ABSOLUTE RADIO LIMITED

ABSOLUTE RADIO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàABSOLUTE RADIO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02674136
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ABSOLUTE RADIO LIMITED?

    • Radiodiffusione (60100) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova ABSOLUTE RADIO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Media House Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ABSOLUTE RADIO LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TIML RADIO LIMITED12 set 200812 set 2008
    VIRGIN RADIO LIMITED18 dic 199218 dic 1992
    INDEPENDENT MUSIC RADIO LIMITED 31 gen 199231 gen 1992
    ROCK 1215 LIMITED21 gen 199221 gen 1992
    MARK 2179 LIMITED24 dic 199124 dic 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di ABSOLUTE RADIO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per ABSOLUTE RADIO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2019

    23 pagineAA

    legacy

    38 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 03 dic 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    28 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del segretario cambiati per Bauer Group Secretariat Limited il 25 set 2018

    1 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Sarah Jane Vickery il 25 set 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Keenan il 25 set 2018

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    41 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 13/12/2017
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale al 14 dic 2017

    • Capitale: GBP 5,959,750
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Chi sono gli amministratori di ABSOLUTE RADIO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Segretario
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione00944753
    159023720001
    FORD, Deidre Ann
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    United KingdomBritish109666380002
    KEENAN, Paul Anthony
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    EnglandBritish243390510001
    VICKERY, Sarah Jane
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    EnglandBritish119137220004
    CLARKE, Sara
    Old Stable Cottage
    Old Barn Farm, Uplawmoor
    G78 4AZ Glasgow
    Segretario
    Old Stable Cottage
    Old Barn Farm, Uplawmoor
    G78 4AZ Glasgow
    British77963580002
    DAVIDSON, Dawn
    Langhaugh
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    Segretario
    Langhaugh
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    British51065860001
    FLYNN, Roger Patrick
    4 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    Segretario
    4 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    British66703670003
    LEGGE, Diana Patricia
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    Segretario
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    British66675910001
    ROBINSON, Adrian Mervyn
    6 Glenard Hall
    Goatstown Road
    IRISH Clonskeagh
    Dublin 14
    Ireland
    Segretario
    6 Glenard Hall
    Goatstown Road
    IRISH Clonskeagh
    Dublin 14
    Ireland
    Irish77585790001
    TAMES, Jane Elizabeth Anne
    5 Hatfield Drive
    Kelvinside
    G12 0XZ Glasgow
    Segretario
    5 Hatfield Drive
    Kelvinside
    G12 0XZ Glasgow
    British118367070001
    ZAMET, Naomi Rae
    Flat 1 Merlin House Oak Hill Park
    Frognal Hampstead
    NW3 7LJ London
    Segretario
    Flat 1 Merlin House Oak Hill Park
    Frognal Hampstead
    NW3 7LJ London
    British42158970002
    ZIPRIN, Geoffrey Charles
    The Old Carters House
    53 Chenies Village
    WD3 6EQ Bucks
    Segretario nominato
    The Old Carters House
    53 Chenies Village
    WD3 6EQ Bucks
    British900001590001
    AUMONIER, John Martin
    Little Heath Nyetimber Lane
    West Chiltington
    RH20 2ND Pulborough
    West Sussex
    Amministratore
    Little Heath Nyetimber Lane
    West Chiltington
    RH20 2ND Pulborough
    West Sussex
    Other63227690001
    BLACKABY, Oliver Guy
    Cholmeley Crescent
    Highgate
    N6 5EX London
    47
    Amministratore
    Cholmeley Crescent
    Highgate
    N6 5EX London
    47
    United KingdomBritish131001170001
    CAMPBELL, David Lachlan
    GU28
    Amministratore
    GU28
    EnglandBritish58507320001
    DEVEREUX, Robert Harold Ferrers
    5 Ladbroke Terrace
    W11 3PG London
    Amministratore
    5 Ladbroke Terrace
    W11 3PG London
    EnglandBritish68747470001
    DHARIWAL, Ravindra
    Oopp Nv Farms, Khasra No 1523
    Sub Po S P School
    110030 Bhatti Mines
    Ashray Farms
    Asola Village New Delhi
    India
    Amministratore
    Oopp Nv Farms, Khasra No 1523
    Sub Po S P School
    110030 Bhatti Mines
    Ashray Farms
    Asola Village New Delhi
    India
    IndiaIndian137478960001
    EMSLIE, Donald Gordon
    32 Drumsheugh Gardens
    EH3 7RN Edinburgh
    Amministratore
    32 Drumsheugh Gardens
    EH3 7RN Edinburgh
    ScotlandBritish61177720002
    FLANAGAN, Andrew Henry
    7 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    7 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish42787120004
    FLYNN, Roger Patrick
    4 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    Amministratore
    4 Doneraile Street
    Fulham
    SW6 6EN London
    EnglandBritish66703670003
    GYNGELL, Bruce
    57 Oakley Street
    SW3 5HB London
    Amministratore
    57 Oakley Street
    SW3 5HB London
    Australian25950350001
    HAZLITT, Frances
    73 Finlay Street
    SW6 6HF London
    Amministratore
    73 Finlay Street
    SW6 6HF London
    British110554850001
    HUGHES, Gary William
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    Amministratore
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    UkBritish72256160002
    HUNTINGFORD, Richard Norman Legh
    11 Baronsmead Road
    Barnes
    SW13 9RR London
    Amministratore
    11 Baronsmead Road
    Barnes
    SW13 9RR London
    United KingdomBritish3297910006
    IBBETT, Kenneth Richard Andre
    31 Aldridge Road Villas
    W11 1BN London
    Amministratore
    31 Aldridge Road Villas
    W11 1BN London
    United KingdomBritish34929900001
    JACKSON, Paul
    Geeta
    London Road
    SL5 9RY Sunningdale
    Berkshire
    Amministratore
    Geeta
    London Road
    SL5 9RY Sunningdale
    Berkshire
    British117927650001
    LEVISON, Charles John Cuthbertson
    40 Kensington Park Gardens
    W11 2QT London
    Amministratore
    40 Kensington Park Gardens
    W11 2QT London
    British76794220002
    MANFREY, Barbara Louise
    55 Palace Gardens Terrace
    W8 4RU London
    Amministratore
    55 Palace Gardens Terrace
    W8 4RU London
    American34084460002
    MOLLETT, Andrew
    4 White Heron Mews
    Park Lane
    TW11 0JQ Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    4 White Heron Mews
    Park Lane
    TW11 0JQ Teddington
    Middlesex
    British47101600001
    PARIGI, Amba Preetham
    10th Floor, Flat 102, A Wing
    66 Napean Sea Road
    400 036 Mumbai
    Petit Hall Tahnee Heights Chsl
    Mumbai
    India
    Amministratore
    10th Floor, Flat 102, A Wing
    66 Napean Sea Road
    400 036 Mumbai
    Petit Hall Tahnee Heights Chsl
    Mumbai
    India
    IndiaIndian134398470002
    PEARSON, Anthony John
    Scamells Corner Red Lane
    Blackbrook
    RH5 4DU Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Scamells Corner Red Lane
    Blackbrook
    RH5 4DU Dorking
    Surrey
    UkBritish44001900002
    PEARSON, Anthony John
    Scamells Corner Red Lane
    Blackbrook
    RH5 4DU Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Scamells Corner Red Lane
    Blackbrook
    RH5 4DU Dorking
    Surrey
    UkBritish44001900002
    PHIPPEN, Peter Sangster
    Templewood Lane
    Stoke Poges
    SL2 4BG Slough
    "Oak Acre"
    England
    Amministratore
    Templewood Lane
    Stoke Poges
    SL2 4BG Slough
    "Oak Acre"
    England
    EnglandBritish32688550001
    POTTER, Irene
    55 Peel Place
    Clayhall Avenue
    IG5 0PT Ilford
    Essex
    Amministratore delegato nominato
    55 Peel Place
    Clayhall Avenue
    IG5 0PT Ilford
    Essex
    British900001600001
    SHAH, Sanjeev
    Next To Maulya Centre, Senapati Bapat Marg,
    Lower Parel
    400 013 Mumbai
    A/203 2nd Floor Casea Grande Tower
    India
    Amministratore
    Next To Maulya Centre, Senapati Bapat Marg,
    Lower Parel
    400 013 Mumbai
    A/203 2nd Floor Casea Grande Tower
    India
    IndiaIndian148788520001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ABSOLUTE RADIO LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bauer Ar Holdings Limited
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    06 apr 2016
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneComapnies House
    Numero di registrazione03359692
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ABSOLUTE RADIO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Corporate loan agreement
    Creato il 14 dic 2009
    Consegnato il 23 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The assets, both moveable and immoveable see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Timl Global Limited
    Transazioni
    • 23 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental security agreement
    Creato il 16 feb 2004
    Consegnato il 03 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The trademarks and design rights specified next to its name in schedule 2 of the agreement under the heading specific intellectual property rights; any copyright or other intellectual property monopoly right in any of the above; or any interest (including by way of licence) in any of the above. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 04 apr 2003
    Consegnato il 16 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other of the obligors to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent on Trust for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 16 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 18 lug 2002
    Consegnato il 24 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 24 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Hedging debenture
    Creato il 30 apr 1998
    Consegnato il 18 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each of the obligors (as defined) to banque paribas (as security trustee for itself and the hedge provider) and to the hedge provider under the hedging documents together with all costs,charges and expenses incurred by the hedge provder and/or the security trustee in connection with the protection,preservation or enforcement of it's respective rights under the hedging documents
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Banque Paribas
    Transazioni
    • 18 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 dic 1997
    Consegnato il 24 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the obligors to the secured creditors(or any of them) under each of the senior facility documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Banque Paribas(As Security Trustee)
    Transazioni
    • 24 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 mar 1997
    Consegnato il 27 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys obligations and liabilities now due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the facility documents and/or this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over land (as defined) broadcasting licences all rights of the company uner or in respect of the broadcasting licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Company as Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 27 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 gen 1995
    Consegnato il 13 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An issue of secured debentures in a series
    Creato il 13 dic 1993
    Consegnato il 23 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Transazioni
    • 23 dic 1993Registrazione di un'emissione di obbligazioni garantite in una serie (397a)
    • 09 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A registered charge
    Creato il 31 ago 1993
    Consegnato il 02 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Transazioni
    • 02 set 1993Registrazione di un'emissione di obbligazioni garantite in una serie (397a)
    • 09 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A registered charge
    Creato il 24 ago 1993
    Consegnato il 02 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Transazioni
    • 02 set 1993Registrazione di un'emissione di obbligazioni garantite in una serie (397a)
    • 09 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A registered charge
    Creato il 05 lug 1993
    Consegnato il 23 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • Not Known.
    Transazioni
    • 23 lug 1993Registrazione di un'emissione di obbligazioni garantite in una serie (397a)
    • 09 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A registered charge
    Creato il 28 giu 1993
    Consegnato il 29 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Transazioni
    • 29 giu 1993Registrazione di un'emissione di obbligazioni garantite in una serie (397a)
    • 09 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Issue of secured debentures
    Creato il 21 giu 1993
    Consegnato il 25 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Transazioni
    • 25 giu 1993Registrazione di un'emissione di obbligazioni garantite in una serie (397a)
    • 09 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Series of debentures
    Creato il 21 mag 1993
    Consegnato il 01 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • None
    Transazioni
    • 01 giu 1993Registrazione di un'emissione di obbligazioni garantite in una serie (397a)
    • 09 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Issue
    Creato il 23 apr 1993
    Consegnato il 10 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • None
    Transazioni
    • 10 mag 1993Registrazione di un'emissione di obbligazioni garantite in una serie (397a)
    • 09 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Series of debentures
    Creato il 08 mar 1993
    Consegnato il 12 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • Virgin Communications Limited
    Transazioni
    • 12 mar 1993Registrazione di un'emissione di obbligazioni garantite in una serie (397a)
    • 03 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Series of debentures
    Creato il 08 mar 1993
    Consegnato il 12 mar 1993
    Data dello strumento di garanzia 08 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • Virgin Communications Limited
    Transazioni
    • 12 mar 1993Registrazione di un onere per garantire una serie di obbligazioni (397)
    • 09 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of rent deposit
    Creato il 19 gen 1993
    Consegnato il 27 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Forsecuring £50,000.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Pursuant to clause 2 (f) of the deed of rent deposit referred to virgin radio limited agreed to charge £50,000 to trafalgar house developments limited as security for the performance of its obligation in a lease dated 19/1/93 relating to the 2ND 3RD and 4TH floors 1 golden square london W1 and performance of its obligation in the rent deposit deed of the aforesaid date.
    Persone aventi diritto
    • Trafalgar House Developments Limited
    Transazioni
    • 27 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0