TELESHOP SERVICES LIMITED

TELESHOP SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTELESHOP SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02677693
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TELESHOP SERVICES LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacchi (46390) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova TELESHOP SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Equity House
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Northamptonshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TELESHOP SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FINISHGOOD LIMITED15 gen 199215 gen 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di TELESHOP SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al27 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TELESHOP SERVICES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TELESHOP SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    21 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 15 dic 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account cancelled. Sum of £450,056 be credited to the p/l 07/12/2015
    RES13

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 1

    5 pagineMR05

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Cessazione della carica di Christopher Nicholas Martin come amministratore in data 14 set 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Timothy Kenny come amministratore in data 14 set 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Thomas Codd come amministratore in data 14 set 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Thomas Codd come segretario in data 14 set 2015

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Jonathan Paul Prentis come amministratore in data 14 set 2015

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Musgrave House Widewater Place Moorhall Road Harefield Middlesex UB9 6NS a Equity House Irthlingborough Road Wellingborough Northamptonshire NN8 1LT in data 29 set 2015

    1 pagineAD01

    Dimissioni di un revisore

    3 pagineAA03

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Bilancio redatto al 27 dic 2014

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 gen 2015

    Stato del capitale al 15 gen 2015

    • Capitale: GBP 447,187
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di Donal Horgan come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 gen 2014

    Stato del capitale al 16 gen 2014

    • Capitale: GBP 447,187
    SH01

    Chi sono gli amministratori di TELESHOP SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRENTIS, Jonathan Paul
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritish177693990001
    CLAYTON, Ian David Keith
    11 The Court
    Marine Gate Promenade
    PR9 0EG Southport
    Segretario
    11 The Court
    Marine Gate Promenade
    PR9 0EG Southport
    British18285200002
    CODD, David Thomas, Mr.
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Segretario
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    182404910001
    DUNLEA, Aidan Finbar
    39 Redwood Place
    HP9 1RP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    39 Redwood Place
    HP9 1RP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Irish108011300001
    HARE, Richard Warren
    Sunnyside Main Street
    Gawcott
    MK18 4HZ Buckingham
    Buckinghamshire
    Segretario
    Sunnyside Main Street
    Gawcott
    MK18 4HZ Buckingham
    Buckinghamshire
    British2955620006
    MORGAN, David George
    7 Firs Gate
    HG2 9HE Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    7 Firs Gate
    HG2 9HE Harrogate
    North Yorkshire
    British16133400001
    O'FLYNN, David
    Ballyphilip
    IRISH Glanmire
    Co. Cork
    Ireland
    Segretario
    Ballyphilip
    IRISH Glanmire
    Co. Cork
    Ireland
    Irish123363960001
    TREBBLE, Christopher John
    36 Stembridge Way
    Norton Fitzwarren
    TA2 6SX Taunton
    Somerset
    Segretario
    36 Stembridge Way
    Norton Fitzwarren
    TA2 6SX Taunton
    Somerset
    British51754910001
    WIRTH, Julie Ann
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    Segretario
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    British114305580001
    BARNETT, Louise Annabel
    Anscott House
    17 Nottingham Road
    LE65 1DJ Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Amministratore
    Anscott House
    17 Nottingham Road
    LE65 1DJ Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    British54609000001
    BARNETT, Louise Annabel
    Anscott House
    17 Nottingham Road
    LE65 1DJ Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Amministratore
    Anscott House
    17 Nottingham Road
    LE65 1DJ Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    British54609000001
    CODD, David Thomas, Mr.
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    IrelandIrish182392430001
    DAVIES, Colin Ernest
    The Granary
    Escrick Road
    YO19 6BQ York
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Granary
    Escrick Road
    YO19 6BQ York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish78759470002
    DUNLEA, Aidan Finbar
    39 Redwood Place
    HP9 1RP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    39 Redwood Place
    HP9 1RP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Irish108011300001
    ELLIS, Peter Brian
    11 Hanover Close St Botolphs View
    Barton Seagrave
    NN15 6GH Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    11 Hanover Close St Botolphs View
    Barton Seagrave
    NN15 6GH Kettering
    Northamptonshire
    British45029930001
    HORGAN, Donal Patrick
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    Amministratore
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    IrelandIrish163398920001
    HYSON, Martin John
    Poplar Lane
    RG10 0DJ Hurst Reading
    White Rose Cottage
    Berkshire
    Amministratore
    Poplar Lane
    RG10 0DJ Hurst Reading
    White Rose Cottage
    Berkshire
    United KingdomBritish128460840001
    KENNY, Timothy, Mr.
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    IrelandIrish113651250001
    MARTIN, Christopher Nicholas
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Irthlingborough Road
    NN8 1LT Wellingborough
    Equity House
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritish48484090003
    MORGAN, David George
    7 Firs Gate
    HG2 9HE Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    7 Firs Gate
    HG2 9HE Harrogate
    North Yorkshire
    British16133400001
    O'FLYNN, David, Mr.
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    Amministratore
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    IrelandIrish163739400001
    O'FLYNN, David
    Ballyphilip
    IRISH Glanmire
    Co. Cork
    Ireland
    Amministratore
    Ballyphilip
    IRISH Glanmire
    Co. Cork
    Ireland
    Irish123363960001
    OLD, Douglas Henry
    Clevedale
    Green Lane, Collingham
    LS22 5DE Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Clevedale
    Green Lane, Collingham
    LS22 5DE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish78026400001
    PYE, James Francis
    11 Neville Crescent
    MK43 8JE Bromham
    Bedfordshire
    Amministratore
    11 Neville Crescent
    MK43 8JE Bromham
    Bedfordshire
    British99123350001
    PYPER, Simon John
    160 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1NG London
    Amministratore
    160 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1NG London
    British108173190001
    RIGBY, Graham Lakin
    Magnolia Cottage 4 Fulmer Place Farm
    SL3 6HP Fulmer
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Magnolia Cottage 4 Fulmer Place Farm
    SL3 6HP Fulmer
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish74211400002
    SMITH, Philip Anthony
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    Amministratore
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    EnglandBritish233299960001
    TAYLOR, Michael John
    The Old Parsonage
    Nether Winchendon
    HP18 0EA Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Old Parsonage
    Nether Winchendon
    HP18 0EA Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish122666080001
    TREBBLE, Christopher John
    36 Stembridge Way
    Norton Fitzwarren
    TA2 6SX Taunton
    Somerset
    Amministratore
    36 Stembridge Way
    Norton Fitzwarren
    TA2 6SX Taunton
    Somerset
    British51754910001
    WIRTH, Julie Ann
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    Amministratore
    Musgrave House Widewater Place
    Moorhall Road
    UB9 6NS Harefield
    Middlesex
    EnglandBritish114305580002

    TELESHOP SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 25 gen 1998
    Consegnato il 02 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all book and other debts both present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance in relation to such book and other debts; by way of first floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company whatsoever and wheresoever both present and future including the assets comprised in the fixed charges to the extent that such fixed assets shall for any reason be ineffective.
    Persone aventi diritto
    • Euro Sales Finance PLC
    Transazioni
    • 02 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 02 ago 1994
    Consegnato il 05 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 31 mar 1993
    Consegnato il 09 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 31ST march 1993
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lancashire Enterprises Venture Fund
    Transazioni
    • 09 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 31 mar 1993
    Consegnato il 06 apr 1993
    In corso
    Importo garantito
    The performance of the tenant's obligations under the lease of even date and this deed to the chargee
    Brevi particolari
    £15,000.00 placed in a separate account with the landlord'sbankers.
    Persone aventi diritto
    • Commission for the New Towns
    Transazioni
    • 06 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2015Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0