MARR TAVERNS LIMITED

MARR TAVERNS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMARR TAVERNS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02677899
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MARR TAVERNS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MARR TAVERNS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Elsley Court
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MARR TAVERNS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OVAL (775) LIMITED15 gen 199215 gen 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di MARR TAVERNS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per MARR TAVERNS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2019

    16 pagineAA

    legacy

    86 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    2 pagineAGREEMENT2

    Cessazione della carica di David Forde come amministratore in data 31 lug 2020

    1 pagineTM01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mar 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 17 gen 2020

    • Capitale: GBP 2.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    2 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    legacy

    79 paginePARENT_ACC

    Nomina di Mr Sean Michael Paterson come amministratore in data 24 apr 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David James Tannahill come amministratore in data 24 apr 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 24 ago 2018 al 31 dic 2018

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 19 ago 2017

    3 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Marr Holdings Limited come persona con controllo significativo il 04 set 2017

    2 paginePSC05

    Chi sono gli amministratori di MARR TAVERNS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MOORE, Christopher John
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish136853310001
    MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish112375050001
    PATERSON, Sean Michael
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    Amministratore
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    ScotlandBritish257892140001
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191628080001
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    BROWN, Robert Adam Southall
    24 Alders Brook
    Hilton
    DE65 5HF Derby
    Derbyshire
    Segretario
    24 Alders Brook
    Hilton
    DE65 5HF Derby
    Derbyshire
    British67809020001
    DALEY, Frances Margaret Catherine
    1 Frank Dixon Way
    SE21 7BB London
    Segretario
    1 Frank Dixon Way
    SE21 7BB London
    United Kingdom45177440002
    HARRINGTON, Columb
    4 Drovers Way
    Newton Longville
    MK17 0HR Buckinghamshire
    Segretario
    4 Drovers Way
    Newton Longville
    MK17 0HR Buckinghamshire
    Irish51845740002
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175488540001
    JONES, Ian Andrew
    6 Pages Croft
    HP4 1BX Berkhamsted
    Hertfordshire
    Segretario
    6 Pages Croft
    HP4 1BX Berkhamsted
    Hertfordshire
    British54298280003
    KIRK, Ronald Leslie James
    16 Greet Park Close
    NG25 0EE Southwell
    Nottinghamshire
    Segretario
    16 Greet Park Close
    NG25 0EE Southwell
    Nottinghamshire
    British71984630001
    LAZARUS, David Michael
    58 Woodside Park Road
    N12 8RS London
    Segretario
    58 Woodside Park Road
    N12 8RS London
    British62981490001
    MOORE, Alan
    47 Bolton Gardens
    TW11 9AX Teddington
    Middlesex
    Segretario
    47 Bolton Gardens
    TW11 9AX Teddington
    Middlesex
    British8254860001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    British117216940001
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161686170001
    WHITAKER, Jack Mcdonald
    16 Broadmead Road
    IG8 0AY Woodford Green
    Essex
    Segretario
    16 Broadmead Road
    IG8 0AY Woodford Green
    Essex
    British31871780001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    BUNTING, Martin Brian
    The Long House
    41 High Street, Odiham
    RG29 1LF Hook
    Hampshire
    Amministratore
    The Long House
    41 High Street, Odiham
    RG29 1LF Hook
    Hampshire
    EnglandBritish64749460001
    DALEY, Frances Margaret Catherine
    17 Pickwick Road
    Dulwich
    SE21 7JN London
    Amministratore
    17 Pickwick Road
    Dulwich
    SE21 7JN London
    British45177440001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    FORDE, David
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomIrish180590780001
    FREEDMAN, Cyril Winston
    Golden Mead
    Mead Road
    BR7 6AD Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    Golden Mead
    Mead Road
    BR7 6AD Chislehurst
    Kent
    British1631420001
    JACKSON, Alan Michael
    Woodrow Farm
    Wigginton
    HP23 6HT Tring
    Hertfordshire
    Amministratore
    Woodrow Farm
    Wigginton
    HP23 6HT Tring
    Hertfordshire
    EnglandBritish46903690001
    KEMP, Deborah Jane
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    Amministratore
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    United KingdomBritish79388130005
    KIRK, Ronald Leslie James
    16 Greet Park Close
    NG25 0EE Southwell
    Nottinghamshire
    Amministratore
    16 Greet Park Close
    NG25 0EE Southwell
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish71984630001
    LAMBERT, Stephen David
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    British43572470001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    MOORE, Alan
    47 Bolton Gardens
    TW11 9AX Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    47 Bolton Gardens
    TW11 9AX Teddington
    Middlesex
    British8254860001
    NEAME, Robert Harry Beale
    Dane Court Farmhouse
    Kits Hill Selling
    ME13 9QP Faversham
    Kent
    Amministratore
    Dane Court Farmhouse
    Kits Hill Selling
    ME13 9QP Faversham
    Kent
    United KingdomBritish1511740001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002
    SHERLING, Clive Richard
    Lincoln House, Woodside Hill
    Chalfont St Peter
    SL9 9TF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Lincoln House, Woodside Hill
    Chalfont St Peter
    SL9 9TF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish20007920003
    TANNAHILL, David James
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    ScotlandBritish237381690001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MARR TAVERNS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    29 ago 2017
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    No
    Forma giuridicaCorporate
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleUnited Kingdom (Scotland)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc065527
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    06 apr 2016
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2506120
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MARR TAVERNS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 14 set 1999
    Consegnato il 05 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors each of them to the secured creditors (or any of them) under the facility documents (or any of them) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited (As Trustee for the Secured Creditors)
    Transazioni
    • 05 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 04 mar 1996
    Consegnato il 21 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 04 mar 1996
    Consegnato il 11 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a adam & eve 47 swan road rotherhithe london t/no 134241. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 12 gen 1996
    Consegnato il 26 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other liable party (all as defined) to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined) and to the finance parties or any of them under each of the liability documents (as defined) to which such liable party is a party
    Brevi particolari
    Golden lion public house 2 britannia street london WC1 t/n 221904,the victoria public house 2 mornington terrace camden NW1 t/n 340217,the marquis of granby public house west sompting lancing west sussex and the vauxhall public house 159 sturry road canterbury kent with all buildings and fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co. Limited
    Transazioni
    • 26 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 31 lug 1995
    Consegnato il 02 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each liable party (as defined) to the chargee under the liability documents (as defined)
    Brevi particolari
    Reardons wine bar, bankside house 107/112 leadenhall street london EC3. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited as Agent and Trustee for the Finance Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 02 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed of sub-charge
    Creato il 18 mag 1995
    Consegnato il 24 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations due or to become due from the company and/or each liable party pursuant to the terms of the liability documents and/or this charge
    Brevi particolari
    First legal mortgage all the company's interest in the usher debenture the principal money and all interest due. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co as Agent and Trustee for the Finance Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 24 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 20 set 1994
    Consegnato il 07 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for the finance parties (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The george & dragon public house cavendish street ramsgate kent title no K408946,the jolly caulkers public house batchelor street chatham kent title NO341831 tog with all buildings and fixtures the proceeds of sale and the benefit of any covenants.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 07 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture (seventh)
    Creato il 21 mag 1993
    Consegnato il 26 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations of each liable party (as defined) to samuel montagu & co (as agent and trustee for the finance parties) and to the finance parties (as defined) or any of them under each of the liablility documents (also as defined)to which such liable party is a party see charge particulars form for details
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited (As Agent and Trustee)
    Transazioni
    • 26 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 02 apr 1993
    Consegnato il 08 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for the finance parties (as defined) on any account whatsoever under each of the liability documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 08 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 02 feb 1993
    Consegnato il 05 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations of each liable partie (as defined) to samuel montagu & co. (As agent and trustee for the finance parties) and to the finance parties (as defined) or any of them under each of the lability documents (also as defined) to which such liable party is a party
    Brevi particolari
    Property k/a merlin king arthurs way andover weymouth title no: HP443117. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co
    Transazioni
    • 05 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 04 dic 1992
    Consegnato il 10 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined) under the terms of each of the liability documents (as defined)
    Brevi particolari
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited as Agent and Trustee for the Finance Parties(As Defined)
    Transazioni
    • 10 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 21 ott 1992
    Consegnato il 23 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee the deed
    Brevi particolari
    A separate designated interest earning account at a clearing bank. £19,260 tog: all sums paid into the said account.
    Persone aventi diritto
    • Tower Bridge Business Centre Limited
    Transazioni
    • 23 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 14 ott 1992
    Consegnato il 16 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from marr taverns limited (formerly oval (775) limited) supplemental to a guarantee and debenture dated 23/03/92 to the chargee under each of the finance documents (as defined in the debenture) to which the company is a party
    Brevi particolari
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Which the Company is a Party
    • Samuel Montagu & Co. Limited as Agent and Trustee for Itself and Forthe Finance Parties (As Defined) and the Finance Parties (or Any of Them) Under Each of the Finance Documents (as Defined in the Debenture) To
    Transazioni
    • 16 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 04 set 1992
    Consegnato il 09 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other member of the group to samuel montagu & co limited as security agent and trustee for the finance parties (as defined)under the terms of the liability documents (as defined)
    Brevi particolari
    Property k/a the british pilot station road allhallows kent ME3 9QW title no: P121192 (please see form 395 for full details ). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 09 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 10 ago 1992
    Consegnato il 19 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations of the company and any subsidiaries of the company (the liable parties) to the chargee or any of them under each of theliability documents (as defined) to which such liable party is a party
    Brevi particolari
    F/H and l/h properties specified in the schedule together with buildings and fixtures the proceeds of sale thereof see doc for details.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited(The "Security Agent") and the Finance Parties(as Defined)
    Transazioni
    • 19 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 23 mar 1992
    Consegnato il 25 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent & trustee for the finance parties (as defined in the charge) on any account whatsoever under the terms of the liability documents (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    (For full details refer to doc M395 ref M77). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co. Limited as Agent and Trustee for the Financeparties (As Defined in the Charge)
    Transazioni
    • 25 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0