TURNSTONE INVESTMENTS LIMITED

TURNSTONE INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTURNSTONE INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02677906
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TURNSTONE INVESTMENTS LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova TURNSTONE INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Warehouse
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TURNSTONE INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MISLEX (30) LIMITED15 gen 199215 gen 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di TURNSTONE INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per TURNSTONE INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 026779060016 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 026779060014 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 026779060015 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 026779060017 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015

    4 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 026779060017, creata il 02 set 2016

    22 pagineMR01

    Bilancio annuale redatto al 15 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 gen 2016

    Stato del capitale al 25 gen 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 026779060016, creata il 27 ott 2015

    21 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 026779060014, creata il 27 ott 2015

    21 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 026779060015, creata il 27 ott 2015

    60 pagineMR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TURNSTONE INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GOLDSMITH, Christopher William
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    United Kingdom
    Segretario
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    United Kingdom
    British13230340005
    DEACON, Timothy John
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    United Kingdom
    Amministratore
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    United Kingdom
    United KingdomBritish102496140001
    GOLDSMITH, Christopher William
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    United Kingdom
    Amministratore
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    United Kingdom
    United KingdomBritish13230340005
    GREGORY, Yvette Marie
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    Amministratore
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    EnglandBritish197416740001
    WESTLEX REGISTRARS LIMITED
    21 Southampton Row
    WC1B 5HS London
    Segretario nominato
    21 Southampton Row
    WC1B 5HS London
    900005880001
    BARNES, Sara Anne
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    United Kingdom
    Amministratore
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    United Kingdom
    United KingdomBritish98921440001
    CARTER, Andrew Stewart
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    Amministratore
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    United KingdomBritish145669000001
    CARTER, Andrew Stewart
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    Amministratore
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    United KingdomBritish145669000001
    HOLMES, Colin Robert
    Chantry Mid Meadow
    Hungate Lane
    NR34 9TP Beccles
    Suffolk
    Amministratore
    Chantry Mid Meadow
    Hungate Lane
    NR34 9TP Beccles
    Suffolk
    United KingdomBritish8041680001
    HUGHSON, David Callum
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    Amministratore
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    British62284790002
    MARTIN, Julia Helen
    79 Streathbourne Road
    SW17 8RA London
    Amministratore
    79 Streathbourne Road
    SW17 8RA London
    British84688790001
    MARTIN, Julia Helen
    79 Streathbourne Road
    SW17 8RA London
    Amministratore
    79 Streathbourne Road
    SW17 8RA London
    British84688790001
    MOULDER, Stuart Christopher
    Uvongo House Blackmore Road
    Blackmore
    CM4 0QX Ingatestone
    Essex
    Amministratore
    Uvongo House Blackmore Road
    Blackmore
    CM4 0QX Ingatestone
    Essex
    EnglandBritish46329920001
    PARDOE, Richard Grenville
    Cherry Tree Cottage
    17 West Avenue
    HP10 8AE Penn
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Cherry Tree Cottage
    17 West Avenue
    HP10 8AE Penn
    Buckinghamshire
    EnglandBritish141544990001
    SCOTT, Nicholas Peter
    7 Poplar Close
    Great Gransden
    SG19 3AX Sandy
    Bedfordshire
    Amministratore
    7 Poplar Close
    Great Gransden
    SG19 3AX Sandy
    Bedfordshire
    EnglandBritish108455130001
    TAME, Russell
    Orchard House
    1a Mill Road
    CB21 5LT West Wratting
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Orchard House
    1a Mill Road
    CB21 5LT West Wratting
    Cambridgeshire
    British117422530001
    WESTLEX REGISTRARS LIMITED
    21 Southampton Row
    WC1B 5HS London
    Amministratore delegato nominato
    21 Southampton Row
    WC1B 5HS London
    900005880001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TURNSTONE INVESTMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Turnstone Estates Ltd
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    England
    15 gen 2017
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    TURNSTONE INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 02 set 2016
    Consegnato il 09 set 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    By way of legal mortgage the property on the south west side of parkway chelmsford essex and registered at the land registry under title number EX641103.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Winchester Estates Limited (A Company Registered in Gibraltar with Company Number 90002)
    Transazioni
    • 09 set 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 27 ott 2015
    Consegnato il 02 nov 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The freehold property on the south west side of parkway chelmsford essex and registered at the land registry under title number EX641103.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Euro Dinero S.À R.L.
    Transazioni
    • 02 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 27 ott 2015
    Consegnato il 28 ott 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Any present or future freehold or leasehold property in which the company has an interest and includes all buildings and fixtures on that property, the proceeds of sale of any part of that property, any licence, agreement for sale or agreement for lease in relation to that property, the benefit of any covenants for title given or entered into by any predecessor in title of the company in respect of that property and any monies paid or payable in respect of those covenants.. All patents, trademarks, service marks, designs, business names, copyrights, design rights, moral rights, inventions, confidential information, know how and other intellectual property rights and any interests including by way of licence in any of the foregoing in each case whether registered or not and the benefit of all applications for and rights to use any such assets.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Euro Dinero S.À R.L.
    Transazioni
    • 28 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 27 ott 2015
    Consegnato il 28 ott 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The freehold property on the south west side of parkway chelmsford essex and registered at the land registry under title number EX641103.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Euro Dinero S.À R.L.
    Transazioni
    • 28 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 06 dic 2007
    Consegnato il 08 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land k/a army & navy parkway chelmsford essex t/no EX641103, 128 parkway chelmsford essex t/no EX342427, 130 parkway chelmsofrd essex EX433394 (for further details of properties charged please refer to form 395) all rights to and interest in any insurances in respect of the property the gross rents licence fees and other monies receivable in respect of the property (the rental income) all interest and rights under any contracts or agreements or claims for or in respect of the sale purchase leasing mortgaging management carrying out of works to development or redevelopment of or other dealing with or ownership of the property or any part thereof the goodwill of any business and floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time at the property.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 06 dic 2007
    Consegnato il 08 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of a first floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over agreement for lease
    Creato il 06 dic 2007
    Consegnato il 08 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any person who is a party to any related security document to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its present and future rights title and interest in and to the agreement for lease; sums which shall from time to time become payable to the company from the operator. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over agreement for lease
    Creato il 06 dic 2007
    Consegnato il 08 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any person who is a party to any related security document to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its present and future rights title and interest in and to the agreement for lease; sums which shall from time to time become payable to the company from the operator. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge
    Creato il 28 gen 2000
    Consegnato il 02 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a 103 mill road cambridge fixtures and fittings thereon all monies to the credit of any account all rental and other monies and the proceeds of any insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 02 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 mar 1999
    Consegnato il 01 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H kwik-save supermarket 1-3 upper green east micham-SGL109533. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 01 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 dic 1997
    Consegnato il 13 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h land and buildings k/a 3 high street brentwood essex t/n EX347522, 4 culver street west colchester essex t/n EX439617 and 23 strait bargate boston lincolnshire t/n LL142866 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 13 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 21 ott 1997
    Consegnato il 21 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter and this charge as defined therein
    Brevi particolari
    23 strait bargate, boston, lincolnshire title number LL142866 and the proceeds of sale, benefit of all rights and claims. Floating charge over all movable plant, machinery, implements, building materials of all kinds, utensils, furniture and equipment, undertaking and all other property assets and rights.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • N M Rothschild & Sons Limitedincluding Where the Context Admits Its Successors, Transferees and Assigns
    Transazioni
    • 21 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Conveyance
    Creato il 05 mag 1995
    Consegnato il 10 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the conveyance
    Brevi particolari
    Land situate to the north west of springfield road chelmsford essex.
    Persone aventi diritto
    • Secretary of State for Transport
    Transazioni
    • 10 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge
    Creato il 30 mar 1995
    Consegnato il 31 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility letter,the charge or this charge supplemental to the charge dated 2 november 1993
    Brevi particolari
    Fixed equitable charge the benefit of all rights and claims to which the mortgagor is entitled under the documents listed in the schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 31 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 13 lug 1994
    Consegnato il 18 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any transferee (as defined in clause 17.1 of the deed) under the terms of the facility letter (as defined) and all other monies due on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land situated on the north west side of springfield road, chelmsford, essex and by way of specific charge all the income and rights relating thereto floating charge over all movable plant, materials, machinery, implements, utensils, furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 18 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 20 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 02 nov 1993
    Consegnato il 10 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 3 new street boston t/n/ LL61670, and various other properties as listed on schedule to form 395 all rights, and/or the proceeds of sale thereof the details in col.5 Have this day been amended.please see doc.M91C.J.M.evans 1/12/93. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 10 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 16 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 05 mag 1992
    Consegnato il 12 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 24TH march 1992 and/or this charge and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See 395 for full details of property charged). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 12 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0