GAINSBOROUGH BATHS LTD

GAINSBOROUGH BATHS LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGAINSBOROUGH BATHS LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02679818
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GAINSBOROUGH BATHS LTD?

    • Attività di benessere fisico (96040) / Altre attività di servizi

    Dove si trova GAINSBOROUGH BATHS LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GAINSBOROUGH BATHS LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GAINSBOROUGH BATHROOMS LIMITED22 gen 199222 gen 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di GAINSBOROUGH BATHS LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per GAINSBOROUGH BATHS LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 22 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 gen 2012

    Stato del capitale al 23 gen 2012

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 20/10/2011
    RES13

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    5 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 22 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    19 pagineAA

    legacy

    9 pagineMG01

    legacy

    7 pagineMG01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Documents 25/03/2011
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    21 pagineAA

    Nomina di Mr Malcolm Patrick Farmiloe come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Richard Price come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christopher Wassall come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Dennis Goodes come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 22 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher James Wassall il 02 feb 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Dennis Goodes il 02 feb 2010

    2 pagineCH01

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    19 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di GAINSBOROUGH BATHS LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FARMILOE, Gordon Trevarthen
    Perry Mill Farm
    Perry Mill Lane
    B98 6RR Bradley Green Redditch
    Segretario
    Perry Mill Farm
    Perry Mill Lane
    B98 6RR Bradley Green Redditch
    BritishAccountant48633500003
    FARMILOE, Gordon Trevarthen
    Perry Mill Farm
    Perry Mill Lane
    B98 6RR Bradley Green Redditch
    Amministratore
    Perry Mill Farm
    Perry Mill Lane
    B98 6RR Bradley Green Redditch
    EnglandBritishAccountant48633500003
    FARMILOE, Malcolm Patrick
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector5663680009
    PRICE, Richard Duncan
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    Premier House
    Hewell Road Enfield
    B97 6BW Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector111545180001
    ROUTLEDGE, David George
    11 Thyme Grove
    Meir Park
    ST3 7YF Stoke On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    11 Thyme Grove
    Meir Park
    ST3 7YF Stoke On Trent
    Staffordshire
    British19742100001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    FARMILOE, Malcolm Patrick
    31 Reynard Close
    Webheath
    B97 6PY Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    31 Reynard Close
    Webheath
    B97 6PY Redditch
    Worcestershire
    BritishMarketing5663680007
    FARMILOE, Philip Geoffrey
    Manor Cottage
    Abbots Morton
    WR7 4NA Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Manor Cottage
    Abbots Morton
    WR7 4NA Worcester
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector23681750002
    GOODES, Dennis
    7 Smythsons Close
    School Aycliffe
    DL5 6TB Newton Aycliffe
    County Durham
    Amministratore
    7 Smythsons Close
    School Aycliffe
    DL5 6TB Newton Aycliffe
    County Durham
    EnglandBritishDirector126617830001
    HARRIS, David
    Aggborough Crescent
    DY10 1LQ Kidderminster
    63
    Worcestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Aggborough Crescent
    DY10 1LQ Kidderminster
    63
    Worcestershire
    United Kingdom
    BritishAccountant129590130001
    ONIONS, Colin Thomas
    66 Clarence Road
    Four Oaks
    B74 4AR Sutton Coldfield
    Birmingham
    Amministratore
    66 Clarence Road
    Four Oaks
    B74 4AR Sutton Coldfield
    Birmingham
    BritishCompany Director75870280001
    ROUTLEDGE, David George
    11 Thyme Grove
    Meir Park
    ST3 7YF Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    11 Thyme Grove
    Meir Park
    ST3 7YF Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector Proposed19742100001
    WASSALL, Christopher James
    55 Ridge Road
    DY6 9RE Kingswinford
    West Midlands
    Amministratore
    55 Ridge Road
    DY6 9RE Kingswinford
    West Midlands
    EnglandBritishDirector38444440001
    WOODLEY, Frederick Paul
    Owen House Newhall Lodge
    Newhall Drive
    B76 1QX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    Owen House Newhall Lodge
    Newhall Drive
    B76 1QX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Great BritainBritishCompany Director102853770001

    GAINSBOROUGH BATHS LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Omnibus letter of set-off
    Creato il 24 ott 2011
    Consegnato il 28 ott 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Mortgage
    Creato il 01 apr 2011
    Consegnato il 18 apr 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property at unit 16 vigo place hayward industrial estate aldridge t/no WM884026,l/h property at gainsborough house brickyard road aldridge and l/h property at unit 16 vigo place hayward industrial estate aldridge west midlands see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Trustee
    Transazioni
    • 18 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 01 apr 2011
    Consegnato il 18 apr 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether for its own account or as trustee for the secured parties or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Trustee
    Transazioni
    • 18 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee & debenture
    Creato il 20 mar 2007
    Consegnato il 04 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Philip Farmiloe
    Transazioni
    • 04 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 20 mar 2007
    Consegnato il 04 apr 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 08 mar 2006
    Consegnato il 22 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 18 feb 1997
    Consegnato il 28 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company and/or buildrandom limited to the chargee on any acount whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the south west of brickyard road aldridge west midlands t/no wm 633539.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 mar 1992
    Consegnato il 17 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £19,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Gordon Trevarthen Farmiloe
    Transazioni
    • 17 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0