ALDEN HENDI LIMITED

ALDEN HENDI LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàALDEN HENDI LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02681207
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ALDEN HENDI LIMITED?

    • (2222) /

    Dove si trova ALDEN HENDI LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o KPMG LLP
    St Nicholas House
    Park Row
    NG1 6FQ Nottingham
    Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ALDEN HENDI LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HENDI SYSTEMS LIMITED07 giu 200407 giu 2004
    DIRECT IMAGE SYSTEMS & COMMUNICATIONS LIMITED25 feb 199225 feb 1992
    SWITCHEXTRA LIMITED27 gen 199227 gen 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di ALDEN HENDI LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per ALDEN HENDI LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 24 nov 2010

    14 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 01 giu 2010

    15 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    5 pagineLQ01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 01 dic 2009

    15 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    2 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 01 giu 2009

    18 pagine2.24B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    35 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    15 pagine2.16B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    20 pagineAA

    legacy

    1 pagine403a

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed hendi systems LIMITED\certificate issued on 13/06/08
    3 pagineCERTNM

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    18 pagineAA

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    18 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ALDEN HENDI LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FENTON, Peter Michael
    2 Birtrick Drive
    DA13 0LR Meopham
    Kent
    Segretario
    2 Birtrick Drive
    DA13 0LR Meopham
    Kent
    BritishDirector79742830001
    BROWNING, Timothy Thomas
    113 Burnham Green Road
    AL6 0NH Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    113 Burnham Green Road
    AL6 0NH Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritishPrinter52879660001
    FENTON, Peter Michael
    2 Birtrick Drive
    DA13 0LR Meopham
    Kent
    Amministratore
    2 Birtrick Drive
    DA13 0LR Meopham
    Kent
    EnglandBritishDirector79742830001
    GACHOWSKI, Arthur
    2 Wanstead Road
    IG8 7AA Woodford Green
    Essex
    Amministratore
    2 Wanstead Road
    IG8 7AA Woodford Green
    Essex
    PolishCompany Director24382100003
    PULFORD, John Alfred
    Scawswater Mill
    Idless
    TR4 9QR Truro
    Amministratore
    Scawswater Mill
    Idless
    TR4 9QR Truro
    United KingdomBritishManagement Consultant98133800001
    SZLENKIER, John Charles
    107 Grove Park
    Camberwell
    SE5 8LE London
    Amministratore
    107 Grove Park
    Camberwell
    SE5 8LE London
    BritishCompany Director23710090002
    HOOPER, Terence John
    Norfolk House 1 St Anthonys Avenue
    Leverstock Green
    HP3 8HQ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Segretario
    Norfolk House 1 St Anthonys Avenue
    Leverstock Green
    HP3 8HQ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British44320640002
    KENNY, Mark
    30 Sydney Road
    West Ealing
    W13 9EY London
    Segretario
    30 Sydney Road
    West Ealing
    W13 9EY London
    British30736250002
    LIPINSKI, Andrew Alexander, Mr.
    Old Brook House
    Brook End
    MK44 2HR Keysoe
    Bedfordshire
    Segretario
    Old Brook House
    Brook End
    MK44 2HR Keysoe
    Bedfordshire
    British18079820001
    SZLENKIER, John Charles
    22 Grove Park
    Camberwell
    SE5 8LH London
    Segretario
    22 Grove Park
    Camberwell
    SE5 8LH London
    BritishCompany Director23710090001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    DURRANCE, Philip Walter
    34 Hamilton Gardens
    St Johns Wood
    NW8 9PU London
    Amministratore
    34 Hamilton Gardens
    St Johns Wood
    NW8 9PU London
    EnglandBritishSolicitor34720400004
    EVANS, Michael Armytage
    15 Killieser Avenue
    SW2 4NX London
    Amministratore
    15 Killieser Avenue
    SW2 4NX London
    EnglandBritishManagement Consultant2194120001
    HENDY, David Edward
    Denehurst Garden Close
    Givens Grove
    KT22 8LR Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Denehurst Garden Close
    Givens Grove
    KT22 8LR Leatherhead
    Surrey
    BritishDirector23908720002
    HOOPER, Terence John
    1b St Anthonys Avenue
    HP3 8HQ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    1b St Anthonys Avenue
    HP3 8HQ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    BritishFinance Director44320640001
    KENNY, Mark
    30 Sydney Road
    West Ealing
    W13 9EY London
    Amministratore
    30 Sydney Road
    West Ealing
    W13 9EY London
    BritishAccountant30736250002
    LIPINSKI, Andrew Alexander, Mr.
    Old Brook House
    Brook End
    MK44 2HR Keysoe
    Bedfordshire
    Amministratore
    Old Brook House
    Brook End
    MK44 2HR Keysoe
    Bedfordshire
    United KingdomBritishAccountant18079820001
    MCDIARMID, Stephen David
    24 Rosebury Vale
    Ruislip Manor
    HA4 6AQ Ruislip
    Middlesex
    Amministratore
    24 Rosebury Vale
    Ruislip Manor
    HA4 6AQ Ruislip
    Middlesex
    BritishNetwork & Technical Director26385620001
    PAGE, Bruce
    32 Lauderdale Tower
    EC2Y 8BY London
    Amministratore
    32 Lauderdale Tower
    EC2Y 8BY London
    BritishPublisher/Programmer71959220002
    REID, Michael John
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    Amministratore
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    EnglandIrishDirector950490001
    RICHER, David Maurice
    13 Hardings
    Chalgrove
    OX44 7TJ Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    13 Hardings
    Chalgrove
    OX44 7TJ Oxford
    Oxfordshire
    BritishOperations Director18494280001
    WEBBER, Paul Arthur
    The Tan House
    Horns Cross
    TN31 6JG Northiam
    East Sussex
    Amministratore
    The Tan House
    Horns Cross
    TN31 6JG Northiam
    East Sussex
    BritishCompany Director13443640001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ALDEN HENDI LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 06 giu 2008
    Consegnato il 11 giu 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a hendi systems limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 4 de havilland way windrush park witney oxfordshire t/n ON257345 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Derbyshire Building Society
    Transazioni
    • 11 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 216 feb 2010Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
      • Numero di pratica 2
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30 july 1999 and
    Creato il 12 dic 2007
    Consegnato il 14 dic 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 05 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Heidelberg speedmaster eight colour perfecting press - model SM102-8P - serial number 538747. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 05 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    All assets debenture deed
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 05 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 05 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of chattel mortgage
    Creato il 02 mar 2005
    Consegnato il 08 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    1 x 1996 heidelberg speedmaster SM102-4 P3 serial no 538639,1 x 1999 heidelberg speedmaster SM74-5 P3 serial no 624139 and all existing and future guarantees warranties and servicing and maintenance agreements and all insurances.
    Persone aventi diritto
    • Close Asset Finance Limited
    Transazioni
    • 08 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off
    Creato il 10 gen 2005
    Consegnato il 18 gen 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 18 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30 july 1999 and
    Creato il 01 set 2004
    Consegnato il 03 set 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any accounts of the companies or any of them with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 31 ott 2003
    Consegnato il 07 nov 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all the plant and machinery vehicles computers and other equipment of the borrower listed in the schedule attached to form 395 and all spare parts replacements modifications and addition for or to the same and the full benefit of all warranties and maintenance contracts in relation thereto.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 07 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 06 feb 2002
    Consegnato il 09 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of thirty two thousand five hundred pounds plus value added tax thereon at the rate of 17.5% (rent deposit deed).
    Persone aventi diritto
    • Gransim Properties (No. 5) Limited
    Transazioni
    • 09 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 27 gen 2000
    Consegnato il 04 feb 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 31 ott 1996
    Consegnato il 02 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 02 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee and debenture
    Creato il 19 mag 1994
    Consegnato il 24 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or crawfords-di limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 nov 1992
    Consegnato il 24 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Please see doc for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC.
    Transazioni
    • 24 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ALDEN HENDI LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    02 dic 2008Inizio dell'amministrazione
    24 nov 2010Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jane Bronwen Moriarty
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Mark Jeremy Orton
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Praticante
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    2Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Neil Martin Inman
    Scanlans Consultant Surveyors Llp 618 Warwick Road
    Solihull
    B91 1AA Birmingham
    Ricevitore/gestore
    Scanlans Consultant Surveyors Llp 618 Warwick Road
    Solihull
    B91 1AA Birmingham
    Alan Scanlon Murdoch
    618 Warwick Road
    B91 1AA Solihull
    West Midlands
    Ricevitore/gestore
    618 Warwick Road
    B91 1AA Solihull
    West Midlands

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0