PRIMROSE CARE LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPRIMROSE CARE LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02681546
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PRIMROSE CARE LTD?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PRIMROSE CARE LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Cavendish House Lakpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PRIMROSE CARE LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CRABTREE & GOULD LTD27 gen 199227 gen 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di PRIMROSE CARE LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per PRIMROSE CARE LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di John Henry Whitehead come amministratore in data 12 giu 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Carl Michael Brown come amministratore in data 12 giu 2017

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    3 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    21 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di Richard Mark Preece come amministratore in data 16 feb 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 27 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 feb 2016

    Stato del capitale al 07 feb 2016

    • Capitale: GBP 160,455
    SH01

    Nomina di Mr Richard Mark Preece come amministratore in data 22 gen 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Timothy Mark Pethick come amministratore in data 31 dic 2015

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 gen 2016 al 31 dic 2015

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Victoria Haynes come segretario in data 01 dic 2015

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Enbrook Park Sandgate Folkestone Kent CT20 3SE a Cavendish House Lakpur Court Staffordshire Technology Park Stafford ST18 0FX in data 04 dic 2015

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2015

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Timothy Mark Pethick come amministratore in data 09 set 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Darryn Stanley Gibson come amministratore in data 09 set 2015

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Henry Whitehead il 01 mar 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 27 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 feb 2015

    Stato del capitale al 02 feb 2015

    • Capitale: GBP 160,455
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2014

    3 pagineAA

    Nomina di Victoria Haynes come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Taguma Ngondonga come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di PRIMROSE CARE LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROWN, Carl Michael
    Lakpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lakpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    United Kingdom
    EnglandBritish232841280001
    CHRISTODOULOU, Nicholas John
    Flat 3 3 Chatsworth Gardens
    BN20 7JP Eastbourne
    East Sussex
    Segretario
    Flat 3 3 Chatsworth Gardens
    BN20 7JP Eastbourne
    East Sussex
    British62742480002
    COLLISON, David
    44 Lowther Road
    SW13 9NU London
    England
    Segretario
    44 Lowther Road
    SW13 9NU London
    England
    British34835160001
    DAVIES, John
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    158562310001
    HAYNES, Victoria
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    British182412280001
    NGONDONGA, Taguma
    Basing View
    RG21 4EA Basingstoke
    Fanum House
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Basing View
    RG21 4EA Basingstoke
    Fanum House
    Hampshire
    United Kingdom
    171626990001
    ROBERTS THOMAS, Caroline Emma
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    Segretario
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    British76032450005
    SANDERS, Julian Philip
    38 Darrick Wood Road
    BR6 8AW Orpington
    Kent
    Segretario
    38 Darrick Wood Road
    BR6 8AW Orpington
    Kent
    British6658160003
    KCCF LTD
    19 Old Court Place
    Kensington
    London
    Segretario nominato
    19 Old Court Place
    Kensington
    London
    900005270001
    BASHAM, Brian Arthur
    Elsworthy Rise
    NW3 3SH London
    14
    Amministratore
    Elsworthy Rise
    NW3 3SH London
    14
    United KingdomBritish69378240003
    BIDDLESTONE, Keith
    9 Aldenham Road
    WD7 8AU Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    9 Aldenham Road
    WD7 8AU Radlett
    Hertfordshire
    British68242230001
    BOOTY, Stephen Martin
    South Lodge
    Guildford Road
    KT24 5QE Effingham
    Surrey
    Amministratore
    South Lodge
    Guildford Road
    KT24 5QE Effingham
    Surrey
    EnglandBritish147928010001
    CHRISTODOULOU, Nicholas John
    Flat 3 3 Chatsworth Gardens
    BN20 7JP Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    Flat 3 3 Chatsworth Gardens
    BN20 7JP Eastbourne
    East Sussex
    British62742480002
    CHRISTODOULOU, Nicholas John
    Flat 3 3 Chatsworth Gardens
    BN20 7JP Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    Flat 3 3 Chatsworth Gardens
    BN20 7JP Eastbourne
    East Sussex
    British62742480002
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish29367700001
    DIXON, Catherine Helen
    7 Ashwood Terrace
    LS6 2EH Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    7 Ashwood Terrace
    LS6 2EH Leeds
    West Yorkshire
    British100792180001
    DONALD, Alan Charles
    13 Craven Gardens
    Wimbledon
    SW19 8LU London
    Amministratore
    13 Craven Gardens
    Wimbledon
    SW19 8LU London
    British58742090001
    ELLERBY, Mark
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish40582650004
    ELLERBY, Mark
    82 Nelson Road
    N8 9RT London
    Amministratore
    82 Nelson Road
    N8 9RT London
    British40582650002
    ELLIS, Martyn Anthony
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish95749550002
    GIBSON, Darryn Stanley
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomNew Zealander177930490001
    GREENE, Kevin Anthony
    Bethena 25 Alexandra Road
    Ash
    GU12 6PQ Aldershot
    Hampshire
    Amministratore
    Bethena 25 Alexandra Road
    Ash
    GU12 6PQ Aldershot
    Hampshire
    British48212370002
    HOLDEN, Dean Allan
    Spring House
    Spring Hill Fordcombe
    TN3 0SE Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Spring House
    Spring Hill Fordcombe
    TN3 0SE Tunbridge Wells
    Kent
    British32671980002
    HOWARD, Stuart Michael
    Enbrook Park
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Enbrook Park
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish160271430001
    IVERS, John Joseph
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish77692980002
    JEWITT, Justin Allan Spaven, Professor
    The Stables
    89 Aston End Road Aston
    SG2 7EY Stevenage
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Stables
    89 Aston End Road Aston
    SG2 7EY Stevenage
    Hertfordshire
    EnglandBritish39701670001
    KEE, Fergus Alexander
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    Amministratore
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    United KingdomIrish26911740008
    LEA, Edward William
    The Spinney
    Rose Lane
    AL4 8RD Wheathampstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Spinney
    Rose Lane
    AL4 8RD Wheathampstead
    Hertfordshire
    British28018450001
    LEWIS, Henry Nathan
    Flat 1 28 Eton Avenue
    NW3 3HL London
    Amministratore
    Flat 1 28 Eton Avenue
    NW3 3HL London
    British16463020002
    LYON, David Oliver
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish51084280003
    PETHICK, Timothy Mark
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish172197670001
    PREECE, Richard Mark
    Lakpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lakpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    United Kingdom
    EnglandBritish97531900001
    SMITH, Graham
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish142125320001
    TAYLOR, Frederick Gerard, Dr
    Merry Acres
    Sheepcote Dell Road
    HP7 0QS Beamoud End
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Merry Acres
    Sheepcote Dell Road
    HP7 0QS Beamoud End
    Buckinghamshire
    British29229590002
    TAYLOR, Neil Robert
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    Amministratore
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    United KingdomBritish62846800003

    Chi sono le persone con controllo significativo di PRIMROSE CARE LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Nestor Primecare Services Limited
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    06 apr 2016
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House England And Wales
    Numero di registrazione1963820
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PRIMROSE CARE LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 12 mar 1998
    Consegnato il 13 mar 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 15TH december 1997 between the company and the chargee
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to the account with the royal bank of scotland PLC piccadilly circus branch haymaket london in the joint names of the company and the mortgagee into which the initial deposit of £2,045 is placed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Covetree Limited
    Transazioni
    • 13 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 05 nov 1997
    Consegnato il 19 nov 1997
    In corso
    Importo garantito
    £2,250.00 due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date
    Brevi particolari
    The interest in an account in the name of linnells of greyfriars court paradise square oxford OX1 1BB at national westminster bank PLC 121 high street oxford OX1 4BB in which the sum of £2,250 has been deposited.
    Persone aventi diritto
    • Gerald Ernest Shirley
    • Alfred Ernest Russell Beesley
    • Michael John Linnell
    • Martyn Noel Elliott Ess
    Transazioni
    • 19 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 31 ott 1997
    Consegnato il 20 nov 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the event of default
    Brevi particolari
    The sum of £1,851.94 deposited in an interest earning deposit account with the mortgagees' solicitors.
    Persone aventi diritto
    • Usborne Developments Limited
    Transazioni
    • 20 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 30 lug 1997
    Consegnato il 31 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a subordinated loan agreement entered into on 16TH september 1993 as varied by a letter dated 30TH july 1997 (the facility letter)
    Brevi particolari
    Ny way of second legal mortgage all estates and interests in land or rights to acquire the same in the ownership of the company as at 30TH july 1997. by way of second fixed equitable charge all estates and interests in land or rights to acquire the same as acquired by the company after 30TH july 1997 and by way of second floating charge the company's f/h and l/h property and the other assets and undertakings and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bupa Investments Limited
    Transazioni
    • 31 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 set 1994
    Consegnato il 28 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0