PRIMROSE CARE LTD
Panoramica
| Nome della società | PRIMROSE CARE LTD |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02681546 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PRIMROSE CARE LTD?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova PRIMROSE CARE LTD?
| Indirizzo della sede legale | Cavendish House Lakpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PRIMROSE CARE LTD?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CRABTREE & GOULD LTD | 27 gen 1992 | 27 gen 1992 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PRIMROSE CARE LTD?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per PRIMROSE CARE LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Henry Whitehead come amministratore in data 12 giu 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Carl Michael Brown come amministratore in data 12 giu 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 21 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Mark Preece come amministratore in data 16 feb 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Richard Mark Preece come amministratore in data 22 gen 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Mark Pethick come amministratore in data 31 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 gen 2016 al 31 dic 2015 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Victoria Haynes come segretario in data 01 dic 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Enbrook Park Sandgate Folkestone Kent CT20 3SE a Cavendish House Lakpur Court Staffordshire Technology Park Stafford ST18 0FX in data 04 dic 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy Mark Pethick come amministratore in data 09 set 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Darryn Stanley Gibson come amministratore in data 09 set 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr John Henry Whitehead il 01 mar 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Victoria Haynes come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Taguma Ngondonga come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PRIMROSE CARE LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN, Carl Michael | Amministratore | Lakpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House United Kingdom | England | British | 232841280001 | |||||
| CHRISTODOULOU, Nicholas John | Segretario | Flat 3 3 Chatsworth Gardens BN20 7JP Eastbourne East Sussex | British | 62742480002 | ||||||
| COLLISON, David | Segretario | 44 Lowther Road SW13 9NU London England | British | 34835160001 | ||||||
| DAVIES, John | Segretario | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | 158562310001 | |||||||
| HAYNES, Victoria | Segretario | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | British | 182412280001 | ||||||
| NGONDONGA, Taguma | Segretario | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire United Kingdom | 171626990001 | |||||||
| ROBERTS THOMAS, Caroline Emma | Segretario | 5 Broomsleigh Street NW6 1QQ London | British | 76032450005 | ||||||
| SANDERS, Julian Philip | Segretario | 38 Darrick Wood Road BR6 8AW Orpington Kent | British | 6658160003 | ||||||
| KCCF LTD | Segretario nominato | 19 Old Court Place Kensington London | 900005270001 | |||||||
| BASHAM, Brian Arthur | Amministratore | Elsworthy Rise NW3 3SH London 14 | United Kingdom | British | 69378240003 | |||||
| BIDDLESTONE, Keith | Amministratore | 9 Aldenham Road WD7 8AU Radlett Hertfordshire | British | 68242230001 | ||||||
| BOOTY, Stephen Martin | Amministratore | South Lodge Guildford Road KT24 5QE Effingham Surrey | England | British | 147928010001 | |||||
| CHRISTODOULOU, Nicholas John | Amministratore | Flat 3 3 Chatsworth Gardens BN20 7JP Eastbourne East Sussex | British | 62742480002 | ||||||
| CHRISTODOULOU, Nicholas John | Amministratore | Flat 3 3 Chatsworth Gardens BN20 7JP Eastbourne East Sussex | British | 62742480002 | ||||||
| DAVIES, Julian Peter | Amministratore | Timberlea, Warminster Road South Newton SP2 0QW Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 29367700001 | |||||
| DIXON, Catherine Helen | Amministratore | 7 Ashwood Terrace LS6 2EH Leeds West Yorkshire | British | 100792180001 | ||||||
| DONALD, Alan Charles | Amministratore | 13 Craven Gardens Wimbledon SW19 8LU London | British | 58742090001 | ||||||
| ELLERBY, Mark | Amministratore | Burton Grange Burton Leonard HG3 3SU Harrogate North Yorkshire | England | British | 40582650004 | |||||
| ELLERBY, Mark | Amministratore | 82 Nelson Road N8 9RT London | British | 40582650002 | ||||||
| ELLIS, Martyn Anthony | Amministratore | Beaconsfield Road AL10 8HU Hatfield Beaconsfield Court Hertfordshire United Kingdom | England | British | 95749550002 | |||||
| GIBSON, Darryn Stanley | Amministratore | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | United Kingdom | New Zealander | 177930490001 | |||||
| GREENE, Kevin Anthony | Amministratore | Bethena 25 Alexandra Road Ash GU12 6PQ Aldershot Hampshire | British | 48212370002 | ||||||
| HOLDEN, Dean Allan | Amministratore | Spring House Spring Hill Fordcombe TN3 0SE Tunbridge Wells Kent | British | 32671980002 | ||||||
| HOWARD, Stuart Michael | Amministratore | Enbrook Park CT20 3SE Folkestone 2 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 160271430001 | |||||
| IVERS, John Joseph | Amministratore | Beaconsfield Road AL10 8HU Hatfield Beaconsfield Court Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 77692980002 | |||||
| JEWITT, Justin Allan Spaven, Professor | Amministratore | The Stables 89 Aston End Road Aston SG2 7EY Stevenage Hertfordshire | England | British | 39701670001 | |||||
| KEE, Fergus Alexander | Amministratore | The Old Cottage Howe Green SG13 8LH Hertford | United Kingdom | Irish | 26911740008 | |||||
| LEA, Edward William | Amministratore | The Spinney Rose Lane AL4 8RD Wheathampstead Hertfordshire | British | 28018450001 | ||||||
| LEWIS, Henry Nathan | Amministratore | Flat 1 28 Eton Avenue NW3 3HL London | British | 16463020002 | ||||||
| LYON, David Oliver | Amministratore | 41 Park Avenue North AL5 2EE Harpenden Hertfordshire | England | British | 51084280003 | |||||
| PETHICK, Timothy Mark | Amministratore | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 172197670001 | |||||
| PREECE, Richard Mark | Amministratore | Lakpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House United Kingdom | England | British | 97531900001 | |||||
| SMITH, Graham | Amministratore | Moor Lane LS297AF Burley In Wharfedale Briarfield West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 142125320001 | |||||
| TAYLOR, Frederick Gerard, Dr | Amministratore | Merry Acres Sheepcote Dell Road HP7 0QS Beamoud End Buckinghamshire | British | 29229590002 | ||||||
| TAYLOR, Neil Robert | Amministratore | Highfield Church Street HG5 8NR Goldsborough Knaresborough | United Kingdom | British | 62846800003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PRIMROSE CARE LTD?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestor Primecare Services Limited | 06 apr 2016 | Lakhpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
PRIMROSE CARE LTD ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creato il 12 mar 1998 Consegnato il 13 mar 1998 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 15TH december 1997 between the company and the chargee | |
Brevi particolari All the company's right title and interest in and to the account with the royal bank of scotland PLC piccadilly circus branch haymaket london in the joint names of the company and the mortgagee into which the initial deposit of £2,045 is placed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 05 nov 1997 Consegnato il 19 nov 1997 | In corso | Importo garantito £2,250.00 due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date | |
Brevi particolari The interest in an account in the name of linnells of greyfriars court paradise square oxford OX1 1BB at national westminster bank PLC 121 high street oxford OX1 4BB in which the sum of £2,250 has been deposited. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 31 ott 1997 Consegnato il 20 nov 1997 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee in the event of default | |
Brevi particolari The sum of £1,851.94 deposited in an interest earning deposit account with the mortgagees' solicitors. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 30 lug 1997 Consegnato il 31 lug 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a subordinated loan agreement entered into on 16TH september 1993 as varied by a letter dated 30TH july 1997 (the facility letter) | |
Brevi particolari Ny way of second legal mortgage all estates and interests in land or rights to acquire the same in the ownership of the company as at 30TH july 1997. by way of second fixed equitable charge all estates and interests in land or rights to acquire the same as acquired by the company after 30TH july 1997 and by way of second floating charge the company's f/h and l/h property and the other assets and undertakings and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 19 set 1994 Consegnato il 28 set 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0