THREE X MANAGED SERVICES LIMITED

THREE X MANAGED SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHREE X MANAGED SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02682404
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THREE X MANAGED SERVICES LIMITED?

    • Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova THREE X MANAGED SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THREE X MANAGED SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FIBRECITY LIMITED13 feb 200213 feb 2002
    BLUE CHIP LIMITED29 gen 199229 gen 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di THREE X MANAGED SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per THREE X MANAGED SERVICES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per THREE X MANAGED SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 dic 2013

    12 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da * Bunkers Hill the Great North Road Aberford Leeds LS25 3DF* in data 28 dic 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Cessazione della carica di Martin Hiscox come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    3 pagineMG04

    legacy

    2 pagineMG04

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    21 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 apr 2012

    Stato del capitale al 13 apr 2012

    • Capitale: GBP 52,002
    SH01

    Nomina di Samantha Gray come segretario

    1 pagineAP03

    Nomina di Djamel Souici come segretario

    1 pagineAP03

    Nomina di Martin Hiscox come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Masternaut International Sas come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di William Henry come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Waterhouse come segretario

    1 pagineTM02

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Nomina di Mr Paul Francis Bosson come amministratore

    2 pagineAP01

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Cessazione della carica di Kevin Lawrence come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    20 pagineAA

    Nomina di Mr William Patrick Henry come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Kevin Brian Lawrence come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di THREE X MANAGED SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GRAY, Samantha
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    Segretario
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    167961710001
    SOUICI, Djamel
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    Segretario
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    167961680001
    BOSSON, Paul Francis
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    Amministratore
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    EnglandBritishDirector82707040001
    BELLAMY, Simon James
    Shadwell Park Drive
    LS17 8TT Leeds
    20
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Shadwell Park Drive
    LS17 8TT Leeds
    20
    West Yorkshire
    United Kingdom
    BritishDirector95804040002
    CONWAY, Robert
    18 Barnwell House
    St Giles Road
    SE5 7RP London
    Segretario nominato
    18 Barnwell House
    St Giles Road
    SE5 7RP London
    British900002090001
    TEMPEST, Sidney
    Three Ninety Nine Old Coach Road
    Barwick Road, Garforth
    LS25 2DL Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Three Ninety Nine Old Coach Road
    Barwick Road, Garforth
    LS25 2DL Leeds
    West Yorkshire
    BritishCivil Engineer24063140002
    WATERHOUSE, Paul Keith
    Bunkers Hill
    The Great North Road Aberford
    LS25 3DF Leeds
    Segretario
    Bunkers Hill
    The Great North Road Aberford
    LS25 3DF Leeds
    151029980001
    BELLAMY, Simon James
    Shadwell Park Drive
    LS17 8TT Leeds
    20
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Shadwell Park Drive
    LS17 8TT Leeds
    20
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector95804040002
    COWAN, Graham Michael
    Gloucester Road
    EN5 1RT New Barnet
    16
    Hertfordshire
    Amministratore delegato nominato
    Gloucester Road
    EN5 1RT New Barnet
    16
    Hertfordshire
    United KingdomBritish900002410001
    DE PESCARA, Christophe
    4 Rue De La Haye
    Bp 11937
    95732 Roissy
    Hub Telecom Le Dome
    France
    Amministratore
    4 Rue De La Haye
    Bp 11937
    95732 Roissy
    Hub Telecom Le Dome
    France
    FranceFrenchDirector155158600001
    DEPEYRON, Frederic
    4 Rue De La Haye
    Bp 11937
    95732 Roissy
    Hub Telecom Le Dome
    France
    Amministratore
    4 Rue De La Haye
    Bp 11937
    95732 Roissy
    Hub Telecom Le Dome
    France
    FranceFrenchDirector155263090001
    FAVRE, Laurent
    4 Rue De La Haye
    Bp 11937
    95732 Roissy
    Hub Telecom Le Dome
    France
    Amministratore
    4 Rue De La Haye
    Bp 11937
    95732 Roissy
    Hub Telecom Le Dome
    France
    FranceFrenchDirector155331320001
    HENRY, William Patrick
    Kingfisher Way
    Hinchingbrooke Business Park
    PE29 6FN Huntingdon
    Cybit House
    Cambridgeshire
    England
    Amministratore
    Kingfisher Way
    Hinchingbrooke Business Park
    PE29 6FN Huntingdon
    Cybit House
    Cambridgeshire
    England
    United KingdomAmericanDirector159943040001
    HISCOX, Martin Andrew
    Bunkers Hill
    The Great North Road Aberford
    LS25 3DF Leeds
    Amministratore
    Bunkers Hill
    The Great North Road Aberford
    LS25 3DF Leeds
    United KingdomBritishDirector167954460001
    LANNE, Michel Marc
    Bunkers Hill
    The Great North Road Aberford
    LS25 3DF Leeds
    Amministratore
    Bunkers Hill
    The Great North Road Aberford
    LS25 3DF Leeds
    United KingdomFrenchDirector149709490002
    LAWRENCE, Kevin Brian
    Kingfisher Way
    Hinchingbrooke Business Park
    PE29 6FN Huntingdon
    Cybit House
    Cambridgeshire
    England
    Amministratore
    Kingfisher Way
    Hinchingbrooke Business Park
    PE29 6FN Huntingdon
    Cybit House
    Cambridgeshire
    England
    EnglandBritishDirector169886380001
    PORT, Martin Harry
    Wigton Lane
    LS17 8SJ Leeds
    52
    West Yorkshire
    Amministratore
    Wigton Lane
    LS17 8SJ Leeds
    52
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector84002050001
    TEMPEST, Brannan James
    Lowside Cottage Barwick Road
    Garforth
    LS25 2DL Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Lowside Cottage Barwick Road
    Garforth
    LS25 2DL Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishComputer Engineer24063150001
    TEMPEST, Craig Maxwell
    65 New Templegate
    Temple Newsham
    LS15 0JN Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    65 New Templegate
    Temple Newsham
    LS15 0JN Leeds
    West Yorkshire
    BritishComputer Engineer51019500001
    MASTERNAUT INTERNATIONAL SAS
    Rue Charles Cros
    27400 Louvier
    4
    France
    Amministratore
    Rue Charles Cros
    27400 Louvier
    4
    France
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione417555430
    155332020001

    THREE X MANAGED SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 15 apr 2011
    Consegnato il 21 apr 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 set 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Legal mortgage
    Creato il 15 apr 2011
    Consegnato il 21 apr 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Full title guarantee f/h land priory park bunkers hill aberford leeds t/no:WYK73983 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 set 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 15 feb 2008
    Consegnato il 26 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 15 feb 2008
    Consegnato il 27 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a or being land and buildings at priory park great north road aberford leeds.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment of rental income
    Creato il 26 gen 2007
    Consegnato il 31 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the assignor to the group on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any income in repect of any rental or other money under any lease licence agreement or other interest,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National PLC
    Transazioni
    • 31 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal and general charge
    Creato il 26 gen 2007
    Consegnato il 31 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All uncalled capital all intellectual property rights and all other f/h and l/h property now or in the future any legal or beneficial interest in all securitities stock in trade and plant book debts floating charge any immovable property and assets,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National PLC
    Transazioni
    • 31 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 04 mag 2005
    Consegnato il 20 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a priory park bunkers hill aberford leeds t/no WYK73983. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 feb 2005
    Consegnato il 05 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage over benefit of guarantee bond
    Creato il 21 ott 2003
    Consegnato il 31 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the entire beneficial interest in and benefit to the borrower of the guarantee bond dated 1 october 2003 and all rights to receive any damages or compensation or other payments for any breach of the obligations contained in the guarantee bond.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 ott 2003
    Consegnato il 31 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A legal mortgage of all f/h and l/h property now vested in the company including the property known as priory park, bunkers hill, aberford, leeds t/no WYK73983. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 ott 2003
    Consegnato il 31 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage f/h property known as priory park, bunkers hill, aberford, leeds t/no WYK73983. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 giu 2002
    Consegnato il 18 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property known as priory park bunkers hill the great north road aberford leeds west yorkshire title number WYK73983.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 feb 2000
    Consegnato il 06 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    78 main street garforth leeds west yorkshire t/no: WYK374777.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 02 giu 1995
    Consegnato il 06 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-78 main street garforth leeds west yorkshire together with a floating charge over all movable fixtures fittings plant machinery equipment materials and articles.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 06 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    THREE X MANAGED SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    18 dic 2012Inizio della liquidazione
    22 nov 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Matthew John Waghorn
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Praticante
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    David William Tann
    Bridge House London Bridge
    SE1 9QR London
    Praticante
    Bridge House London Bridge
    SE1 9QR London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0