ANCHORJADE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàANCHORJADE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02682770
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ANCHORJADE LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ANCHORJADE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Eldon Court
    Percy Street
    NE99 1TD Newcastle Upon Tyne
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ANCHORJADE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per ANCHORJADE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 30 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 feb 2012

    Stato del capitale al 01 feb 2012

    • Capitale: GBP 25,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Barry Edward Kerr Gilmour il 30 gen 2012

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175(5)a 12/08/2010
    RES13

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    7 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    7 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    7 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    7 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2005

    7 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2004

    7 pagineAA

    legacy

    2 pagine363s

    legacy

    pagine363(353)

    Bilancio redatto al 31 mar 2003

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di ANCHORJADE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAMPBELL, Russell Kenneth
    Highfield
    North Bank, Haydon Bridge
    NE47 6LY Hexham
    Northumberland
    Segretario
    Highfield
    North Bank, Haydon Bridge
    NE47 6LY Hexham
    Northumberland
    British26948290004
    CAMPBELL, Russell Kenneth
    Highfield
    North Bank, Haydon Bridge
    NE47 6LY Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    Highfield
    North Bank, Haydon Bridge
    NE47 6LY Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritishCompany Secretary26948290004
    GILMOUR, Barry Edward Kerr
    East Road
    Longhorsley
    NE65 8SY Morpeth
    Heatherlands
    Northumberland
    Amministratore
    East Road
    Longhorsley
    NE65 8SY Morpeth
    Heatherlands
    Northumberland
    United KingdomBritishCompany Director20361920009
    PLANT, William Allan
    1 Barnard Court
    Woodstone Village
    DH4 6TS Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Barnard Court
    Woodstone Village
    DH4 6TS Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishCompany Director87465680003
    CHAMBERS, David Alan
    Oakrise Hawkshill Close
    KT10 8JY Esher
    Surrey
    Segretario
    Oakrise Hawkshill Close
    KT10 8JY Esher
    Surrey
    English2669400001
    CHRISTIAN, Kevin
    12 Close Quane
    IM5 1PY Peel
    Isle Of Man
    Segretario
    12 Close Quane
    IM5 1PY Peel
    Isle Of Man
    BritishChartered Accountant54761610001
    SAME-DAY COMPANY SERVICES LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Segretario nominato
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000980001
    CHRISTIAN, Kevin
    12 Close Quane
    IM5 1PY Peel
    Isle Of Man
    Amministratore
    12 Close Quane
    IM5 1PY Peel
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishChartered Accountant54761610001
    IVANOVIC, Ivan Bozidar
    Staveley House Staveley Road
    W4 3HU London
    Amministratore
    Staveley House Staveley Road
    W4 3HU London
    United KingdomBritishCompany Director48128130002
    SHUTTLEWORTH, David Andrew
    158 Edge Hill
    Ponteland
    NE20 9JN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    158 Edge Hill
    Ponteland
    NE20 9JN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishCompany Director67100520005
    WALKER, Geoffrey
    Ivy House 11 King Street
    PO10 7AX Emsworth
    Hampshire
    Amministratore
    Ivy House 11 King Street
    PO10 7AX Emsworth
    Hampshire
    BritishCompany Director918890001
    WATKINS, David Tyrrell
    Redheugh
    Tarset
    NE48 1NB Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    Redheugh
    Tarset
    NE48 1NB Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritishShipbroker15566730001
    WILDMAN & BATTELL LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Amministratore delegato nominato
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000970001

    ANCHORJADE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 13 set 1997
    Consegnato il 02 ott 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever including but not limited to the financing documents (as therein defined)
    Brevi particolari
    Property k/a part first floor eldon court newcastle upon tyne t/n TY63990, part first floor eldon court newcastle upon tyne t/n TY59435, FI9RST floor offices at blatic house station road ballasella isle of man, units 25 and 26 blezard business park brenkley colliery seaton buen tyne and wear please see form 395 for further properties listed together with all buildings and fixtures ( including trade fixtures) and fixed plant and machinery all ships currently owned by inter alia the chargor together with all vesselswhich may be acquired by the chargor, all plant machinery vehicles and other equipment the benefit of all present and future licences the goodwill its debts the benefit of all contracts and a floating charge over the undertaking property assets and rights.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 13 set 1997
    Consegnato il 18 set 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 18 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Share charge
    Creato il 02 lug 1994
    Consegnato il 20 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the limited recourse guarantee dated 9TH april 1994 securing the obligations of stephenson clarke shipping limited under the terms of the loan agreement dated 9TH april 1992 and the supplemental agreement dated 2ND july 1994 and/or this charge
    Brevi particolari
    All the company's interest in and to all the shares being the shares in the capital of stephenson clarke shipping limited beneficially owned by and to be registered in the name of the company and shall include any other shares and all stock, shares, warrants, securities, dividends and bonuses etc. in respect of or derived from the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hambros Bank Limited(As Agent and Trustee for Itself and the Governor and Company of the Bank of Scotland)
    Transazioni
    • 20 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 09 apr 1992
    Consegnato il 24 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany and/or powell duffryn shipping limited now known as stephenson clarke shipping limited to the chargee under the terms of all or any of the security documents (as defined) and this charge
    Brevi particolari
    All the companys rights title and interet in and to the majority shareholders mortgaged property and all benefit and interest therein together with all rights and receivables (as defined) see form 395 ref M512C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hambros Bank Limited (As Agent and Trustee for Itself and the Banks)
    Transazioni
    • 24 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 apr 1992
    Consegnato il 24 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany to hambros bank limited (as agent for the banks) and to the banks (as defined) or any of them under or pursuant to the guarantee the facility letter the advisory fees letter and/or this deed
    Brevi particolari
    Please see form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hambros Bank Limited
    Transazioni
    • 24 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 09 apr 1992
    Consegnato il 24 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to hambros bank limited as agent and trustee for itself and the banks as defined pursuant to the guarantee,the loan agreement dated 090492 and the security documents as defined
    Brevi particolari
    The interest of the compamy in and to the shares of pd shipping beneficially owned including the dividends interest or income therefrom (please see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Hambros Bank Limited
    Transazioni
    • 24 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0