LOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED

LOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02683478
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED?

    • fabbricazione di altre macchine per scopi speciali n.c.a. (28990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova LOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lock House Neville Street
    Chadderton
    OL9 6LF Oldham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    YAMATO LOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED28 gen 199228 gen 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di LOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per LOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Edward Ufland come amministratore in data 13 mar 2017

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Philip Matthew Deakin come amministratore in data 30 ott 2017

    2 pagineTM01

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 28 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 feb 2016

    Stato del capitale al 22 feb 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per S & J Registrars Limited il 01 mag 2015

    1 pagineCH04

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 28 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 feb 2015

    Stato del capitale al 16 feb 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 05 ago 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    18 pagineAA

    Cessazione della carica di Ola Tricia Aramita Barreto-Morley come amministratore in data 31 mar 2013

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di LOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    S & J REGISTRARS LIMITED
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Segretario
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione01740543
    43122090005
    HUDSON, Giles Matthew
    Lock House Neville Street
    Chadderton
    OL9 6LF Oldham
    Amministratore
    Lock House Neville Street
    Chadderton
    OL9 6LF Oldham
    United KingdomBritishChartered Accountant161583790003
    CODRINGTON, Ronald George
    7 Saumur Way
    CV34 6LH Warwick
    Warwickshire
    Segretario
    7 Saumur Way
    CV34 6LH Warwick
    Warwickshire
    British776800001
    GARNETT, David John Edward
    13 Cunliffe Drive
    M33 3WS Sale
    Cheshire
    Segretario
    13 Cunliffe Drive
    M33 3WS Sale
    Cheshire
    BritishDirector41691700001
    SMITH, Maureen
    31 Juliet Drive
    Bilton
    CV22 6LY Rugby
    Warwickshire
    Segretario
    31 Juliet Drive
    Bilton
    CV22 6LY Rugby
    Warwickshire
    British23498410001
    SAME-DAY COMPANY SERVICES LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Segretario nominato
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000980001
    BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita
    Lock House Neville Street
    Chadderton
    OL9 6LF Oldham
    Amministratore
    Lock House Neville Street
    Chadderton
    OL9 6LF Oldham
    United KingdomBritishTax Manager140644240001
    DEAKIN, Philip Matthew
    Lock House Neville Street
    Chadderton
    OL9 6LF Oldham
    Amministratore
    Lock House Neville Street
    Chadderton
    OL9 6LF Oldham
    United KingdomBritishChartered Accountant146225080002
    DEIGHTON, David Martin
    47 Ivygreen Drive
    Springhead
    OL4 4PR Oldham
    Lancashire
    Amministratore
    47 Ivygreen Drive
    Springhead
    OL4 4PR Oldham
    Lancashire
    BritishDirector67817050001
    GARNETT, David John Edward
    13 Cunliffe Drive
    M33 3WS Sale
    Cheshire
    Amministratore
    13 Cunliffe Drive
    M33 3WS Sale
    Cheshire
    EnglandBritishChartered Accountant41691700001
    HARTLEY, Peter Robert
    29 Kirkdale Drive
    Royton
    OL2 5TG Oldham
    Lancashire
    Amministratore
    29 Kirkdale Drive
    Royton
    OL2 5TG Oldham
    Lancashire
    EnglandBritishDirector67818140001
    HIRANI, Hitesh Ratna
    20 Wensleydale Close
    Royton
    OL2 5TQ Oldham
    Lancashire
    Amministratore
    20 Wensleydale Close
    Royton
    OL2 5TQ Oldham
    Lancashire
    EnglandBritishDirector67817320001
    HIRANO, Takashi
    9-53 Rikyumae-Cho
    Suma-Ku
    FOREIGN Kobe-City
    Hyogo-Pref
    Japan
    Amministratore
    9-53 Rikyumae-Cho
    Suma-Ku
    FOREIGN Kobe-City
    Hyogo-Pref
    Japan
    JapaneseEngineering Manager28029510001
    KAWANISHI, Shozo
    4-12-5 Kurakuen
    FOREIGN Nishinomiya-City
    Hyogo-Pref 673
    Japan
    Amministratore
    4-12-5 Kurakuen
    FOREIGN Nishinomiya-City
    Hyogo-Pref 673
    Japan
    JapaneseCompany Director40054040001
    KIRKMAN, Anthony Terence
    3 Cawdon Grove
    Dorridge
    B93 8EA Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    3 Cawdon Grove
    Dorridge
    B93 8EA Solihull
    West Midlands
    BritishDivisional Managing Director41435170001
    LOGUE, Neil Joseph
    The Stable House
    Lutterworth Road, North Kilworth
    LE17 6JE Lutterworth
    Leicestershire
    Amministratore
    The Stable House
    Lutterworth Road, North Kilworth
    LE17 6JE Lutterworth
    Leicestershire
    United KingdomIrishGroup Finance Director151942010001
    LONDON, Philip Ronald
    31 Mayall Drive
    Four Oaks
    B75 5LR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    31 Mayall Drive
    Four Oaks
    B75 5LR Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishDivisional Financial Controlle70642220001
    LONG, Mark Peter
    11 Ashley Drive
    Bramhall
    SK7 1EW Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    11 Ashley Drive
    Bramhall
    SK7 1EW Stockport
    Cheshire
    BritishCompany Director52377020001
    MASSEY, Harry
    25 Strathmore Close
    Ramsbottom
    BL0 9YW Bury
    Lancashire
    Amministratore
    25 Strathmore Close
    Ramsbottom
    BL0 9YW Bury
    Lancashire
    BritishDirector67817440001
    MCCARTHY, John Patrick
    184 Simmondley Lane
    SK13 6LY Glossop
    Derbyshire
    Amministratore
    184 Simmondley Lane
    SK13 6LY Glossop
    Derbyshire
    BritishDirector70339800001
    PRINGLE, Frank Edwin
    1109b Aspen Court
    FOREIGN Kohler
    Wisconsin 53044
    Usa
    Amministratore
    1109b Aspen Court
    FOREIGN Kohler
    Wisconsin 53044
    Usa
    AmericanConsultant28029500001
    RANDALL, Michael Raymond David, Dr
    Poplars The Avenue
    Rowledge
    GU10 4AL Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Poplars The Avenue
    Rowledge
    GU10 4AL Farnham
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director15272540001
    RANDALL, Michael Raymond David, Dr
    Poplars The Avenue
    Rowledge
    GU10 4AL Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Poplars The Avenue
    Rowledge
    GU10 4AL Farnham
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director15272540001
    ROBINSON, Geoffrey
    Orchards
    Munstead Heath
    GU8 4AR Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Orchards
    Munstead Heath
    GU8 4AR Godalming
    Surrey
    EnglandBritishChairman79887440001
    ROSS, Alan Irving
    20 Rawson Crescent
    KA5 5AT Mauchline
    Ayrshire
    Amministratore
    20 Rawson Crescent
    KA5 5AT Mauchline
    Ayrshire
    EnglandBritishManaging Director120484750001
    STALKER, Michael
    3 Tatchbury Road
    Failsworth
    M35 9PZ Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    3 Tatchbury Road
    Failsworth
    M35 9PZ Manchester
    Lancashire
    BritishDirector70339920001
    SUMMERFIELD, Peter Humphrey
    17 Grendon Road
    B92 7EL Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    17 Grendon Road
    B92 7EL Solihull
    West Midlands
    BritishDivisional Managing Director56557810002
    UFLAND, Edward
    Lock House Neville Street
    Chadderton
    OL9 6LF Oldham
    Amministratore
    Lock House Neville Street
    Chadderton
    OL9 6LF Oldham
    United KingdomBritishChartered Accountant87558180001
    WALSH, James Laurence
    4 Canterbury Park
    Holme Road
    M20 2UQ Didsbury
    Lancashire
    Amministratore
    4 Canterbury Park
    Holme Road
    M20 2UQ Didsbury
    Lancashire
    BritishGeneral Manager61934910003
    WOOD, John Denis George
    21 Northwick Crescent
    B91 3TU Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    21 Northwick Crescent
    B91 3TU Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishManaging Director41350610001
    WILDMAN & BATTELL LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Amministratore delegato nominato
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000970001

    LOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of deposit
    Creato il 12 nov 2012
    Consegnato il 27 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit of £15,000 and all amounts in the future credited to account number 64303586 with the bank.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 15 ott 2004
    Consegnato il 20 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 15 ott 2004
    Consegnato il 20 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land and buildings on the east side of neville street, oldham t/no. GM577209 and l/h property k/a premises on the west side of neville street, oldham t/no. GM481866. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 dic 1998
    Consegnato il 08 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (including for the avoidance of doubt, the debenture)
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage f/h & l/h land at neville street oldham t/nos: GM481866 and GM577209. .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 17 dic 1992
    Consegnato il 21 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 1994Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 20 mar 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 dic 1992
    Consegnato il 21 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land and buildings situate on the west side of neville street oldham greater manchester t/n gm 481866. together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 1994Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 20 mar 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 dic 1992
    Consegnato il 21 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings situate on the east side of neville street oldham greater manchester t/n gm 577209. together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 1994Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 20 mar 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0