RHONDDA BUSES LIMITED

RHONDDA BUSES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRHONDDA BUSES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02683764
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RHONDDA BUSES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova RHONDDA BUSES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Stagecoach Services Limited One Stockport Exchange
    20 Railway Road
    SK1 3SW Stockport
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di RHONDDA BUSES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 mag 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per RHONDDA BUSES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Stato del capitale al 30 giu 2021

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 02 mag 2020

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2019

    4 pagineAA

    Nomina di Karen Rosaleen Robbins come amministratore in data 31 mag 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Bruce Dingwall come amministratore in data 31 mag 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Colin Brown come amministratore in data 31 mag 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2018

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2017

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Stagecoach Services Ltd Daw Bank Stockport Cheshire SK3 0DU a C/O Stagecoach Services Limited One Stockport Exchange 20 Railway Road Stockport SK1 3SW in data 16 nov 2017

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 giu 2016

    Stato del capitale al 14 giu 2016

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 mag 2015

    Stato del capitale al 04 mag 2015

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2014

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di RHONDDA BUSES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Segretario
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    British137383880001
    DINGWALL, Bruce Maxwell
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant185252790001
    ROBBINS, Karen Rosaleen
    Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    8
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    8
    Derbyshire
    England
    EnglandBritishCompany Director73518280001
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor137383880003
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Segretario
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    BritishAccountant70283550001
    GILBERT, Robert John
    2 Swn-Y-Mor
    Southerndown
    CF32 0RN Bridgend
    Mid Glamorgan
    Segretario
    2 Swn-Y-Mor
    Southerndown
    CF32 0RN Bridgend
    Mid Glamorgan
    BritishCompany Director7449870001
    HARVEY, Peter
    56 Brand Hill
    Woodhouse Eaves
    LE12 8SS Loughborough
    Leicestershire
    Segretario
    56 Brand Hill
    Woodhouse Eaves
    LE12 8SS Loughborough
    Leicestershire
    British30318040002
    NEWEY, Yvonne
    92 Welland Road
    Hilton
    DE65 5NE Derby
    Segretario
    92 Welland Road
    Hilton
    DE65 5NE Derby
    BritishCompany Secretary100520100001
    STAITE, John Frederick
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    Segretario
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    BritishCompany Director45931770001
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Segretario
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BIRD, Andrew
    9 Ashton Close
    BS21 7UT Clevedon
    Avon
    Amministratore
    9 Ashton Close
    BS21 7UT Clevedon
    Avon
    BritishEngineering Director20747560001
    BROWN, Colin
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant85970020003
    COCHRANE, Keith Robertson
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    Amministratore
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    BritishFinance Director47574960002
    COX, Anthony Geoffrey
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director70180950001
    COX, Brian John
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    Amministratore
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    EnglandBritishExecutive Director1436830002
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Amministratore
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    EnglandBritishAccountant70283550001
    GILBERT, Robert John
    2 Swn-Y-Mor
    Southerndown
    CF32 0RN Bridgend
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    2 Swn-Y-Mor
    Southerndown
    CF32 0RN Bridgend
    Mid Glamorgan
    BritishCompany Director7449870001
    GRIFFITHS, Martin Andrew
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Amministratore
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    ScotlandBritishFinance Director61722690002
    HINKLEY, William Barry
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    Amministratore
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    EnglandBritishExecutive Director2268190002
    KINSKI, Michael John
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    United KingdomBritishGroup Chief Executive58643710001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director6874440001
    MOORS, Michael Eric
    5 Ridge House
    Ridge House Drive, Festival Park
    ST1 5SJ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    5 Ridge House
    Ridge House Drive, Festival Park
    ST1 5SJ Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector26926420002
    NEWEY, Yvonne
    92 Welland Road
    Hilton
    DE65 5NE Derby
    Amministratore
    92 Welland Road
    Hilton
    DE65 5NE Derby
    BritishAccounts Manager100520100001
    PEACH, William
    11 Clos Y Dolydd
    Beddau
    CF38 2TG Pontypridd
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    11 Clos Y Dolydd
    Beddau
    CF38 2TG Pontypridd
    Mid Glamorgan
    BritishGeneral Manager48137360001
    PEDDLE, Julian Henry
    Orchard Cottage
    Stubwood
    ST14 5HX Uttoxeter
    Staffordshire
    Amministratore
    Orchard Cottage
    Stubwood
    ST14 5HX Uttoxeter
    Staffordshire
    BritishDirector6284620001
    ROBBINS, Karen Rosaleen
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    Amministratore
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    EnglandBritishAccountant73518280001
    STAITE, John Frederick
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    Amministratore
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    United KingdomBritishCompany Director45931770001
    SWEETING, John Raymond
    Riversedge 15 Tollgate Close
    CF8 3AY Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    Riversedge 15 Tollgate Close
    CF8 3AY Caerphilly
    Mid Glamorgan
    BritishCommercial Director25628210001
    VARLEY, Graeme George Turnbull
    5 Knole Close
    Almondsbury
    BS12 4EJ Bristol
    Avon
    Amministratore
    5 Knole Close
    Almondsbury
    BS12 4EJ Bristol
    Avon
    BritishDirector38424570001
    WARNEFORD, Leslie Brian
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director49771140004
    WHITE, Robert Neil Pratt
    18 Celandine Court
    Ty Canol
    NP44 6JU Cwmbran
    Gwent
    Amministratore
    18 Celandine Court
    Ty Canol
    NP44 6JU Cwmbran
    Gwent
    BritishCompany Director20722660001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RHONDDA BUSES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleUnited Kingdom (Scotland)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc176671
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    RHONDDA BUSES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 18 feb 1992
    Consegnato il 26 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land situate at porth glamorgan including land at aberhondda road porth land at ynishir and part of therhondda fach river and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattels mortgage
    Creato il 04 feb 1992
    Consegnato il 08 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £125,425.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All the plant machinery and chattels listed on the reverse of the form 395 and attached schedule please see form for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Welsh Omnibus Services Limited
    Transazioni
    • 08 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 03 feb 1992
    Consegnato il 13 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0