ECCLESFIELD PROPERTIES LIMITED

ECCLESFIELD PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàECCLESFIELD PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02684008
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ECCLESFIELD PROPERTIES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova ECCLESFIELD PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ECCLESFIELD PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KT565 LIMITED04 feb 199204 feb 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di ECCLESFIELD PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per ECCLESFIELD PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    legacy

    3 pagineSH20

    legacy

    3 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale al 14 giu 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    Cessazione della carica di Michael James Kachmer come amministratore in data 03 apr 2013

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Nomina di Graham Philip Brisley Veal come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kevin Blades come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Maurice Delon Jones il 11 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Prima Secretary Limited il 11 gen 2010

    2 pagineCH04

    Cessazione della carica di Thomas Doerr come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Adrian David Gray come amministratore

    3 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    3 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di ECCLESFIELD PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Segretario
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4363143
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Amministratore
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritish146072380001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Amministratore
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    Amministratore
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    BURROWES, Rosemary Anne
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    Segretario
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    British49687740001
    COX, Jacqueline
    81 Manchester Road
    Deepcar
    S30 5QX Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    81 Manchester Road
    Deepcar
    S30 5QX Sheffield
    South Yorkshire
    British11720990002
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    POINTON, Graham
    6 Grasmere Close
    Penistone
    S30 6HP Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    6 Grasmere Close
    Penistone
    S30 6HP Sheffield
    South Yorkshire
    British3081900001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    Segretario
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    WATSON, David Ian
    Knoll Farm Aston
    Hope
    S33 6RA Hope Valley
    Segretario
    Knoll Farm Aston
    Hope
    S33 6RA Hope Valley
    British8474300001
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Amministratore
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    COX, Jacqueline
    81 Manchester Road
    Deepcar
    S30 5QX Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    81 Manchester Road
    Deepcar
    S30 5QX Sheffield
    South Yorkshire
    British11720990002
    CUTHBERTSON, George Brian
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish6996370001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Amministratore
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    JEFFREY, Nicholas
    Riley Croft
    Eyam
    S32 5QZ Hope Valley
    Amministratore
    Riley Croft
    Eyam
    S32 5QZ Hope Valley
    EnglandBritish15639340001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    Amministratore
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican136570610001
    MULHALL, Denis Joseph
    Fitzgeorge House
    Fitzgeorge Avenue
    KT3 4SH New Malden
    Surrey
    Amministratore
    Fitzgeorge House
    Fitzgeorge Avenue
    KT3 4SH New Malden
    Surrey
    EnglandBritish,Irish32235150003
    RIDLER, Mark Philip
    35 Oakdale Road Netheredge
    S7 1SL Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    35 Oakdale Road Netheredge
    S7 1SL Sheffield
    South Yorkshire
    British66732880002
    SHEPHERD, James Gordon
    Ridgeways 100 Bawtry Road
    Bessacarr
    DN4 7BW Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Ridgeways 100 Bawtry Road
    Bessacarr
    DN4 7BW Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritish8474280001
    WATSON, David Ian
    Knoll Farm Aston
    Hope
    S33 6RA Hope Valley
    Amministratore
    Knoll Farm Aston
    Hope
    S33 6RA Hope Valley
    United KingdomBritish8474300001
    WHITELING, Mark Argent
    The Treehouse
    85 Elmfield Avenue
    TW11 8BX Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    The Treehouse
    85 Elmfield Avenue
    TW11 8BX Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish101297630001
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006

    ECCLESFIELD PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 25 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 25 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    Creato il 20 feb 2002
    Consegnato il 08 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 08 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    Creato il 20 nov 2001
    Consegnato il 30 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 mar 1992
    Consegnato il 13 mar 1992
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings at butterthwaite lane ecclesfield sheffield title number SYK295344. And proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 06 mar 1992
    Consegnato il 13 mar 1992
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0