TELSTRA (PSINET)

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTELSTRA (PSINET)
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 02684753
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TELSTRA (PSINET)?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova TELSTRA (PSINET)?

    Indirizzo della sede legale
    2nd Floor, Blue Fin
    110 Southwark Street
    SE1 0TA London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TELSTRA (PSINET)?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PSINET UK LIMITED01 lug 199801 lug 1998
    EUNET GB LIMITED25 nov 199425 nov 1994
    GBNET LIMITED06 feb 199206 feb 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di TELSTRA (PSINET)?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per TELSTRA (PSINET)?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 feb 2016

    Stato del capitale al 12 feb 2016

    • Capitale: GBP 3,619,618
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 18 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 feb 2015

    Stato del capitale al 06 feb 2015

    • Capitale: GBP 3,619,618
    SH01

    Cessazione della carica di Douglas Rogerson come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Douglas James Rogerson come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Henry Hon come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 18 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 feb 2014

    Stato del capitale al 04 feb 2014

    • Capitale: GBP 3,619,618
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 18 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ming Chau Henry Hong il 17 mag 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 18 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2010

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Ming Chau Henry Hon come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Kirton come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Murray Hankinson come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 18 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Telstra House 21 Tabernacle Street London EC2A 4DE* in data 23 giu 2010

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Simon Vye come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Alexander Kelton come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2009

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di TELSTRA (PSINET)?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GOULD, John Matthew Joseph, Mr.
    Flat 3
    9 Paddington Street
    W1U 5QJ London
    W1v 5qj
    Segretario
    Flat 3
    9 Paddington Street
    W1U 5QJ London
    W1v 5qj
    BritishSolicitor79846290001
    GOULD, John Matthew Joseph, Mr.
    Flat 3
    9 Paddington Street
    W1U 5QJ London
    W1v 5qj
    Amministratore
    Flat 3
    9 Paddington Street
    W1U 5QJ London
    W1v 5qj
    United KingdomBritishSolicitor79846290001
    BENTLEY, Ann
    8 Daniels Court
    CT5 1ET Whitstable
    Kent
    Segretario
    8 Daniels Court
    CT5 1ET Whitstable
    Kent
    British56185680001
    KUNKEL, David Nelson
    3007 South Erin Drive
    22124 Oakton
    Virginia
    Usa
    Segretario
    3007 South Erin Drive
    22124 Oakton
    Virginia
    Usa
    AmericanLawyer45035440002
    POWELL, Geoffrey Leonard
    Collinwood High Wych Lane
    High Wych
    CM21 0JR Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Segretario
    Collinwood High Wych Lane
    High Wych
    CM21 0JR Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    British60033230001
    SCOTT, Alexander Victor John
    8 Borley Way
    Teversham
    CB1 5BA Cambridge
    Segretario
    8 Borley Way
    Teversham
    CB1 5BA Cambridge
    British36797650003
    STONE, Ian Rodney
    2 Salisbury Road
    CT6 6JH Herne Bay
    Kent
    Segretario
    2 Salisbury Road
    CT6 6JH Herne Bay
    Kent
    British2752350001
    ARNELL, Roland Scott
    20 Rue Francois Grast
    FOREIGN Geneva
    1208
    Switzerland
    Amministratore
    20 Rue Francois Grast
    FOREIGN Geneva
    1208
    Switzerland
    AmericanDirector78737210001
    BIRD, James
    Ship House
    The Leas Kingsdown
    CT14 8ER Deal
    Kent
    Amministratore
    Ship House
    The Leas Kingsdown
    CT14 8ER Deal
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director2752390001
    CLAYTON, Henry Roger
    Ladywell House Spring Lane
    Fordwich
    CT2 0DL Canterbury
    Kent
    Amministratore
    Ladywell House Spring Lane
    Fordwich
    CT2 0DL Canterbury
    Kent
    BritishUniversity-Director Of Finance30883170001
    COLLINSON, Richard Peter Anthony
    61 Hillside Avenue
    CT2 8HA Canterbury
    Kent
    Amministratore
    61 Hillside Avenue
    CT2 8HA Canterbury
    Kent
    United KingdomBritishComputer Consultant13716740001
    COOPER, Simon Nicholas Hope
    Bridge House
    Bridge Street
    IM9 1AX Castletown
    Isle Of Man
    Amministratore
    Bridge House
    Bridge Street
    IM9 1AX Castletown
    Isle Of Man
    BritishLawyer80955930001
    CUNNINGHAM, Daniel Peter
    11605 Clipstone Lane
    Reston
    USA Virginia
    22090
    Amministratore
    11605 Clipstone Lane
    Reston
    USA Virginia
    22090
    AmericanFinancial Officer47738720001
    HANKINSON, Murray John
    5 St John's Wood Road
    NW8 8RB London
    Ground Floor Flat
    Amministratore
    5 St John's Wood Road
    NW8 8RB London
    Ground Floor Flat
    United KingdomAustralianGroup Manager104972830002
    HANKINSON, Murray John
    Flat 4
    26 Upper Wimpole Street
    W1G 6NG London
    Amministratore
    Flat 4
    26 Upper Wimpole Street
    W1G 6NG London
    AustralianGroup Manager104972830001
    HEDGES, Andrew John
    Maple Lodge Farm House
    Maple Lodge Close Denham Way
    WD3 9SF Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Maple Lodge Farm House
    Maple Lodge Close Denham Way
    WD3 9SF Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritishBusinessman72371930001
    HOBBS, Harry
    17971 Yatton Road
    Round Hill
    IRISH Virginia
    22014
    U S A
    Amministratore
    17971 Yatton Road
    Round Hill
    IRISH Virginia
    22014
    U S A
    United StatesAmericanBusinessman64342610001
    HOLT, Valerie
    46 Rock Road
    CB1 7UF Cambridge
    Amministratore
    46 Rock Road
    CB1 7UF Cambridge
    BritishManaging Director62469210001
    HON, Henry Ming Chau
    Floor, Blue Fin
    110 Southwark Street
    SE1 0TA London
    2nd
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor, Blue Fin
    110 Southwark Street
    SE1 0TA London
    2nd
    United Kingdom
    Hong KongUnited States Of AmericaGroup Financial Controller159232370004
    HORNE, Kathleen
    19095 Loudoun Orchard Road
    20175 Leesburg
    Virginia
    Usa
    Amministratore
    19095 Loudoun Orchard Road
    20175 Leesburg
    Virginia
    Usa
    Us CitizenAttorney72818090001
    HOULDER, Peter Jeremy
    4 Redbrick Cottages Rhode Common
    Dunkirk
    ME13 9PH Faversham
    Kent
    Amministratore
    4 Redbrick Cottages Rhode Common
    Dunkirk
    ME13 9PH Faversham
    Kent
    BritishNetwork Manager33119810001
    JONES, Deri Gwentfryn
    17 Highfield Close
    CT2 9DX Canterbury
    Kent
    Amministratore
    17 Highfield Close
    CT2 9DX Canterbury
    Kent
    BritishCompany Director89903570001
    KELTON, Alexander Andrew
    353 Edingburgh Road
    Castlegrag
    New South Wales
    Nsw 2068
    Australia
    Amministratore
    353 Edingburgh Road
    Castlegrag
    New South Wales
    Nsw 2068
    Australia
    AustraliaAustraliaGroup Managing Dir103940820001
    KIRTON, David
    17 Northcote Avenue
    Caringbah
    New South Wales
    Nsw 2229
    Australia
    Amministratore
    17 Northcote Avenue
    Caringbah
    New South Wales
    Nsw 2229
    Australia
    AustraliaAustraliaGroup Financial Controller103940930001
    KIRTON, David
    17 Northcote Avenue
    Caringbah
    New South Wales
    Nsw 2229
    Australia
    Amministratore
    17 Northcote Avenue
    Caringbah
    New South Wales
    Nsw 2229
    Australia
    AustraliaAustraliaGroup Financial Con103940930001
    KUNKEL, David Nelson
    3007 South Erin Drive
    22124 Oakton
    Virginia
    Usa
    Amministratore
    3007 South Erin Drive
    22124 Oakton
    Virginia
    Usa
    AmericanLawyer45035440002
    MEAD, Timothy John
    Jaspers
    24a Westbere Lane Westbere
    CT2 0HH Canterbury
    Kent
    Amministratore
    Jaspers
    24a Westbere Lane Westbere
    CT2 0HH Canterbury
    Kent
    BritishUniversity Registrar28809090003
    MEAD, Timothy John
    Jaspers
    24a Westbere Lane Westbere
    CT2 0HH Canterbury
    Kent
    Amministratore
    Jaspers
    24a Westbere Lane Westbere
    CT2 0HH Canterbury
    Kent
    BritishUniversity Administrator28809090003
    OMAND, James Magnus Christopher
    Give Ale Cottage
    Fordwich
    CT2 0DB Canterbury
    Kent
    Amministratore
    Give Ale Cottage
    Fordwich
    CT2 0DB Canterbury
    Kent
    BritishCompany Director9652320001
    ROGERSON, Douglas James
    Floor, Blue Fin
    110 Southwark Street
    SE1 0TA London
    2nd
    Amministratore
    Floor, Blue Fin
    110 Southwark Street
    SE1 0TA London
    2nd
    Hong KongBritishFinance Director188657790001
    SALY, Leo
    18 Eldridge Street
    Cherrybrook
    New South Wales Nsw 2126
    Australia
    Amministratore
    18 Eldridge Street
    Cherrybrook
    New South Wales Nsw 2126
    Australia
    DutchGroup Manager104402780001
    SCHRADER, William Lee
    20082 Dairy Lane
    IRISH Sterling
    Virginia
    Usa
    Amministratore
    20082 Dairy Lane
    IRISH Sterling
    Virginia
    Usa
    AmericanBusinessman39901710001
    SCOTT, Alexander Victor John
    8 Borley Way
    Teversham
    CB1 5BA Cambridge
    Amministratore
    8 Borley Way
    Teversham
    CB1 5BA Cambridge
    EnglandBritishDirector36797650003
    SLATER, John Bruce, Professor
    29 St Annes Road
    CT5 2DP Whitstable
    Kent
    Amministratore
    29 St Annes Road
    CT5 2DP Whitstable
    Kent
    BritishUniversity Professor19182670001
    TARLOVSKY, Nir
    767 Fifth Avenue
    Suite 4300
    NY 10153 New York
    New York
    Usa
    Amministratore
    767 Fifth Avenue
    Suite 4300
    NY 10153 New York
    New York
    Usa
    IsraeliCompany Director49590840001

    TELSTRA (PSINET) ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 30 lug 1999
    Consegnato il 04 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the rent deposit deed the lease and the authorised guarantee agreement
    Brevi particolari
    The balance from time to time standing to the credit of the deposit account opened in the name of the landlord bearing the deposit fund. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ttc (1994) Limited
    Transazioni
    • 04 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rental deposit deed
    Creato il 24 giu 1999
    Consegnato il 30 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £18,125 and allother monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the rent deposit deed
    Brevi particolari
    £18,125.
    Persone aventi diritto
    • Oakfern Properties Limited
    Transazioni
    • 30 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 16 set 1994
    Consegnato il 30 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0