TOM COBLEIGH (INNS) LIMITED

TOM COBLEIGH (INNS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTOM COBLEIGH (INNS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02684842
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TOM COBLEIGH (INNS) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TOM COBLEIGH (INNS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Resolve Partners Limited 22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di TOM COBLEIGH (INNS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al22 ago 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per TOM COBLEIGH (INNS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 gen 2018

    9 pagineLIQ03

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 feb 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL a Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street London WC2N 6JU in data 12 set 2017

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom a 48 Warwick Street London W1B 5NL in data 09 feb 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 12 gen 2017

    LRESSP

    Nomina di Lindsay Anne Keswick come segretario in data 25 apr 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Claire Susan Stewart come segretario in data 25 apr 2016

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ a Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT in data 07 mar 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 06 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 feb 2016

    Stato del capitale al 17 feb 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 22 ago 2015

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Lucy Jane Bell come amministratore in data 26 gen 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jonathan Robert Langford come amministratore in data 26 gen 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Daryl Antony Kelly come amministratore in data 26 gen 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Kirk Dyson Davis come amministratore in data 21 dic 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Henry Jones come segretario in data 04 dic 2015

    1 pagineTM02

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 24 ago 2016 al 30 apr 2016

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Patrick James Gallagher come amministratore in data 23 giu 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 06 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 feb 2015

    Stato del capitale al 09 feb 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 23 ago 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 feb 2014

    Stato del capitale al 07 feb 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Chi sono gli amministratori di TOM COBLEIGH (INNS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    Segretario
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    207524200001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    FREEMAN, Charles Truscott
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    British67008750001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180592780001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    PRATT, Kenneth Leslie Thomas
    Jubilee Lodge 7 Walnut Grove
    East Bridgford
    NG13 8NS Nottingham
    Segretario
    Jubilee Lodge 7 Walnut Grove
    East Bridgford
    NG13 8NS Nottingham
    British24300100006
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172445250001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181021510001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    THOMAS, Francis George Northcott
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    Segretario
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    British34191470001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Segretario
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    WATKINS, Simon Andrew
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    Segretario
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    British34048840002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164754670001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DE MIGUEL, Fiona Margaret
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    British42996540002
    DUFFILL, Clare Marianne
    27 Churston Close
    162-164 Tulse Hill
    SW2 3BX London
    Amministratore
    27 Churston Close
    162-164 Tulse Hill
    SW2 3BX London
    British71005690002
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    FREEMAN, Charles Truscott
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish67008750001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish170184800001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Amministratore
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritish47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86246470001
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135408140001
    MAPP, Derek
    Dunston Hole Farm Dunston Road
    Newbold
    S41 9RL Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    Dunston Hole Farm Dunston Road
    Newbold
    S41 9RL Chesterfield
    Derbyshire
    British12473610001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    MCQUARTER, Mark
    14 Townsend Drive
    AL3 5RQ St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    14 Townsend Drive
    AL3 5RQ St Albans
    Hertfordshire
    British57915140001
    PICKERSGILL, John Barry
    Vale House
    Bourne Close Blind Lane
    SL8 5NG Bourne End
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Vale House
    Bourne Close Blind Lane
    SL8 5NG Bourne End
    Buckinghamshire
    EnglandBritish6145910001
    PRATT, Kenneth Leslie Thomas
    Manor Farm Kirk Hill
    East Bridgford
    NG13 8PE Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Manor Farm Kirk Hill
    East Bridgford
    NG13 8PE Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish24300100007
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002
    RIKLIN, Cornel Carl
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    Amministratore
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    EnglandSwiss78412270001
    SEGAL, Richard Lawrence
    11 Holly Park
    Finchley
    N3 3JA London
    Amministratore
    11 Holly Park
    Finchley
    N3 3JA London
    British47031800002

    Chi sono le persone con controllo significativo di TOM COBLEIGH (INNS) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    06 apr 2016
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2673413
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TOM COBLEIGH (INNS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture
    Creato il 03 set 2000
    Consegnato il 15 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the beneficiaries under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H l/h land k/a bill brewer second avenue centrum 100 wellington road burton on trent t/no SF349440, joplins unit 30 low pavement chesterfield derbyshire t/no DY239637 and master locksmith meteor centre mansfield road derbyshire t/no DY203879 (for full details of all property charged see form 395) together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cibc World Markets PLC (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 15 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 apr 1995
    Consegnato il 02 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a guarantee and debenture dated 10 march 1994
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all that property k/as the bill brewer public house centrum 100 burton upon trent.t/no.SF349440.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 10 mar 1994
    Consegnato il 14 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of th e other companies named therein to the chargees under the terms of the facilities agereement and/or the swap agreements (each as defined therein)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Lenders and the Swap Counterparties as Defined Therein
    Transazioni
    • 14 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 mar 1994
    Consegnato il 14 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys standing to the credit of the accounts of the companies as per form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 ott 1993
    Consegnato il 20 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from the company & tom cobleigh PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The old queens head pond hill sheffield.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 set 1993
    Consegnato il 01 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or tom cobleigh PLC to the chargee
    Brevi particolari
    Master locksmith (formerly k/a the meteor centre)mansfield road derby.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 mag 1993
    Consegnato il 07 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from the company and tom cobleigh limited to the chargee
    Brevi particolari
    The red lion hotel market place doncaster south yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 mag 1993
    Consegnato il 15 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The waggon & horses,abbeydale rd,millhouses,sheffield.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 21 apr 1993
    Consegnato il 07 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from the company and the borrowers (as defined therein) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of the account or accounts of the company.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1993
    Consegnato il 12 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or tom cobleigh limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The crofts quarry hill mosborough sheffield.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 lug 1992
    Consegnato il 25 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany and/or tom cobleigh limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Joplins unit 30 the pavements chesterfield.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 mag 1992
    Consegnato il 22 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facilities agreement and/or any of the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    See 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 06 mag 1992
    Consegnato il 19 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from the company or any other group company to the chargee or any other member of the scottish & newcastle PLC group of companies under the terms of the facility agreement and/or any of the financing documents (as defined) and under or pursuant to the trading agreement
    Brevi particolari
    (For full details see form 395 tc ref: M198C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Scottish & Newcastle PLC
    Transazioni
    • 19 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TOM COBLEIGH (INNS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 gen 2017Inizio della liquidazione
    15 apr 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon Harris
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Praticante
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Ben David Woodthorpe
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Praticante
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0