NORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED

NORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02684941
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova NORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SIMCO 474 LIMITED06 feb 199206 feb 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di NORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per NORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Admiral Way Doxford International Business Park, Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP in data 14 set 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 04 set 2012

    LRESSP

    Nomina di Mr Kenneth Mcintyre Carlaw come amministratore in data 28 ago 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nigel Paul Featham come amministratore in data 28 ago 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Cocker come amministratore in data 28 ago 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Anthony Bowler come amministratore in data 28 ago 2012

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 26 mag 2012

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mag 2012

    Stato del capitale al 03 mag 2012

    • Capitale: GBP 210,002
    SH01

    Nomina di David Cocker come amministratore in data 19 mar 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David John Barry come amministratore in data 19 mar 2012

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Nomina di Nigel Paul Featham come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jonathan May come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Anthony Bowler il 04 mag 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David John Barry il 04 mag 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jonathan Paul May il 04 mag 2011

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 03 mag 2010

    1 pagineCH03

    Chi sono gli amministratori di NORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    Segretario
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    British102907000002
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    Amministratore
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    EnglandBritish161250030001
    LAUCHT, Robert Ian
    1 High Meadows, Church Lane
    Kirk Ella
    HU10 7NJ Hull
    East Riding Yorkshire
    Segretario
    1 High Meadows, Church Lane
    Kirk Ella
    HU10 7NJ Hull
    East Riding Yorkshire
    British13774020001
    RICHARDS, Lewis
    16 Dove House Lane
    B91 2EX Solihull
    West Midlands
    Segretario
    16 Dove House Lane
    B91 2EX Solihull
    West Midlands
    British2452070001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    WATSON, Kenneth James
    1 Portsmouth Place
    DL1 2XH Darlington
    County Durham
    Segretario
    1 Portsmouth Place
    DL1 2XH Darlington
    County Durham
    British29509590001
    SIMCO COMPANY SERVICES LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    West Yorkshire
    Segretario nominato
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    West Yorkshire
    900004040001
    BARRY, David John
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish132225520001
    BOWLER, Richard Anthony
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish35116070001
    COCKER, David
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish37574310001
    FEATHAM, Nigel Paul
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish161124990001
    GRACE, David Martin
    Woodhouse Back Lane
    Woolley
    WF4 2JT Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Woodhouse Back Lane
    Woolley
    WF4 2JT Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish27031320002
    HODGSON, Gordon William
    Bramble House
    Easington Lane
    DH5 0QX Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Bramble House
    Easington Lane
    DH5 0QX Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    British1108360001
    HODGSON, Kenneth
    The Grange Church Lane
    Elvington
    YO41 4HD York
    Amministratore
    The Grange Church Lane
    Elvington
    YO41 4HD York
    United KingdomBritish9946200002
    HUNTER, Michael John
    100 Manygates Lane
    Sandal
    WF2 7DP Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    100 Manygates Lane
    Sandal
    WF2 7DP Wakefield
    West Yorkshire
    British1058260002
    KERSLAKE, Brian John
    Oaklands
    Coppenhall
    ST18 9BW Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    Oaklands
    Coppenhall
    ST18 9BW Stafford
    Staffordshire
    British34169610003
    LAUCHT, Robert Ian
    1 High Meadows, Church Lane
    Kirk Ella
    HU10 7NJ Hull
    East Riding Yorkshire
    Amministratore
    1 High Meadows, Church Lane
    Kirk Ella
    HU10 7NJ Hull
    East Riding Yorkshire
    United KingdomBritish13774020001
    LEEDER, David John
    3 Juniper House
    140 Narrow Street
    E14 8BP London
    Amministratore
    3 Juniper House
    140 Narrow Street
    E14 8BP London
    EnglandBritish110562870001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Amministratore
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritish4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001
    MAY, Jonathan Paul
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish125675730002
    NOBLE, Stephen Leslie
    Brewery Close
    Stamfordham
    NE18 0PQ Northumberland
    Close House
    United Kingdom
    Amministratore
    Brewery Close
    Stamfordham
    NE18 0PQ Northumberland
    Close House
    United Kingdom
    United KingdomBritish128655430001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Amministratore
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    British58415290001
    RICHARDSON, Susan
    3 Woodside
    NE46 1HU Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    3 Woodside
    NE46 1HU Hexham
    Northumberland
    British62146850001
    WATSON, Kenneth James
    1 Portsmouth Place
    DL1 2XH Darlington
    County Durham
    Amministratore
    1 Portsmouth Place
    DL1 2XH Darlington
    County Durham
    EnglandBritish29509590001
    WHITE, Philip Michael
    25 Viceroy Close
    Bristol Road
    B5 7UR Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    25 Viceroy Close
    Bristol Road
    B5 7UR Birmingham
    West Midlands
    British5721830002
    WOOLNER, Andrew Edward
    Green Farm Back Lane
    Shustoke
    B46 2AP Coleshill
    Warwickshire
    Amministratore
    Green Farm Back Lane
    Shustoke
    B46 2AP Coleshill
    Warwickshire
    British45409730001
    SIMCO DIRECTOR A LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    West Yorkshire
    900004030001
    SIMCO DIRECTOR B LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    England
    Amministratore delegato nominato
    41 Park Square
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    England
    900004020001

    NORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 31 gen 1995
    Consegnato il 10 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bus depot caroline street bishop auckland title no DU168017,bus depot thorngate barnard castle durham title no DU166794,central workshop and headquarter offices morton road yarm road industrial estate darlington title no DU189820 tog with 23 various other properties. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 set 1994
    Consegnato il 15 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from dawntalk limited to the chargee on any account whatsoever and from the company undr the provisions of the charge
    Brevi particolari
    F/H land hereditaments and premises known as caroline street depot cockton hill bishop auckland durham together with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 set 1994
    Consegnato il 15 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due form dawntalk limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H land hereditaments and premises k/a land and buildings on the east side of boathouse lane stockton on tees cleveland together with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 set 1994
    Consegnato il 15 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from dawntalk limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the provisions of the charge
    Brevi particolari
    F/H land hereditaments and premises k/a land and bus depot at union street middlesbrough cleveland together with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 set 1994
    Consegnato il 15 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from dawntalk limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the provisions of the charge
    Brevi particolari
    F/H land hereditaments and premises k/a land and buildings to the west of waddington street durham together with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 set 1994
    Consegnato il 15 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from dawntalk limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the provisions of the charge
    Brevi particolari
    F/H land hereditaments and premises k/a land and buildings on the south side of davy drive north west industrial estate peterlee together with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 dic 1993
    Consegnato il 30 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from westcourt group limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Property k/a land and bildings on south of davy drive north west ind: est: peterlee t/n DU119600. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 dic 1993
    Consegnato il 30 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from westcourt group limited to the chargee on any account wharsoever and from the company under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Property k/a land and buildings on east of boathouse lane stockton-on-tees cleveland t/n CE96794. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 dic 1993
    Consegnato il 30 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from westcourt group limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Property k/a caroline street depot and warehouse seymour st. Cockton hill bishop aukland durham t/n DU168017. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 dic 1993
    Consegnato il 30 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from westcourt group limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Land and bus depot union street middlesborough cleveland t/n CE11928. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 dic 1993
    Consegnato il 30 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from westcourt group limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Property k/a land and buildings to west of waddington st. Durham t/n DU168088. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 08 dic 1993
    Consegnato il 13 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Transfer of whole and legal charge
    Creato il 24 mar 1992
    Consegnato il 13 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H propery k/a the travel enquiry office and toilets (ground floors only) at the bus station north road durham title no: DU76614.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Transfer of whole and legal charge
    Creato il 24 mar 1992
    Consegnato il 13 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a the information kiosk and land beneath at the new bus station between clayton and saddler street bishop auckland county durham.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Transfer of whole and legal charge
    Creato il 24 mar 1992
    Consegnato il 13 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land at and k/a the bus station feethams darlington county durham title no: DU166934.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Transfer of whole and legal charge
    Creato il 24 mar 1992
    Consegnato il 13 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a first floor offices at middlesborough bus station middlesborough.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Transfer of whole and legal charge
    Creato il 24 mar 1992
    Consegnato il 13 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a the staff canteen at new bus station between clayton and saddler streets bishop auckland county durham.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Transfer of whole and legal charge
    Creato il 24 mar 1992
    Consegnato il 13 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a first floor offices kitchen and canteen at middlesborough bus station new port road middlesborough title no: CE83893.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Transfer of whole and legal charge
    Creato il 24 mar 1992
    Consegnato il 13 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a shpo unit no.7 Being premises on ground floor of middlesborough bus station.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Transfer of whole and legal charge
    Creato il 24 mar 1992
    Consegnato il 13 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land and buildings to nth. West of ovenhope way peterlee title no: DU84160.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Transfer of whole and legal charge dated 23/03/1990
    Creato il 24 mar 1992
    Consegnato il 10 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal charge all/and every interest in the f/h land near to waddington street and shawwood,durham,county durham.t/no.du 168088.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Transfer of whole and legal charge dated 23/03/1990
    Creato il 24 mar 1992
    Consegnato il 10 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal charge all/and every interest in the f/h land at the corner of park street and firby lane,ripon,north yorkshire containing 1,444 sq.yds and four ninths of a square yard.t/no.nyk 100128.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Transfer of whole
    Creato il 24 mar 1992
    Consegnato il 10 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal charge all/and every interest in or over the f/h property k/a the bus depot situated in union street,derwent street,tay street and victoria street,middlesbrough,cleveland.t/no.ce 115928.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Transfer of whole
    Creato il 24 mar 1992
    Consegnato il 10 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal charge all/and every interest in the f/h land lying to the south and south west side of north road,durham city.t/nos.du 54876 and du 31915.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Transfer of whole and legal charge dated 23/03/1990
    Creato il 24 mar 1992
    Consegnato il 10 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal charge all/and every intest in the f/h land at bents foot,gayle, near hawes,north yorkshire.t/no.nyk 99504.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    NORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 apr 2013Data di scioglimento
    04 set 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Timothy Clay
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praticante
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praticante
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0