HOMEMALT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHOMEMALT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02686221
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HOMEMALT LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HOMEMALT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    17 Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HOMEMALT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRADVINE LIMITED11 feb 199211 feb 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di HOMEMALT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HOMEMALT LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per HOMEMALT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 gen 2014

    Stato del capitale al 17 gen 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Mrs Francesca Anne Todd come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Shearer come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 21 dic 2011

    • Capitale: GBP 2.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    1 pagineAA

    legacy

    4 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Risoluzioni

    Resolutions
    13 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Nomina di Mr Richard John Shearer come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Capita Group Secretary Limited come segretario

    2 pagineAP04

    Nomina di Capita Corporate Director Limited come amministratore

    2 pagineAP02

    Chi sono gli amministratori di HOMEMALT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    England
    Segretario
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2376959
    135207160001
    TODD, Francesca Anne
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish72249980002
    CAPITA CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    England
    Amministratore
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5641516
    129795770003
    BASHFORD, Howard
    Grovelands 22 Station Road
    Cholsey
    OX10 9PT Wallingford
    Oxfordshire
    Segretario
    Grovelands 22 Station Road
    Cholsey
    OX10 9PT Wallingford
    Oxfordshire
    British68140690003
    COSTER, Malcolm David
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    Segretario
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    British39034110001
    COTTRELL, Paul Alan
    16 Goldcrest Drive
    TN22 5QG Uckfield
    East Sussex
    Segretario
    16 Goldcrest Drive
    TN22 5QG Uckfield
    East Sussex
    British13754300002
    DUNN, Nigel Anthony
    The White Lodge 219 Melton Road
    Edwalton
    NG12 4AF Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    The White Lodge 219 Melton Road
    Edwalton
    NG12 4AF Nottingham
    Nottinghamshire
    British3835120001
    GREEN, Michael
    4 Potterton Close
    Barwick In Elmet
    LS15 4DY Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    4 Potterton Close
    Barwick In Elmet
    LS15 4DY Leeds
    West Yorkshire
    British9581830001
    HART, Darren
    9 Siskin Close
    Mickleover
    DE3 0UL Derby
    Derbyshire
    Segretario
    9 Siskin Close
    Mickleover
    DE3 0UL Derby
    Derbyshire
    British109555160001
    MCINTYRE, David
    Woodfield Park
    Colinton
    EH13 0RA Edinburgh
    65
    Scotland
    Segretario
    Woodfield Park
    Colinton
    EH13 0RA Edinburgh
    65
    Scotland
    146806480001
    SMITH, David
    Monks Way Hagg Nook Wood
    Newstead Abbey Park
    NG15 3GD Nottingham
    Notts
    Segretario
    Monks Way Hagg Nook Wood
    Newstead Abbey Park
    NG15 3GD Nottingham
    Notts
    British31420700001
    L & A SECRETARIAL LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Segretario nominato
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001450001
    ANDROLIA, Brian Melvin
    Draycott House
    Kempsey
    WR5 3NY Worcester
    Amministratore
    Draycott House
    Kempsey
    WR5 3NY Worcester
    EnglandBritish8975540001
    BASHFORD, Howard
    Grovelands 22 Station Road
    Cholsey
    OX10 9PT Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Grovelands 22 Station Road
    Cholsey
    OX10 9PT Wallingford
    Oxfordshire
    British68140690003
    BRADLEY, Michael John
    Vantage Point
    208 Henwick Road
    WR2 5PF Worcester
    Amministratore
    Vantage Point
    208 Henwick Road
    WR2 5PF Worcester
    British40818740003
    CHAMBERS, Mark Richard
    348 Goldington Road
    MK41 9NS Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    348 Goldington Road
    MK41 9NS Bedford
    Bedfordshire
    United KingdomBritish141463800001
    COSTER, Malcolm David
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    Amministratore
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    EnglandBritish39034110001
    DONOGHUE, William
    22 Ennismore Gardens
    Knightsbridge
    SW7 1AB London
    Amministratore
    22 Ennismore Gardens
    Knightsbridge
    SW7 1AB London
    United KingdomIrish98508020002
    DUNN, Nigel Anthony
    The White Lodge 219 Melton Road
    Edwalton
    NG12 4AF Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The White Lodge 219 Melton Road
    Edwalton
    NG12 4AF Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish3835120001
    GREEN, Michael
    4 Potterton Close
    Barwick In Elmet
    LS15 4DY Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    4 Potterton Close
    Barwick In Elmet
    LS15 4DY Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish9581830001
    MATTHEW, Gordon John
    Rogers Lane
    Ettrington
    CV37 3TA Stratford Upon Avon
    Saracens Yard
    Warwickshire
    Amministratore
    Rogers Lane
    Ettrington
    CV37 3TA Stratford Upon Avon
    Saracens Yard
    Warwickshire
    EnglandBritish151547160001
    MCINTYRE, David Stephen
    Woodfield Park
    Colinton
    EH13 0RA Edinburgh
    65
    Scotland
    Amministratore
    Woodfield Park
    Colinton
    EH13 0RA Edinburgh
    65
    Scotland
    United KingdomBritish107518360001
    SHEARER, Richard John
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    England
    Amministratore
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    England
    United KingdomBritish132651920002
    SMITH, David
    Monks Way Hagg Nook Wood
    Newstead Abbey Park
    NG15 3GD Nottingham
    Notts
    Amministratore
    Monks Way Hagg Nook Wood
    Newstead Abbey Park
    NG15 3GD Nottingham
    Notts
    British31420700001
    SMITH, Peter John
    73 Upton End Road
    Shillington
    SG5 3PE Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    73 Upton End Road
    Shillington
    SG5 3PE Hitchin
    Hertfordshire
    United KingdomBritish94974400001
    WINGFIELD, Richard Alan
    1 Town Farm Close
    Thame
    OX9 2DA Oxford
    Amministratore
    1 Town Farm Close
    Thame
    OX9 2DA Oxford
    EnglandBritish76932830002
    L & A REGISTRARS LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Amministratore delegato nominato
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001440001

    HOMEMALT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 02 dic 2005
    Consegnato il 20 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (The Noteholder)
    Transazioni
    • 20 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 02 dic 2005
    Consegnato il 15 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 02 dic 2005
    Consegnato il 15 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 21 dic 2000
    Consegnato il 09 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental guarantee and debenture between homemalt limited (the chargor), the data base (nottingham) limited & scart holdings limited (together "the charging companies") and skandinaviska enskilda banken ab (publ) (the security trustee)
    Creato il 13 gen 2000
    Consegnato il 31 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from the chargor to each beneficiary (as defined) under or pursuant to the senior finance documents (as defined) and all money and liablities due or to become due by each other company (except as guarantor for the chargor) under or pursuant to the senior finance documents
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 31 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0