LYME REGIS FINE FOODS LIMITED
Panoramica
Nome della società | LYME REGIS FINE FOODS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02687360 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LYME REGIS FINE FOODS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova LYME REGIS FINE FOODS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 4 The Switchback, Gardner Road SL6 7RJ Maidenhead England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di LYME REGIS FINE FOODS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per LYME REGIS FINE FOODS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Foxs Confectionery Ltd Sunningdale Road Braunstone Leicester LE3 1UE a 4 the Switchback, Gardner Road Maidenhead SL6 7RJ in data 22 feb 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Olli Ensio Mustonen il 07 gen 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 8 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 30 set 2016
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Antti Juhani Elevuori come amministratore in data 02 mar 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Olli Ensio Mustonen come amministratore in data 02 mar 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 gen 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Robert Davies come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robert Davies come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Antti Juhani Elevuori come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LYME REGIS FINE FOODS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSTONEN, Olli Ensio | Amministratore | The Switchback, Gardner Road SL6 7RJ Maidenhead 4 England | England | Finnish | Finance Director | 195706160002 | ||||
DAVIES, Robert Andrew | Segretario | Abbey Garth Abbey Road HG5 8HX Knaresborough North Yorkshire | British | Finance Director | 124176200002 | |||||
ZAKI, Luma | Segretario | 25 Hawkshill Way KT10 8LH Esher Surrey | British | 77380020002 | ||||||
ZAKI, Mohammed Abdul Wahid | Segretario | Speciality Clinics Centre Maamary Street FOREIGN Gefinor Beirut Lebanon | Lebanise | Doctor | 24213060003 | |||||
ZIPRIN, Geoffrey Charles | Segretario nominato | The Old Carters House 53 Chenies Village WD3 6EQ Bucks | British | 900001590001 | ||||||
DAVIES, Robert Andrew | Amministratore | Abbey Garth Abbey Road HG5 8HX Knaresborough North Yorkshire | England | British | Finance Director | 124176200002 | ||||
ELEVUORI, Antti Juhani | Amministratore | Bridge Road UB2 4AG Southall Honey Monster Foods Limited Middlesex United Kingdom | United Kingdom | Finnish | Finance Director | 182758350001 | ||||
POTTER, Irene | Amministratore delegato nominato | 55 Peel Place Clayhall Avenue IG5 0PT Ilford Essex | British | 900001600001 | ||||||
SIMMONDS, Paul Stuart | Amministratore | Applegarth Linton Common LS22 4JD Linton West Yorkshire | England | British | Director | 82048150001 | ||||
ZAKI, Alaa Abdul Wahid | Amministratore | 25 Hawks Hill Way KT10 8LH Esher Surrey | Great Britain | British | Businessman | 5814670003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LYME REGIS FINE FOODS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glisten Limited | 06 apr 2016 | Sunningdale Road Braunstone LE3 1UE Leicester Fox's Confectionery Limited England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
LYME REGIS FINE FOODS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Supplemental deed | Creato il 05 gen 2010 Consegnato il 08 gen 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of first fixed charge, all its right, title and interest in and to the trade marks lyme regis organic fruitus (wo) trade mark no:2272421. Fruitus fruitful by nature (with logo) trade mark no:7051048. Fruitus trade mark no:7011604. For details of further trade marks charged please refer to form MG01. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Memorandum of deposit of stocks and shares | Creato il 12 dic 2005 Consegnato il 16 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The stocks shares bonds debentures or other securities deposited with the bank or trustee or nominees of the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 12 dic 2005 Consegnato il 16 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 22 lug 2002 Consegnato il 25 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 17 nov 1995 Consegnato il 21 nov 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 05 mag 1995 Consegnato il 11 mag 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 14 lug 1992 Consegnato il 24 lug 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0