ICAP HYDE HOLDINGS LIMITED

ICAP HYDE HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàICAP HYDE HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02689453
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ICAP HYDE HOLDINGS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ICAP HYDE HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Kpmg Llp 15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ICAP HYDE HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HYDE HOLDINGS LIMITED05 nov 199605 nov 1996
    J.E.H. LIMITED20 feb 199220 feb 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di ICAP HYDE HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per ICAP HYDE HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:secretary of state's release of liquidator
    1 pagineLIQ MISC

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order INSOLVENCY:re block transfer replacement of liq
    30 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Nomina di Deborah Anne Abrehart come amministratore in data 01 set 2016

    3 pagineAP01

    Nomina di David Charles Ireland come amministratore in data 01 set 2016

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Lucy Rachel Mayhew come amministratore in data 01 set 2016

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nicholas James Dargan come amministratore in data 01 set 2016

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Anthony Casterton come amministratore in data 01 set 2016

    2 pagineTM01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 dic 2015

    4 pagine4.68

    Cessazione della carica di Henry Grainger Liddell come amministratore in data 01 apr 2015

    2 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB a Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL in data 10 apr 2015

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Broadgate London EC2M 7UR a 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB in data 13 gen 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 19 dic 2014

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Bilancio annuale redatto al 17 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 feb 2014

    Stato del capitale al 04 feb 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    12 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Henry Grainger Liddell il 06 lug 2013

    2 pagineCH01

    Nomina di Nicholas James Dargan come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Samantha Wren come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 17 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    20 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ICAP HYDE HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAVANAGH, Teri-Anne
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Segretario
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    South African98738710010
    ABREHART, Deborah Anne
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    Amministratore
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish3219400009
    IRELAND, David Charles
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    Amministratore
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    EnglandBritish163102630001
    GROVE, William Hulbert
    Spring Close
    Millers Lane, Outwood
    RH1 5PZ Redhill
    Surrey
    Segretario
    Spring Close
    Millers Lane, Outwood
    RH1 5PZ Redhill
    Surrey
    British73604420001
    LEE, Lesley Jane
    Bankside The Close
    GU7 1PQ Godalming
    Surrey
    Segretario
    Bankside The Close
    GU7 1PQ Godalming
    Surrey
    British33109260002
    MURRAY, Shona
    55 Dorchester Avenue
    HA2 7AX Harrow
    Middlesex
    Segretario
    55 Dorchester Avenue
    HA2 7AX Harrow
    Middlesex
    British71311260001
    WEBSTER, Peter James
    13 Calverton
    Albany Road
    SE5 0AP London
    Segretario
    13 Calverton
    Albany Road
    SE5 0AP London
    British50014310003
    WHITWELL, John Gordon Robson
    24 Military Road
    CO1 2AJ Colchester
    Essex
    Segretario
    24 Military Road
    CO1 2AJ Colchester
    Essex
    British65531480001
    AHRENS, Christopher Robert
    Bothy Cottage
    2 Plaw Hatch Lane
    RH19 4JL Sharpthorne
    Amministratore
    Bothy Cottage
    2 Plaw Hatch Lane
    RH19 4JL Sharpthorne
    British74062450002
    BURROWS, Anthony Richard Brocas
    Barham Hall
    Church Lane Barham
    IP6 0PT Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    Barham Hall
    Church Lane Barham
    IP6 0PT Ipswich
    Suffolk
    United KingdomBritish1570960001
    CASTERTON, David Anthony
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Amministratore
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    United KingdomBritish221477890001
    DARGAN, Nicholas James
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    Amministratore
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    EnglandBritish298810620001
    DAVIS, Ian Charles
    30 Field Stile Road
    IP18 6LD Southwold
    Suffolk
    Amministratore
    30 Field Stile Road
    IP18 6LD Southwold
    Suffolk
    British16378990001
    GROVE, William Hulbert
    Spring Close
    Millers Lane, Outwood
    RH1 5PZ Redhill
    Surrey
    Amministratore
    Spring Close
    Millers Lane, Outwood
    RH1 5PZ Redhill
    Surrey
    EnglandBritish73604420001
    HARRISON, Simon Nicholas Ian
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Amministratore
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    EnglandBritish59864540003
    HOLLYER, Nigel
    99 Pinewood Avenue
    RG45 6RQ Crowthorne
    Berkshire
    Amministratore
    99 Pinewood Avenue
    RG45 6RQ Crowthorne
    Berkshire
    British65676500001
    KIDD, Timothy Charles
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Amministratore
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    EnglandBritish117842820001
    LEE, Carlton Millhouse
    Bankside The Close
    GU7 1PQ Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Bankside The Close
    GU7 1PQ Godalming
    Surrey
    British36055910001
    LEE, Lesley Jane
    Bankside The Close
    GU7 1PQ Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Bankside The Close
    GU7 1PQ Godalming
    Surrey
    British33109260002
    LIDDELL, Henry Grainger
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    Amministratore
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish34376200006
    MATHEWS, Robert Malcolm
    12 Augustas Way
    CM8 1HH Witham
    Essex
    Amministratore
    12 Augustas Way
    CM8 1HH Witham
    Essex
    British35862010001
    MAYHEW, Lucy Rachel
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Amministratore
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    United KingdomBritish151929170001
    NEWMAN, Paul
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Amministratore
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    EnglandBritish213629960001
    PARHAM, Gordon Harold
    Little Court
    Shackleford
    GU8 6AH Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Little Court
    Shackleford
    GU8 6AH Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish16854980001
    PARK, Richard Wells
    29 Ferguson Close
    E14 3SH London
    Amministratore
    29 Ferguson Close
    E14 3SH London
    British71578270001
    SILVE, Jacques Henri
    63 Chesson Road
    W14 9QS London
    Amministratore
    63 Chesson Road
    W14 9QS London
    French41019840001
    WEBSTER, Peter James
    13 Calverton
    Albany Road
    SE5 0AP London
    Amministratore
    13 Calverton
    Albany Road
    SE5 0AP London
    United KingdomBritish50014310003
    WREN, Samantha Anne
    2 Broadgate
    London
    EC2M 7UR
    Amministratore
    2 Broadgate
    London
    EC2M 7UR
    EnglandBritish155853230001

    ICAP HYDE HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of debt
    Creato il 07 apr 1999
    Consegnato il 10 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    £300,000 due from braemar tankers LTD.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 apr 1999
    Consegnato il 09 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of debt
    Creato il 07 apr 1999
    Consegnato il 09 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    £90,000 due from simpson spence and young shipbrokers LTD.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 17 ott 1996
    Consegnato il 24 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ICAP HYDE HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 apr 2017Data di scioglimento
    19 dic 2014Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praticante
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0