HHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED

HHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02689482
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Ldh House St Ives Business Park
    Parsons Green
    PE27 4AA St. Ives
    Cambridgeshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RELAXION SPLASH LIMITED20 feb 199220 feb 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di HHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per HHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 feb 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 feb 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 feb 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 feb 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 10 mag 2016

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 mar 2016

    Stato del capitale al 15 mar 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 feb 2015

    Stato del capitale al 24 feb 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Leisure Connection Limited Potton House Great North Road Wyboston Bedford MK44 3BA a Ldh House St Ives Business Park Parsons Green St. Ives Cambridgeshire PE27 4AA in data 22 ott 2014

    1 pagineAD01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 19 set 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Nomina di Mr Ian Arthur Hendrie come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Richard Still come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Richard Still come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di HHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HENDRIE, Ian Arthur
    St Ives Business Park
    Parsons Green
    PE27 4AA St. Ives
    Ldh House
    Cambridgeshire
    England
    Segretario
    St Ives Business Park
    Parsons Green
    PE27 4AA St. Ives
    Ldh House
    Cambridgeshire
    England
    187265810001
    HENDRIE, Ian Arthur
    St Ives Business Park
    Parsons Green
    PE27 4AA St. Ives
    Ldh House
    Cambridgeshire
    England
    Amministratore
    St Ives Business Park
    Parsons Green
    PE27 4AA St. Ives
    Ldh House
    Cambridgeshire
    England
    United KingdomBritish123762920001
    NICHOLLS, Julian Frederick
    St Ives Business Park
    Parsons Green
    PE27 4AA St. Ives
    Ldh House
    Cambridgeshire
    England
    Amministratore
    St Ives Business Park
    Parsons Green
    PE27 4AA St. Ives
    Ldh House
    Cambridgeshire
    England
    EnglandBritish95086050001
    JONES, John Graham
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    British35569170001
    RING, Robert William
    The Common
    Kinsbourne Green
    AL5 3NT Harpenden
    Pinewood
    Herts
    Segretario
    The Common
    Kinsbourne Green
    AL5 3NT Harpenden
    Pinewood
    Herts
    British29354920001
    STILL, Richard Matthew
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    British71581460002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CAMPBELL, Paul Adam
    4 Estelle Road
    Hampstead
    NW3 2JY London
    Amministratore
    4 Estelle Road
    Hampstead
    NW3 2JY London
    British53606250001
    DANIELS, Colin
    Brooklands
    313 Batley Road
    WF2 0AP Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Brooklands
    313 Batley Road
    WF2 0AP Wakefield
    West Yorkshire
    British1278190001
    GOLDING, Nigel William George
    3 Lynwood Green
    SS6 7NE Rayleigh
    Essex
    Amministratore
    3 Lynwood Green
    SS6 7NE Rayleigh
    Essex
    British12415930002
    JONES, John Graham
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    British35569170001
    MCGINLEY, John Francis
    The Hedges
    Delmerend Lane
    AL3 8ER Flamstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Hedges
    Delmerend Lane
    AL3 8ER Flamstead
    Hertfordshire
    British8525250001
    MEEHAN, Paul Alan
    House, Park Farm
    Newton Hall Lane Mobberley
    WA16 7LQ Knutsford
    The Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    House, Park Farm
    Newton Hall Lane Mobberley
    WA16 7LQ Knutsford
    The Farm
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish130608590001
    MELLOR, David Glynn
    Fieldhead
    92 Victoria Road
    HX5 0QF Elland
    West Yorkshire
    Amministratore
    Fieldhead
    92 Victoria Road
    HX5 0QF Elland
    West Yorkshire
    EnglandBritish57198790001
    RING, Robert William
    The Common
    Kinsbourne Green
    AL5 3NT Harpenden
    Pinewood
    Herts
    Amministratore
    The Common
    Kinsbourne Green
    AL5 3NT Harpenden
    Pinewood
    Herts
    EnglandBritish29354920001
    SMITH, Russell Stansfield
    Woodcliffe Underwood Drive
    Rawdon
    LS19 6LA Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Woodcliffe Underwood Drive
    Rawdon
    LS19 6LA Leeds
    West Yorkshire
    British809230001
    STILL, Richard Matthew
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Danoptra Limited
    West Yorkshire
    Amministratore
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Danoptra Limited
    West Yorkshire
    United KingdomBritish71581460002
    STILL, Richard Matthew
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish71581460002
    DANOPTRA DIRECTOR I LIMITED
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    Low Lane
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Yorkshire
    125899680001
    DANOPTRA DIRECTOR II LIMITED
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Low Lane
    Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Horsforth
    LS18 4ER Leeds
    Low Lane
    Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02689482
    125899730001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per HHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    20 feb 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    HHL (DORMANT COMPANIES) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 16 apr 1997
    Consegnato il 22 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 14 mar 1996
    Consegnato il 26 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 05 apr 1994
    Consegnato il 12 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 12 mag 1993
    Consegnato il 19 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 01 ago 1992
    Consegnato il 20 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a contract bond for £23,385 to south norfolk district council dated 1ST august 1992
    Brevi particolari
    The sum of £23,385 together with interest accrued now or to be held by the chargee on an account numbered 45124787 and earmarked by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balance
    Creato il 02 apr 1992
    Consegnato il 08 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to performance bond dated 28/2/92 in favour of council of the district of east northamptonshire. The sum of £54,000 only
    Brevi particolari
    The sum of £54,000 together with interest accrued now or to be held by the chargee on an account numbered 7697988 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 27 feb 1992
    Consegnato il 09 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to performance bond dated 29/02/92 in favour of council of the district of east northamptonshire in respect of contract for the management of rushden and thrapston swimming pools
    Brevi particolari
    The sum of £54,000 together with interest accrued now or to be held by the chargee on an account numbered 7697988 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0