THOMAS TUCKER LIMITED

THOMAS TUCKER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHOMAS TUCKER LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02690618
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di THOMAS TUCKER LIMITED?

    • Produzione di confetteria allo zucchero (10822) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova THOMAS TUCKER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Forvis Mazars Llp
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THOMAS TUCKER LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TOMMY TUCKER LIMITED09 mag 200109 mag 2001
    MARKETING GOODS AGENCY LIMITED25 feb 199225 feb 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di THOMAS TUCKER LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2019
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2020
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per THOMAS TUCKER LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al07 feb 2020
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma21 feb 2020
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al07 feb 2019
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per THOMAS TUCKER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 ott 2024

    19 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 30 Old Bailey London EC4M 7AU a Forvis Mazars Llp 30 Old Bailey London EC4M 7AU in data 26 lug 2024

    3 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 ott 2023

    18 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 ott 2022

    23 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Tower Bridge House St Katharine's Way London E1W 1DD a 30 Old Bailey London EC4M 7AU in data 11 mag 2022

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 ott 2021

    19 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    37 pagineAM22

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    40 pagineAM10

    Risultato della riunione dei creditori

    7 pagineAM07

    Soddisfazione dell'onere 026906180015 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 026906180014 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    58 pagineAM03

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    15 pagineAM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 1 & 2 Target Park Houghton Road North Anston Sheffield S25 4JJ England a Tower Bridge House St Katharine's Way London E1W 1DD in data 04 ott 2019

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    5 pagineAM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    25 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 026906180018 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 026906180021, creata il 22 lug 2019

    63 pagineMR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    25 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 feb 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 026906180020 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 026906180017 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 026906180020, creata il 04 lug 2018

    18 pagineMR01

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 2 Coach Crescent Shireoaks Triangle Worksop Nottinghamshire S81 8AD a Unit 1 & 2 Target Park Houghton Road North Anston Sheffield S25 4JJ in data 30 apr 2018

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di THOMAS TUCKER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GREGG, Paul Richard
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Forvis Mazars Llp
    Amministratore
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Forvis Mazars Llp
    EnglandBritishCompany Director5337340008
    HOLGATE, Barbara Ann
    Park Farm Main Street
    Hayton
    DN22 9LF Retford
    Nottinghamshire
    Segretario
    Park Farm Main Street
    Hayton
    DN22 9LF Retford
    Nottinghamshire
    British6253940001
    MARSH, Joyce Katherine
    Timberville South View Drive
    Clarborough
    DN22 9JY Retford
    Nottinghamshire
    Segretario
    Timberville South View Drive
    Clarborough
    DN22 9JY Retford
    Nottinghamshire
    British63810000001
    PLANT, Stephen
    2 Ashbourne Road
    Hazel Grove
    SK7 6DX Stockport
    Cheshire
    Segretario
    2 Ashbourne Road
    Hazel Grove
    SK7 6DX Stockport
    Cheshire
    British77227740001
    STANHAM, Simon Peter
    Unit 2 Coach Crescent
    Shireoaks Triangle
    S81 8AD Worksop
    Nottinghamshire
    Segretario
    Unit 2 Coach Crescent
    Shireoaks Triangle
    S81 8AD Worksop
    Nottinghamshire
    British116557350001
    APTGATE LIMITED
    82 Well Hall Road
    Eltham
    SE9 6SL London
    Segretario
    82 Well Hall Road
    Eltham
    SE9 6SL London
    5363580001
    CHEETHAM, Scott Anthony
    Park Lodge
    Gibbets Lane
    DH10 6BQ Bawtry
    Notts
    Amministratore
    Park Lodge
    Gibbets Lane
    DH10 6BQ Bawtry
    Notts
    BritishSales Director30322560002
    CHESLYN CURTIS, Barbara Ann
    The Old Barn
    Retford Road, South Leverton
    DN22 0BY Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The Old Barn
    Retford Road, South Leverton
    DN22 0BY Retford
    Nottinghamshire
    BritishHorologist6253940003
    CHESLYN-CHRTIS, Barbara Hardwick
    129 Jubilee Road
    DN22 7PF Retford
    Notts
    Amministratore
    129 Jubilee Road
    DN22 7PF Retford
    Notts
    BritishPromotional Consultant19928390001
    GREGG, David Simon
    Unit 2 Coach Crescent
    Shireoaks Triangle
    S81 8AD Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Unit 2 Coach Crescent
    Shireoaks Triangle
    S81 8AD Worksop
    Nottinghamshire
    EnglandBritishManaging Director98332960002
    GREGG, Paul Richard
    12 Elystan Street
    Chelsea
    SW3 3PP London
    Flat 47 Crown Lodge
    Uk
    Amministratore
    12 Elystan Street
    Chelsea
    SW3 3PP London
    Flat 47 Crown Lodge
    Uk
    United KingdomBritishNone116557340007
    ROSE, Leslie
    Stanrick House
    38 Totteridge Village
    N20 8JN London
    Amministratore
    Stanrick House
    38 Totteridge Village
    N20 8JN London
    United KingdomBritishCompany Director75923830001
    STANHAM, Simon Peter
    Unit 2 Coach Crescent
    Shireoaks Triangle
    S81 8AD Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Unit 2 Coach Crescent
    Shireoaks Triangle
    S81 8AD Worksop
    Nottinghamshire
    EnglandBritishAccountant116557350001
    WILLIAMS, Colin Herbert
    1 Crowtrees Grove
    Roughlee
    BB9 6NE Nelson
    Lancashire
    Amministratore
    1 Crowtrees Grove
    Roughlee
    BB9 6NE Nelson
    Lancashire
    EnglandBritishAccountant93907120001

    Chi sono le persone con controllo significativo di THOMAS TUCKER LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Coach Crescent
    Shireoaks
    S81 8AD Worksop
    Unit 2
    England
    06 apr 2016
    Coach Crescent
    Shireoaks
    S81 8AD Worksop
    Unit 2
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04016531
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    THOMAS TUCKER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 22 lug 2019
    Consegnato il 01 ago 2019
    In corso
    Breve descrizione
    4.1 each chargor, as continuing security for the payment, discharge and performance of all the secured obligations in relation to all of the following assets whether now or in the future belonging to that chargor hereby, in each case with full title guarantee. (A) fixed charges: charges to igf by way of separate fixed charges:. I. By way of legal mortgage each property specified in schedule 2 which is set opposite its name. Ii. By way of equitable mortgage its real property, other than property or properties specified in schedule 2;. vi. All its intellectual property. .
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Igf Business Credit Limited
    Transazioni
    • 01 ago 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 04 lug 2018
    Consegnato il 05 lug 2018
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 14 set 2017
    Consegnato il 21 set 2017
    In corso
    Breve descrizione
    None.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 21 set 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 12 mag 2014
    Consegnato il 14 mag 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank Commercial Finance LTD
    Transazioni
    • 14 mag 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 set 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 03 dic 2013
    Consegnato il 12 dic 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    L/H of the candy-pop factory hallcot industrial estate coach crescent shireoaks triangle worksop. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 12 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 03 dic 2013
    Consegnato il 12 dic 2013
    In corso
    Breve descrizione
    F/H of unit at aurillac hallcroft industrial estate retford. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 12 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 ott 2013
    Consegnato il 09 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 26 nov 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 25 ott 2013
    Consegnato il 09 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 26 nov 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    All assets debenture
    Creato il 10 mag 2010
    Consegnato il 11 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 11 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2007
    Consegnato il 14 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit at hallcroft industrial estate retford. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 30 mag 2007
    Consegnato il 01 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    6 x popcorn kettles s/no's 101-106. sifter 115. conveyer line 1 113. packing table line 1 117.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 01 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 24 mag 2007
    Consegnato il 26 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The candy - pop factory coach crescent shireoaks triangle worksop notts. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 feb 2007
    Consegnato il 27 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattels mortgage
    Creato il 25 ott 2005
    Consegnato il 04 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule being 2 popcorn production line consisting of popcorn line 1: kettle 1 s/n 101 kettle 2 s/n 102 kettle 3 s/n 103 kettle 4 s/n 104 kettle 5 s/n 105 kettle 6 s/n 106 sifter s/n 115 for further details of equipment charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited (Hsbc)
    Transazioni
    • 04 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 giu 2004
    Consegnato il 23 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The buildings, land and premises at unit 2, coach crescent, shireoaks triangle estate, worksop t/no NT396158.
    Persone aventi diritto
    • Nottinghamshire County Council
    Transazioni
    • 23 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 giu 2004
    Consegnato il 23 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due (including the principal sum of £150,000) from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nottinghamshire County Council
    Transazioni
    • 23 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 13 mag 2004
    Consegnato il 14 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All chattels plant, machinery and things described in the schedule including : 12 x ringmaster 7" s/n 03125934, 3125935, 3125936, 03125937, 03125938, 03125939, 031325940, 03125941, 03125942, 03125943, 013125944 and 03125945, ringmaster 7" s/N0 3105202, voltage control export part number 3696-e, for further details of chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 14 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 11 feb 2004
    Consegnato il 13 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property known as unit 2 coach crescent shireoaks triangle estate worksop. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 set 2000
    Consegnato il 05 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 1997
    Consegnato il 14 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £10,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    3 x 3802 cretors popping machines serial numbers: 88115562 91083239 92114655 1 x wrights monobag fill machine 821.
    Persone aventi diritto
    • North Nottinghamshire Training & Enterprise Council Limited
    Transazioni
    • 14 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 22 apr 1993
    Consegnato il 29 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    THOMAS TUCKER LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 set 2019Inizio dell'amministrazione
    07 ott 2020Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Adam Harris
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Patrick Alexander Lannagan
    Mazars Llp One St Peters Square
    M2 3DE Manchester
    Praticante
    Mazars Llp One St Peters Square
    M2 3DE Manchester
    2
    DataTipo
    07 ott 2020Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Adam Harris
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Patrick Alexander Lannagan
    Mazars Llp One St Peters Square
    M2 3DE Manchester
    Praticante
    Mazars Llp One St Peters Square
    M2 3DE Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0