HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED

HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHIGHWAY (BURNLEY) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02693859
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?

    • (8514) /

    Dove si trova HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Craegmoor House
    Perdiswell Park
    WR3 7NW Worcestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRIAN CHRISTOPHER PROPERTY LIMITED16 apr 199216 apr 1992
    BANDNAME LIMITED05 mar 199205 mar 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di David Manson come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David James Hall come segretario

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Philip Henry Scott come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Jason David Lock come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Matthew Franzidis come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Scott Morrison come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Albert Smith come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christine Cameron come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Julian Ball come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 05 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 mar 2011

    Stato del capitale al 30 mar 2011

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    16 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine353a

    legacy

    1 pagine190a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HALL, David James
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    159660530001
    FRANZIDIS, Matthew
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandUk129251300001
    LOCK, Jason David
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish144822040001
    SCOTT, Philip Henry
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish174231320001
    CHRISTOPHER, Brian John
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    Segretario
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    British18037120001
    CHRISTOPHER, Richard Robert Edward
    9 Millcombe Way
    Walton Le Dale
    PR5 4NB Preston
    Lancashire
    Segretario
    9 Millcombe Way
    Walton Le Dale
    PR5 4NB Preston
    Lancashire
    British54424700002
    MORRISON, Scott
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    British99297890001
    BLG (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED
    7th Floor Beaufort House
    15 St Botolph Street
    EC3A 7NJ London
    Segretario
    7th Floor Beaufort House
    15 St Botolph Street
    EC3A 7NJ London
    39680630001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANDREWS, Carole
    155 Watermoor Road
    GL7 1LF Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    155 Watermoor Road
    GL7 1LF Cirencester
    Gloucestershire
    British102238960001
    BALL, Julian Charles
    Mill Fleam
    Hilton
    DE65 5HE Derby
    14
    Derbyshire
    Amministratore
    Mill Fleam
    Hilton
    DE65 5HE Derby
    14
    Derbyshire
    EnglandBritish138044110001
    CAMERON, Charles Donald Ewen
    Orchard Manor
    Church Lane Martin Hussingtree
    WR3 8TQ Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Orchard Manor
    Church Lane Martin Hussingtree
    WR3 8TQ Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish113187140001
    CAMERON, Christine Isabel
    10 Mount Crescent
    HR1 NQ1 Hereford
    Amministratore
    10 Mount Crescent
    HR1 NQ1 Hereford
    EnglandBritish163745150001
    CAVANAGH, Peter Kenneth
    8 Fir Grove
    Paddington
    WA1 3JF Warrington
    Amministratore
    8 Fir Grove
    Paddington
    WA1 3JF Warrington
    British114627410002
    CHRISTOPHER, Barbara Ruth
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    Amministratore
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    British18037140001
    CHRISTOPHER, Brian John
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    Amministratore
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    British18037120001
    CHRISTOPHER, Richard Robert Edward
    9 Millcombe Way
    Walton Le Dale
    PR5 4NB Preston
    Lancashire
    Amministratore
    9 Millcombe Way
    Walton Le Dale
    PR5 4NB Preston
    Lancashire
    British54424700002
    HILL, Margaret
    11 Pear Tree Close
    Hollingsworth
    S43 2LU Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    11 Pear Tree Close
    Hollingsworth
    S43 2LU Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritish102587360001
    KAY, Allyson
    12 Folks Wood Way
    Stone Street Lympne
    CT21 4EW Hythe
    Kent
    Amministratore
    12 Folks Wood Way
    Stone Street Lympne
    CT21 4EW Hythe
    Kent
    British93464240001
    KEATING, Denise Elizabeth
    62 Church Street
    Cogenhoe
    NN7 1LS Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    62 Church Street
    Cogenhoe
    NN7 1LS Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish111513540001
    MANSON, David Lindsay
    111 Lodge Road
    Knowle
    B93 0HG Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    111 Lodge Road
    Knowle
    B93 0HG Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish126071210001
    NEWHAM, Pamela Maria
    Rowan Cottage
    38 Reedley Road Reedley
    BB10 2LU Burnley
    Lancashire
    Amministratore
    Rowan Cottage
    38 Reedley Road Reedley
    BB10 2LU Burnley
    Lancashire
    British69690300002
    SAVILLE, Richard Cyril Campbell
    Fairings
    Valley Way
    SL9 7PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Fairings
    Valley Way
    SL9 7PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish38530070001
    SMITH, Albert Edward
    Flint House
    Froxfield
    SN8 3JY Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Flint House
    Froxfield
    SN8 3JY Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritish77631340001
    SPURLING, Julian Neville Guy
    Foundry House
    GU35 9LY Kingsley
    Hampshire
    Amministratore
    Foundry House
    GU35 9LY Kingsley
    Hampshire
    EnglandBritish110225070001
    STRATFORD, Michael Anthony
    10 Anne Hathaway Drive
    GL3 2PX Churchdown
    Gloucestershire
    Amministratore
    10 Anne Hathaway Drive
    GL3 2PX Churchdown
    Gloucestershire
    United KingdomBritish38853720002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession and charge acceeding to the debenture dated 18 july 2008 and
    Creato il 02 ott 2008
    Consegnato il 08 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The acquisition agreement claims all rights in respect of the insurance policies, the hedging agreements, any structural intra group loans fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 08 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 set 2007
    Consegnato il 26 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal mortgage
    Creato il 11 mar 2006
    Consegnato il 21 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    3 talbot street burnley t/n LA486809,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal mortgage
    Creato il 11 mar 2006
    Consegnato il 21 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property being 3 talbot street burnley t/n LA486809,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Lenders)
    Transazioni
    • 21 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 11 mar 2006
    Consegnato il 21 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (Security Agent)
    Transazioni
    • 21 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 31 dic 2004
    Consegnato il 06 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from craegmoor homes limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 ott 2003
    Consegnato il 06 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 ott 2003
    Consegnato il 06 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 ott 2003
    Consegnato il 06 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from craegmoor homes limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 26 feb 1999
    Consegnato il 05 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 mar 1993
    Consegnato il 13 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 30 talbot street burnley inc: fixtuer and fittings title no: LA485170. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0