VECTOR INVESTMENTS LIMITED

VECTOR INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVECTOR INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02693876
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    • Locazione e gestione di immobili di società di edilizia residenziale (68201) / Attività immobiliari

    Dove si trova VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O INTERPATH LTD
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BEFOREKEEP LIMITED05 mar 199205 mar 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    17 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 dic 2023

    17 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 dic 2022

    18 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    104 pagineLIQ10

    Indirizzo della sede legale modificato da 10 Fleet Place London EC4M 7QS a 10 Fleet Place London EC4M 7RB in data 01 lug 2022

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 16 Palace Street London England SW1E 5JQ a 10 Fleet Place London EC4M 7QS in data 04 gen 2022

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 13 dic 2021

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 set 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    9 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 set 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 set 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 set 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017

    18 pagineAA

    Nomina di Khwaja Kamran Shah come amministratore in data 09 apr 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Rashidi Olugbenga Keshiro come amministratore in data 09 apr 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016

    22 pagineAA

    Cessazione della carica di Guat Hoon (Known as Christina) Ong come amministratore in data 06 ott 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MUHAMMAD, Junaid Muhammad Rahimullah
    Level 15,
    Sheikh Zayed Road
    P.O. BOX 17000 Dubai
    Conrad Building
    United Arab Emirates
    Amministratore
    Level 15,
    Sheikh Zayed Road
    P.O. BOX 17000 Dubai
    Conrad Building
    United Arab Emirates
    United Arab EmiratesPakistani214227180001
    SHAH, Khwaja Kamran
    0000 Discovery Gardens
    Apt 204 Building 107
    United Arab Emirates
    Amministratore
    0000 Discovery Gardens
    Apt 204 Building 107
    United Arab Emirates
    United Arab EmiratesPakistani245280080001
    COOMBE, Cynthia Mary
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    Segretario
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    155194520001
    HOWARD, Albert Larry
    Highlands
    15 Vernon Road
    SS9 2NG Leigh On Sea
    Essex
    Segretario
    Highlands
    15 Vernon Road
    SS9 2NG Leigh On Sea
    Essex
    British73770040001
    HUDSON, Alan Edmund Wilchen
    79 Porchfield Square
    St John's Gardens
    M3 4FG Manchester
    Segretario
    79 Porchfield Square
    St John's Gardens
    M3 4FG Manchester
    British38798810002
    JONES, Roger Kenneth
    41 Townscliffe Lane
    Marple Bridge
    SK6 5AP Stockport
    Cheshire
    Segretario
    41 Townscliffe Lane
    Marple Bridge
    SK6 5AP Stockport
    Cheshire
    British11127840001
    MCCAUSLAND, Siobhan Mary
    64 Shawdene Road
    M22 4AL Manchester
    Lancashire
    Segretario
    64 Shawdene Road
    M22 4AL Manchester
    Lancashire
    British2583820001
    MOORE, Michael Anthony
    17 Pine Road
    Didsbury
    M20 6UY Manchester
    Lancashire
    Segretario
    17 Pine Road
    Didsbury
    M20 6UY Manchester
    Lancashire
    British4609510001
    PARKINSON, Evelyn
    53 Tyrer Road
    WA12 8SP Newton Le Willows
    Merseyside
    Segretario
    53 Tyrer Road
    WA12 8SP Newton Le Willows
    Merseyside
    British9842960001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALUISI, Patricia Ann
    76 Cadogan Place
    SW1X 9RP London
    Amministratore
    76 Cadogan Place
    SW1X 9RP London
    American23362430001
    BARNETT, Ian Gregory Howie
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    Amministratore
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    United KingdomBritish11591280001
    BATE, Dennis
    109 Carmill Road
    Billinge
    WN5 7TY Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    109 Carmill Road
    Billinge
    WN5 7TY Wigan
    Lancashire
    British28569910001
    BEVERTON, John Davey
    29 Eaton Square
    SW1 9DF London
    Amministratore
    29 Eaton Square
    SW1 9DF London
    British7646360002
    BROOKS, Gary
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    Amministratore
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    United KingdomBritish108919970001
    CHARLTON, Richard Wingate Edward
    8 Fernshaw Road
    SW10 0TF London
    Amministratore
    8 Fernshaw Road
    SW10 0TF London
    United KingdomBritish15470710001
    CORSER, Raymond Bidlake
    Robinswood 1 Dashwood Close
    West Byfleet
    KT14 6QH Wey Bridge
    Surrey
    Amministratore
    Robinswood 1 Dashwood Close
    West Byfleet
    KT14 6QH Wey Bridge
    Surrey
    British55914130002
    FLETCHER, Angus Howard
    Lees Heights
    OX7 3EZ Charlbury
    9
    United Kingdom
    Amministratore
    Lees Heights
    OX7 3EZ Charlbury
    9
    United Kingdom
    United KingdomBritish65254010001
    HOWARD, Albert Larry
    Highlands
    15 Vernon Road
    SS9 2NG Leigh On Sea
    Essex
    Amministratore
    Highlands
    15 Vernon Road
    SS9 2NG Leigh On Sea
    Essex
    EnglandBritish73770040001
    JOHNSON, David Arthur
    133 Newtown Road
    BH31 6EH Verwood
    Dorset
    Amministratore
    133 Newtown Road
    BH31 6EH Verwood
    Dorset
    British10394350002
    KESHIRO, Rashidi Olugbenga
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    Amministratore
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    United KingdomBritish120935530001
    LEESE, Richard Charles, Sir
    19 Westbury Road
    Crumpsall
    M8 5RX Manchester
    Amministratore
    19 Westbury Road
    Crumpsall
    M8 5RX Manchester
    United KingdomBritish53459790002
    LEESE, Richard Charles, Sir
    19 Westbury Road
    Crumpsall
    M8 5RX Manchester
    Amministratore
    19 Westbury Road
    Crumpsall
    M8 5RX Manchester
    United KingdomBritish53459790002
    MACKIE, Colin Dwight
    Highcourt
    11 Tadcaster Road
    YO23 3UL Copmanthorpe
    North Yorkshire
    Amministratore
    Highcourt
    11 Tadcaster Road
    YO23 3UL Copmanthorpe
    North Yorkshire
    United KingdomBritish78640920001
    MOORE, Michael Anthony
    17 Pine Road
    Didsbury
    M20 6UY Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    17 Pine Road
    Didsbury
    M20 6UY Manchester
    Lancashire
    British4609510001
    ONG, Guat Hoon (Known As Christina)
    The Galleries Building 4, Level 6
    Downtown Jebel Ali, PO BOX 17000
    Dubai
    Istithmar World Pjsc
    United Arab Emirates
    Amministratore
    The Galleries Building 4, Level 6
    Downtown Jebel Ali, PO BOX 17000
    Dubai
    Istithmar World Pjsc
    United Arab Emirates
    United Arab EmiratesSingaporean197371130001
    REAMES, Rodney Charles Dudley
    83 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    83 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    British33215200001
    THOMAS OF MACCLESFIELD, Terence James, Lord
    51 Willowmead Drive
    SK10 4DD Prestbury
    Cheshire
    Amministratore
    51 Willowmead Drive
    SK10 4DD Prestbury
    Cheshire
    British85130800001
    TRIPPIER, David Austin, Sir
    Dowry Head
    Helmshore
    BB4 4AE Rossendale
    Lancashire
    Amministratore
    Dowry Head
    Helmshore
    BB4 4AE Rossendale
    Lancashire
    British27871400001
    TURNER, Norman Patrick
    Hillside Macclesfield Road
    SK9 7BW Alderley Edge
    Cheshire
    Amministratore
    Hillside Macclesfield Road
    SK9 7BW Alderley Edge
    Cheshire
    British9842980001
    WADDINGTON, Robert
    83 Bourne Street
    SW1W 8HQ London
    Amministratore
    83 Bourne Street
    SW1W 8HQ London
    British72682390002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione6067171
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    VECTOR INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Third security assignment
    Creato il 30 mag 2003
    Consegnato il 05 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in to and arising under the relevant agreements and the relevant insurances and any moneys payable or to the account of the assignor thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capital Bank Corporate Finance PLC
    Transazioni
    • 05 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security assignment
    Creato il 02 ott 2000
    Consegnato il 05 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the amended lease agreements or any of the other financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    All the company's right title benefit and interest in and to the assigned rights where the assigned rights are all the right title benefit and interest of the chargor in to or arising out of or in connection with clause 5 of the release and guarantee agreement dated 2ND october 2000. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capital Bank Corporate Finance PLC
    Transazioni
    • 05 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security assignment
    Creato il 26 set 1997
    Consegnato il 01 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the lessors, under or pursuant to any of the lease agreements or any of the other financing documents (as defined in the deed)
    Brevi particolari
    All of the assignor's right title benefit and interest to and in the assigned rights and all the benefits of all policies, contracts and agreements in respect of the relevant insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capital Bank Corporate Finance PLC
    Transazioni
    • 01 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security assignment
    Creato il 29 dic 1995
    Consegnato il 10 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the lease agreements or any of the other financing documents
    Brevi particolari
    All of the assignor's right title benefit and interst to and in the assigned rights, the charged account, the deposit and all the benefits of all policies, contracts and agreements in respect of the relevant insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nws Corporate Finance PLC as Agent and Security Trustee for Itself and the Lessors
    Transazioni
    • 10 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 dic 1995
    Consegnato il 10 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any lease agreements or any of the other financing documents
    Brevi particolari
    L/H-the international olympic arena, manchester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nws Corporate Finance PLC as Agent and Security Trustee for Itself and the Lessors
    Transazioni
    • 10 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security account charge
    Creato il 29 dic 1995
    Consegnato il 09 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any of the lease agreements or any of the other financing documents
    Brevi particolari
    All of the company's right title benefit and interest to and in the deposit of £2,000,000 deposited in the account numbered 70329986 in the company's name held with co-op bank at its branch at po box 101, 1 balloon street, manchester M60 4EP sort code 08-90-00.
    Persone aventi diritto
    • Nws Corporate Finance PLC(As Agent and Security Trustee for Itself and the Lessors)
    Transazioni
    • 09 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of building contract
    Creato il 05 nov 1993
    Consegnato il 25 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the co-operative bank PLC and agent and trustee for itself, bovis construction limited and/or the beneficiaries (as defined) or any of them on any account whatsoever under the terms of the assignment (as defined therein)
    Brevi particolari
    A building contract d/d 24/08/93 to construct an indoor sports arena adjacent to victoria railways station manchester. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC ("the Agent")
    Transazioni
    • 25 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 05 nov 1993
    Consegnato il 25 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the co-operative bank PLC as agent and trustee for itself,bovis construction limited and/or the beneficiaries (as defined) or any of them under the terms of the assignment (as defined therein)
    Brevi particolari
    All right title and interest of the company under a building agreement and underlease d/d 04/12/92 an agreement d/d 14/04/93 and an agreement d/d 27/05/93. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC ("the Agent")
    Transazioni
    • 25 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 nov 1993
    Consegnato il 25 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the co-operative bank PLC as agent and trustee for itself and bovis construction limited and/or the beneficiaries (as defined) or any of them on any account whatsoever under the terms of the debenture (as defined therein)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC ("the Agent")
    Transazioni
    • 25 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 feb 1993
    Consegnato il 19 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bovis Construction Limited
    Transazioni
    • 19 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 feb 1993
    Consegnato il 15 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 15 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 gen 1993
    Consegnato il 11 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 11 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 nov 1992
    Consegnato il 27 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings at roger street/brighton street cheetham hill manchester t/no's la 34630 la 52063 la 115564 & la 52062 with buildings & fixtures and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 27 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    VECTOR INVESTMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 dic 2021Inizio della liquidazione
    25 apr 2024Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen John Absolom
    C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Nicholas James Timpson
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Howard Smith
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0