QIOPTIQ EUROPE LIMITED

QIOPTIQ EUROPE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàQIOPTIQ EUROPE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02696054
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di QIOPTIQ EUROPE LIMITED?

    • fabbricazione di strumenti ottici di precisione (26701) / Industrie manifatturiere
    • Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova QIOPTIQ EUROPE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Glascoed Road
    St Asaph
    LL17 0LL Denbighshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di QIOPTIQ EUROPE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AVIMO EUROPE LIMITED20 mag 199420 mag 1994
    DARTPROOF LIMITED11 mar 199211 mar 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di QIOPTIQ EUROPE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per QIOPTIQ EUROPE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mar 2020 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Stato del capitale al 28 gen 2020

    • Capitale: GBP 0.77
    4 pagineSH19
    Note
    DataNota
    28 gen 2020Clarification This is a second filing of an SH19 registered on 13/01/2020.

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 13 gen 2020

    • Capitale: GBP 0.77
    4 pagineSH19
    Note
    DataNota
    28 gen 2020Clarification A second filed SH19 was registered on 28/01/2020.

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 23/12/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 23 dic 2019

    • Capitale: GBP 30,790,360.66
    4 pagineSH01

    Bilancio redatto al 30 dic 2018

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 01 gen 2017

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Dr Alison Mary Chapman come segretario in data 24 gen 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Richard William Groves come segretario in data 24 gen 2017

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Peter Adam White come amministratore in data 13 gen 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Steven David Shaw come amministratore in data 13 gen 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 03 gen 2016

    21 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di QIOPTIQ EUROPE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHAPMAN, Alison Mary, Dr
    Glascoed Road
    St Asaph
    LL17 0LL Denbighshire
    Segretario
    Glascoed Road
    St Asaph
    LL17 0LL Denbighshire
    223261070001
    NISLICK, David Adam
    Glascoed Road
    St Asaph
    LL17 0LL Denbighshire
    Amministratore
    Glascoed Road
    St Asaph
    LL17 0LL Denbighshire
    United StatesAmericanCeo Excelitas Technologies Corp156518330001
    RAO, James Vincent
    Glascoed Road
    St Asaph
    LL17 0LL Denbighshire
    Amministratore
    Glascoed Road
    St Asaph
    LL17 0LL Denbighshire
    United StatesAmericanFco Excelitas Technologies Corp156269250001
    WHITE, Peter Adam
    Glascoed Road
    St Asaph
    LL17 0LL Denbighshire
    Amministratore
    Glascoed Road
    St Asaph
    LL17 0LL Denbighshire
    WalesBritishMd & Vp Land Business222589370001
    ARCHER, Marc Stephen
    52 High Oaks
    AL3 6DN St Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    52 High Oaks
    AL3 6DN St Albans
    Hertfordshire
    British37782900001
    EARDLEY, Barry Eric
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    Segretario
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    British36645710001
    FLEMING, David Scott
    67 Moor Lane
    SK9 6BQ Wilmslow
    Cheshire
    Segretario
    67 Moor Lane
    SK9 6BQ Wilmslow
    Cheshire
    British51073220001
    FRANCIS, Gary
    74 Hamilton Road
    TA1 2ES Taunton
    Somerset
    Segretario
    74 Hamilton Road
    TA1 2ES Taunton
    Somerset
    British37548320001
    GROVES, Richard William
    Glascoed Road
    St Asaph
    LL17 0LL Denbighshire
    Segretario
    Glascoed Road
    St Asaph
    LL17 0LL Denbighshire
    189401150001
    IVIMEY COOK, Richard Charles
    10 The Chestnuts
    OX14 3YN Abingdon
    Oxfordshire
    Segretario
    10 The Chestnuts
    OX14 3YN Abingdon
    Oxfordshire
    BritishDirector74353360002
    MATTHEWS, John Michael
    Fieldways 98 Downs Road
    CR5 1AF Coulsdon
    Surrey
    Segretario
    Fieldways 98 Downs Road
    CR5 1AF Coulsdon
    Surrey
    British9435490001
    PEARSON, Anthony Ralph
    15 Oakfields Road
    SG3 6NS Knebworth
    Hertfordshire
    Segretario
    15 Oakfields Road
    SG3 6NS Knebworth
    Hertfordshire
    British8659000001
    REES, Mark Anthony
    8 Kenwick Close
    Manor Farm
    L66 2HY Great Sutton
    South Wirral
    Segretario
    8 Kenwick Close
    Manor Farm
    L66 2HY Great Sutton
    South Wirral
    BritishAccountant38538380002
    SPENCER, Alan John
    11 Hartlands Close
    DA5 1RL Bexley
    Kent
    Segretario
    11 Hartlands Close
    DA5 1RL Bexley
    Kent
    British14824180001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BOOTH, Ian
    Mill Meadow House Mill Lane
    Lower Slaughter
    GL54 2HX Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Mill Meadow House Mill Lane
    Lower Slaughter
    GL54 2HX Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector42633690003
    CLARKE, Richard John George
    Redwood Harp Hill
    Charlton Kings
    GL52 6PX Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Redwood Harp Hill
    Charlton Kings
    GL52 6PX Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishFinance Director38606270001
    FRANCIS, Gary
    74 Hamilton Road
    TA1 2ES Taunton
    Somerset
    Amministratore
    74 Hamilton Road
    TA1 2ES Taunton
    Somerset
    EnglandBritishFinance Director37548320001
    IVIMEY COOK, Richard Charles
    10 The Chestnuts
    OX14 3YN Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    10 The Chestnuts
    OX14 3YN Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector74353360002
    IVIMEY COOK, Richard Charles
    10 The Chestnuts
    OX14 3YN Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    10 The Chestnuts
    OX14 3YN Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritishAccountant74353360002
    LUA, Sootheng
    442a Dunearn Road
    FOREIGN Singapore 1128
    Amministratore
    442a Dunearn Road
    FOREIGN Singapore 1128
    SingaporeanCompany Director39358660001
    MITCHELL, Stuart Roger
    Little Trees Queens Hill Rise
    SL5 7DP Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Little Trees Queens Hill Rise
    SL5 7DP Ascot
    Berkshire
    New ZealandCompany Director1447530001
    PEARSON, Anthony Ralph
    15 Oakfields Road
    SG3 6NS Knebworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    15 Oakfields Road
    SG3 6NS Knebworth
    Hertfordshire
    BritishDirector8659000001
    PREST, Nicholas Martin
    85 Elgin Crescent
    W11 2JF London
    Amministratore
    85 Elgin Crescent
    W11 2JF London
    Great BritainBritishDirector36518090001
    PRESTON, Stuart Bernard
    1 Greenwood Place
    Wrotham Borough Green
    TN15 7RE Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    1 Greenwood Place
    Wrotham Borough Green
    TN15 7RE Sevenoaks
    Kent
    BritishManaging Director2138180002
    REES, Mark Anthony
    8 Kenwick Close
    Manor Farm
    L66 2HY Great Sutton
    South Wirral
    Amministratore
    8 Kenwick Close
    Manor Farm
    L66 2HY Great Sutton
    South Wirral
    EnglandBritishDirector38538380002
    SHAW, Steven David
    Glascoed Road
    St Asaph
    LL17 0LL Denbighshire
    Amministratore
    Glascoed Road
    St Asaph
    LL17 0LL Denbighshire
    United KingdomBritishManaging Director200290240001
    SPENCER, Alan John
    11 Hartlands Close
    DA5 1RL Bexley
    Kent
    Amministratore
    11 Hartlands Close
    DA5 1RL Bexley
    Kent
    BritishAccountant14824180001
    STEVEN, Brian Joseph Bonthrone
    20 Garden Road
    TN1 2XL Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    20 Garden Road
    TN1 2XL Tunbridge Wells
    Kent
    BritishAccountant59294120003
    TURNER, Stephen Reginald
    Oakwood Cottage
    Oakwood
    NE46 4LE Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    Oakwood Cottage
    Oakwood
    NE46 4LE Hexham
    Northumberland
    United KingdomUkManaging Director78458970002
    WILSON, Alexander David, Dr
    97 Woodside Terrace Lane
    Park
    G3 7XP Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    97 Woodside Terrace Lane
    Park
    G3 7XP Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritishManaging Director103792570001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di QIOPTIQ EUROPE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Qioptiq Uk Holdings Limited
    Glascoed Road
    LL17 0LL St. Asaph
    Glascoed Road
    Denbighshire
    Wales
    06 apr 2016
    Glascoed Road
    LL17 0LL St. Asaph
    Glascoed Road
    Denbighshire
    Wales
    No
    Forma giuridicaProvate Company
    Paese di registrazioneWales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione05612156
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    QIOPTIQ EUROPE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A junior ranking senior share pledge agreement
    Creato il 21 giu 2012
    Consegnato il 09 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the pledgees or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Pledged the shares together with all ancillary rights and claims associated with the shares, pledged present and future rights to receive: dividends attributable to the shares and liquidation proceeds redemption proceeds repaid capital any compensation and all other pecuniary claims see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC, Paris Branch, the Royal Bank of Scotland PLC and Unicredit Bank Ag, London Branch (As Further Defined on Form MG01)
    Transazioni
    • 09 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 31 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A junior ranking mezzanine share pledge agreement
    Creato il 21 giu 2012
    Consegnato il 09 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the pledgees or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Pledged the shares together with all ancillary rights and claims associated with the shares, pledged present and future rights to receive: dividends attributable to the shares and liquidation proceeds redemption proceeds repaid capital any compensation and all other pecuniary claims see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC, Paris Branch, Ecas Ii S.a R.L., American Capital LTD and Ecas 2011-1 Loan B.V.
    Transazioni
    • 09 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 31 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Junior ranking share pledge agreement
    Creato il 04 apr 2008
    Consegnato il 11 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the pledgees or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares together with all ancillary rights and claims associted with the shares see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 11 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A pledge agreement
    Creato il 07 mar 2008
    Consegnato il 25 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights, title and interest in and to the security collateral see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 07 mar 2008
    Consegnato il 19 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 19 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mezzanine share pledge agreement
    Creato il 06 mar 2008
    Consegnato il 25 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the pledgees or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares together with all ancillary rights and claims associated with the shares see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC, Paris Branch, as Security Trustee
    Transazioni
    • 25 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mezzanine share pledge agreement
    Creato il 06 mar 2008
    Consegnato il 25 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the pledgees or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights to receive dividends and liquidation proceeds with all rights and claims thereon; see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Senior share pledge agreement
    Creato il 06 mar 2008
    Consegnato il 25 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the pledgees or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares, together with all ancillary rights and claims, dividends and liquidation proceeds see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 25 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Senior share pledge agreement
    Creato il 06 mar 2008
    Consegnato il 25 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the pledgees on any account under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares together with all ancillary rights and claims associated with the shares see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC, Paris Branch as Security Trustee
    Transazioni
    • 25 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession
    Creato il 22 dic 2005
    Consegnato il 30 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Glascoed road st asaph denbighshire t/n CYM63774. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC, Paris Branch (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 30 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0