STANLEY CLARKE LEISURE LIMITED

STANLEY CLARKE LEISURE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTANLEY CLARKE LEISURE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02700384
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STANLEY CLARKE LEISURE LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova STANLEY CLARKE LEISURE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Millbank Tower
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STANLEY CLARKE LEISURE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INGLEBY (633) LIMITED25 mar 199225 mar 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di STANLEY CLARKE LEISURE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per STANLEY CLARKE LEISURE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per STANLEY CLARKE LEISURE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    The sole member resolved to wind up the company voluntarily. 20/08/2015
    RES13

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Anthony Brian Kelly come amministratore in data 23 lug 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 23 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 mar 2015

    Stato del capitale al 24 mar 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 20 nov 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    10 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Kevin Stuart Robertson il 07 ago 2014

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Kevin Stuart Robertson come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 23 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 mar 2014

    Stato del capitale al 26 mar 2014

    • Capitale: GBP 5,113,302
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2013 al 31 dic 2012

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di Robert Renton come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Ian Renton il 12 giu 2012

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Robert Ian Renton come amministratore

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 12C Lancaster Park Needwood Burton on Trent Staffs DE13 9PD* in data 18 mag 2012

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Rachel Nelson come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Ms Megan Joy Langridge come segretario

    2 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di STANLEY CLARKE LEISURE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LANGRIDGE, Megan Joy
    Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    42
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    42
    Kent
    United Kingdom
    169114520001
    NAHUM, Stephane Abraham Joseph
    21a Kensington High Street
    W8 5NP London
    Amministratore
    21a Kensington High Street
    W8 5NP London
    United KingdomFrenchPrivate Equity99292580014
    O'DRISCOLL, Patrick Colin
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    Millbank Tower
    England
    England
    Amministratore
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    Millbank Tower
    England
    England
    EnglandIrishAccountant75571770002
    ROBERTSON, Kevin Stuart
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    Millbank Tower
    England
    Amministratore
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    Millbank Tower
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer189098720001
    DOONA, Paul Ernest
    10 Hartopp Road
    Four Oaks Estate
    B74 2RQ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    10 Hartopp Road
    Four Oaks Estate
    B74 2RQ Sutton Coldfield
    West Midlands
    British9262110003
    HOLMES, Nicolas
    Kingston Villa
    10 Kingston Street
    DE1 3EZ Derby
    Derbyshire
    Segretario
    Kingston Villa
    10 Kingston Street
    DE1 3EZ Derby
    Derbyshire
    British67823840001
    KELLY, Anthony Brian
    Merrimeet
    Kerves Lane
    RH13 6ET Horsham
    West Sussex
    Segretario
    Merrimeet
    Kerves Lane
    RH13 6ET Horsham
    West Sussex
    BritishDirector66203340003
    NELSON, Rachel Anne
    12c Lancaster Park Needwood
    Burton On Trent
    DE13 9PD Staffs
    Segretario
    12c Lancaster Park Needwood
    Burton On Trent
    DE13 9PD Staffs
    BritishChartered Accountant128053130001
    POTTS, Sarah Joanne
    The Haven
    Bagot Street, Abbots Bromley
    WS15 3DA Rugeley
    Staffordshire
    Segretario
    The Haven
    Bagot Street, Abbots Bromley
    WS15 3DA Rugeley
    Staffordshire
    British68917640001
    STOKES, Mark Bryan
    Ridge Farm
    172 Harvestfields Way Roughley
    B75 5TJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    Ridge Farm
    172 Harvestfields Way Roughley
    B75 5TJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    British74798060005
    INGLEBY NOMINEES LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Segretario nominato
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007860001
    CLARKE, Simon William
    Newchurch
    Hoar Cross
    DE13 8RL Burton-On-Trent
    Lower Lynbrook Farm
    Staffordshire
    Amministratore
    Newchurch
    Hoar Cross
    DE13 8RL Burton-On-Trent
    Lower Lynbrook Farm
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector19863530002
    CLARKE, Stanley William, Sir
    The Knoll
    Main Street
    DE13 8AB Barton Under Needwood
    Staffordshire
    Amministratore
    The Knoll
    Main Street
    DE13 8AB Barton Under Needwood
    Staffordshire
    BritishChairman9443230001
    HARRINGTON, Julie Anne
    12c Lancaster Park Needwood
    Burton On Trent
    DE13 9PD Staffs
    Amministratore
    12c Lancaster Park Needwood
    Burton On Trent
    DE13 9PD Staffs
    EnglandBritishDirector118654280002
    KELLY, Anthony Brian
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    Millbank Tower
    England
    England
    Amministratore
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    Millbank Tower
    England
    England
    United KingdomBritishDirector66203340004
    RENTON, Robert Ian
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    Millbank Tower
    England
    England
    Amministratore
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    Millbank Tower
    England
    England
    United KingdomBritishRacing Director133733440001
    STOKES, Mark Bryan
    Ridge Farm
    172 Harvestfields Way Roughley
    B75 5TJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    Ridge Farm
    172 Harvestfields Way Roughley
    B75 5TJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishFinance Director74798060005
    STREET, Rodney Grant
    1 Walnut Walk
    Victoria Park
    WS13 8FA Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    1 Walnut Walk
    Victoria Park
    WS13 8FA Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritishCompany Director65390550002
    INGLEBY HOLDINGS LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Amministratore delegato nominato
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007850001

    STANLEY CLARKE LEISURE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 20 ago 2007
    Consegnato il 24 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Parties(The Security Trustee)
    Transazioni
    • 24 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 14 ott 2005
    Consegnato il 21 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 21 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0