HOODEN HORSE INNS LIMITED

HOODEN HORSE INNS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHOODEN HORSE INNS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02700525
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HOODEN HORSE INNS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HOODEN HORSE INNS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Elsley Court
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di HOODEN HORSE INNS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per HOODEN HORSE INNS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di David Forde come amministratore in data 31 lug 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 17 gen 2020

    • Capitale: GBP 2.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    2 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    legacy

    79 paginePARENT_ACC

    Nomina di Mr Sean Michael Paterson come amministratore in data 24 apr 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David James Tannahill come amministratore in data 24 apr 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 24 ago 2018 al 31 dic 2018

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 19 ago 2017

    3 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Jubilee House Second Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 2WF a Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street London W1W 8BE in data 08 set 2017

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Punch Taverns (Ib) Limited come persona con controllo significativo il 04 set 2017

    2 paginePSC05

    Cessazione della carica di Francesca Appleby come segretario in data 29 ago 2017

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Stephen Peter Dando come amministratore in data 29 ago 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Edward Michael Bashforth come amministratore in data 29 ago 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Forde come amministratore in data 29 ago 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Christopher John Moore come amministratore in data 29 ago 2017

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di HOODEN HORSE INNS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MOORE, Christopher John
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish136853310001
    MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    EnglandBritish112375050001
    PATERSON, Sean Michael
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    Amministratore
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    ScotlandBritish257892140001
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191627820001
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    BROWN, Robert Adam Southall
    24 Alders Brook
    Hilton
    DE65 5HF Derby
    Derbyshire
    Segretario
    24 Alders Brook
    Hilton
    DE65 5HF Derby
    Derbyshire
    British67809020001
    GRAEME, Dorothy May
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Segretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001330001
    HARRINGTON, Columb
    4 Drovers Way
    Newton Longville
    MK17 0HR Buckinghamshire
    Segretario
    4 Drovers Way
    Newton Longville
    MK17 0HR Buckinghamshire
    Irish51845740002
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175488160001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    SAVAGE, Neil Howard
    Belmont Farm
    Snoad Hill, Bethersden
    TN26 3DY Ashford
    Kent
    Segretario
    Belmont Farm
    Snoad Hill, Bethersden
    TN26 3DY Ashford
    Kent
    British64244340001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    British117216940001
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161624270001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    BENSLEY, Alex Vincent
    Crabb Cottage Lenham Heath Road
    Lenham
    ME17 2BU Maidstone
    Kent
    Amministratore
    Crabb Cottage Lenham Heath Road
    Lenham
    ME17 2BU Maidstone
    Kent
    British26841140002
    BROWN, Robert Adam Southall
    24 Alders Brook
    Hilton
    DE65 5HF Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    24 Alders Brook
    Hilton
    DE65 5HF Derby
    Derbyshire
    British67809020001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    ELLIOTT, Roy Lewis
    Chilmington Cottage Chilmington Green
    Great Chart
    TN23 3DP Ashford
    Kent
    Amministratore
    Chilmington Cottage Chilmington Green
    Great Chart
    TN23 3DP Ashford
    Kent
    British13331850001
    FORDE, David
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomIrish180590780001
    GRAEME, Lesley Joyce
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Amministratore delegato nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001320001
    JACKSON, Alan Marchant
    Woodrow Farm
    Wigginton
    HP23 6HT Tring
    Hertfordshire
    Amministratore
    Woodrow Farm
    Wigginton
    HP23 6HT Tring
    Hertfordshire
    EnglandBritish18341590001
    KEMP, Deborah Jane
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    Amministratore
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    United KingdomBritish79388130005
    LAMBERT, Stephen David
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    British43572470001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002
    SAVAGE, Neil Howard
    Belmont Farm
    Snoad Hill, Bethersden
    TN26 3DY Ashford
    Kent
    Amministratore
    Belmont Farm
    Snoad Hill, Bethersden
    TN26 3DY Ashford
    Kent
    British64244340001
    TANNAHILL, David James
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    ScotlandBritish237381690001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HOODEN HORSE INNS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    29 ago 2017
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    No
    Forma giuridicaCorporate
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleUnited Kingdom (Scotland)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc065527
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    06 apr 2016
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione1899248
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    HOODEN HORSE INNS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 14 set 1999
    Consegnato il 05 ott 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors each of them to the secured creditors (or any of them) under the facility documents (or any of them) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited (As Trustee for the Secured Creditors)
    Transazioni
    • 05 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 21 feb 1994
    Consegnato il 23 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The hooden horse inn maytham road rolvenden kent t/n K342057 together with the goodwill of the business carried on therefrom.
    Persone aventi diritto
    • First National Bank PLC
    Transazioni
    • 23 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Loan agreement and legal charge
    Creato il 03 dic 1993
    Consegnato il 07 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £170,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this deed
    Brevi particolari
    The f/h properties "the rose inn" public house willesborough kent t/n k 414790 and "the hooden horse" public house the street greater chart ashford kent t/n k 298812.
    Persone aventi diritto
    • Greene King PLC
    Transazioni
    • 07 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Loan agreement and legal charge
    Creato il 17 giu 1993
    Consegnato il 23 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £110,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H the rose inn public house willesborough kent t/n K414790.
    Persone aventi diritto
    • Greene King PLC
    Transazioni
    • 23 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 nov 1992
    Consegnato il 04 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The duke of york public house high street cranbrook kent t/n k 341843 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0