VIASYSTEMS EMS - UK LIMITED

VIASYSTEMS EMS - UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVIASYSTEMS EMS - UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02701593
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VIASYSTEMS EMS - UK LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova VIASYSTEMS EMS - UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Weil Gotshal & Manges
    One South Place
    EC2M 2WG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VIASYSTEMS EMS - UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MARCONI COMMUNICATIONS, NETWORK COMPONENTS & SERVICES-UK LIMITED01 giu 199901 giu 1999
    RELTEC (UK) LIMITED01 lug 199701 lug 1997
    RAINFORD GROUP LIMITED06 mar 199506 mar 1995
    RAINFORD GROUP HOLDINGS LIMITED 18 mag 199218 mag 1992
    OBJECTEXIST LIMITED30 mar 199230 mar 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di VIASYSTEMS EMS - UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2004

    Quali sono le ultime deposizioni per VIASYSTEMS EMS - UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Gerald Sax come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Gerald Sax come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Webster come amministratore

    2 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di ri-registrazione

    RES02

    Ordinanza giudiziaria

    Order of court - dissolution void
    3 pagineOC-DV

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    legacy

    1 pagine652a

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    16 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    1 pagine244

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2003

    19 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2002

    19 pagineAA

    legacy

    1 pagine244

    legacy

    5 pagine363s

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 dic 2001

    33 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    legacy

    2 pagine244

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    Chi sono gli amministratori di VIASYSTEMS EMS - UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ACORNLEY, John Keith
    Rose Cottage
    Newton Road
    CV13 0QU Odstone
    Warwickshire
    Segretario
    Rose Cottage
    Newton Road
    CV13 0QU Odstone
    Warwickshire
    British151839430001
    BOND, Philip Austin
    4 Danzey Close
    B98 7TQ Redditch
    Worcestershire
    Segretario
    4 Danzey Close
    B98 7TQ Redditch
    Worcestershire
    British64089430002
    CLARK, Susan Marie
    4462 Periwinkle Lane
    44143 Richmond Heights
    Ohio
    Usa
    Segretario
    4462 Periwinkle Lane
    44143 Richmond Heights
    Ohio
    Usa
    Usa44905370001
    DAY, Catherine Marie
    Flat 2 9 Cringle Road
    Levensholme
    M19 2RW Manchester
    Segretario
    Flat 2 9 Cringle Road
    Levensholme
    M19 2RW Manchester
    British29322740001
    FOSTER, Geoffrey Iain
    The Hollies
    Windmill Lane
    CV7 7GY Balsall Common
    West Midlands
    Segretario
    The Hollies
    Windmill Lane
    CV7 7GY Balsall Common
    West Midlands
    British79299490001
    PERONE, Celestino
    Ashcroft
    Sandlin Leigh Sinton
    WR13 5DN Malvern
    Worcestershire
    Segretario
    Ashcroft
    Sandlin Leigh Sinton
    WR13 5DN Malvern
    Worcestershire
    British55366470003
    PRICE, Andrew Christopher
    The Briars
    36 Pilkington Avenue
    B72 1LD Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    The Briars
    36 Pilkington Avenue
    B72 1LD Sutton Coldfield
    West Midlands
    British120883400001
    SAX, Gerald George
    101 S.Hanley Road
    St Louis
    Missouri 63105
    Usa
    Segretario
    101 S.Hanley Road
    St Louis
    Missouri 63105
    Usa
    American149084090001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ACORNLEY, John Keith
    Rose Cottage
    Newton Road
    CV13 0QU Odstone
    Warwickshire
    Amministratore
    Rose Cottage
    Newton Road
    CV13 0QU Odstone
    Warwickshire
    EnglandBritish151839430001
    CAULFIELD, Michael
    5 Rosswater
    BT47 6YR Londonderry
    County Londonderry
    Amministratore
    5 Rosswater
    BT47 6YR Londonderry
    County Londonderry
    Northern IrelandBritish64089190001
    DAVIS, Jeff
    119 Abbotsbury Road
    W14 8EP London
    Amministratore
    119 Abbotsbury Road
    W14 8EP London
    Usa79150710001
    DAY, Catherine Marie
    Flat 2 9 Cringle Road
    Levensholme
    M19 2RW Manchester
    Amministratore
    Flat 2 9 Cringle Road
    Levensholme
    M19 2RW Manchester
    British29322740001
    FELL, Michael William
    85 High Street
    CB2 5PZ Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    85 High Street
    CB2 5PZ Cambridge
    Cambridgeshire
    British114233310001
    FERGUSON, Alan William
    Arian The Orchards
    Wilmcote
    CV37 9XF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Arian The Orchards
    Wilmcote
    CV37 9XF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British41818060001
    HOUGHTON, Barry
    Deepdene Mereside Road
    Mere
    WA16 6QW Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Deepdene Mereside Road
    Mere
    WA16 6QW Knutsford
    Cheshire
    British25593400001
    PROCTER, Jonathan
    11 Moreton Drive
    Poynton
    SK12 1FA Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    11 Moreton Drive
    Poynton
    SK12 1FA Stockport
    Cheshire
    British18151740001
    SAX, Gerald George
    101 S.Hanley Road
    St Louis
    Missouri 63105
    Usa
    Amministratore
    101 S.Hanley Road
    St Louis
    Missouri 63105
    Usa
    UsaAmerican149084090001
    SHEFFLER, Dudley Paul
    2501 Chagrin River Road
    44040 Gates Mill
    Ohio
    Usa
    Amministratore
    2501 Chagrin River Road
    44040 Gates Mill
    Ohio
    Usa
    American143675950001
    TRAVIS, Len
    17 Lulworth Park
    CV8 2XG Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    17 Lulworth Park
    CV8 2XG Kenilworth
    Warwickshire
    American64089300001
    WEBSTER, David James
    10 Deer Creek Woods Drive
    St Louis
    Missouri 63124
    Usa
    Amministratore
    10 Deer Creek Woods Drive
    St Louis
    Missouri 63124
    Usa
    American57977290002
    WELKER, Patrick
    Astley Manor Astley Lane
    Astley
    CV10 7PZ Nuneaton
    Warwickshire
    Amministratore
    Astley Manor Astley Lane
    Astley
    CV10 7PZ Nuneaton
    Warwickshire
    American56192260001
    WILSON, John Larsen
    359 Bethany Lane
    44012 Avon Lake
    Ohio
    Usa
    Amministratore
    359 Bethany Lane
    44012 Avon Lake
    Ohio
    Usa
    Usa49315930001
    WORMSLEY, Bertram Howard
    69 Hervey Road
    Blackheath
    SE3 8BX London
    Amministratore
    69 Hervey Road
    Blackheath
    SE3 8BX London
    British3252750001
    ZIEMNIAK, Czeslaw John
    Whiteposts
    Walkwood End
    HP9 1PR Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Whiteposts
    Walkwood End
    HP9 1PR Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British79361600001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    VIASYSTEMS EMS - UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 30 giu 1994
    Consegnato il 06 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 03 ago 1993
    Consegnato il 05 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from rainford group limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 05 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2002Registrazione di un'ipoteca
    • 28 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 17 mag 1992
    Consegnato il 01 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0