ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED

ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàENGINE PARTS (U.K.) LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02701726
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi (46760) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 14-17 Thurrock Commercial Park
    Purfleet Industrial Park London Road A13
    RM15 4YA Purfleet
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HIREUS LIMITED30 mar 199230 mar 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 ott 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 lug 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al30 apr 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma14 mag 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al30 apr 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2023

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 apr 2024 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mrs Judith Alexandra Stone come segretario in data 28 apr 2024

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Andrew Lewis Dickinson come segretario in data 28 apr 2024

    1 pagineTM02

    Notifica di Martyn Peter Stone come persona con controllo significativo il 28 apr 2024

    2 paginePSC01

    Notifica di Judith Alexandra Stone come persona con controllo significativo il 28 apr 2024

    2 paginePSC01

    Cessazione di Andrew Lewis Dickinson come persona con controllo significativo il 28 apr 2024

    1 paginePSC07

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2022

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 mag 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2021

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2020

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2019

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2018

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Martyn Peter Stone il 13 mag 2019

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2017

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ott 2016

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 mag 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ott 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 giu 2016

    Stato del capitale al 10 giu 2016

    • Capitale: GBP 206,647
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Lewis Dickinson il 10 dic 2015

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STONE, Judith Alexandra
    Thurrock Commercial Park
    Purfleet Industrial Park London Road A13
    RM15 4YA Purfleet
    Unit 14-17
    Essex
    Segretario
    Thurrock Commercial Park
    Purfleet Industrial Park London Road A13
    RM15 4YA Purfleet
    Unit 14-17
    Essex
    322549900001
    DICKINSON, Andrew Lewis
    Thurrock Commercial Park
    Purfleet Industrial Park London Road A13
    RM15 4YA Purfleet
    Unit 14-17
    Essex
    Amministratore
    Thurrock Commercial Park
    Purfleet Industrial Park London Road A13
    RM15 4YA Purfleet
    Unit 14-17
    Essex
    WalesBritishSalesman53581760003
    STONE, Judith Alexandra
    Thurrock Commercial Park
    Purfleet Industrial Park London Road A13
    RM15 4YA Purfleet
    Unit 14-17
    Essex
    Amministratore
    Thurrock Commercial Park
    Purfleet Industrial Park London Road A13
    RM15 4YA Purfleet
    Unit 14-17
    Essex
    WalesBritishGovernment Agency Policy Maker165693160001
    STONE, Martyn Peter
    Thurrock Commercial Park
    Purfleet Industrial Park London Road A13
    RM15 4YA Purfleet
    Unit 14-17
    Essex
    Amministratore
    Thurrock Commercial Park
    Purfleet Industrial Park London Road A13
    RM15 4YA Purfleet
    Unit 14-17
    Essex
    WalesBritishPolice Officer181036560001
    DICKINSON, Andrew Lewis
    Thurrock Commercial Park
    Purfleet Industrial Park London Road A13
    RM15 4YA Purfleet
    Unit 14-17
    Essex
    Segretario
    Thurrock Commercial Park
    Purfleet Industrial Park London Road A13
    RM15 4YA Purfleet
    Unit 14-17
    Essex
    187654580001
    DICKINSON, Janet Valerie
    8 Cheshire Close
    RM11 3ER Hornchurch
    Essex
    Segretario
    8 Cheshire Close
    RM11 3ER Hornchurch
    Essex
    British53581560001
    GRAEME, Dorothy May
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Segretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001330001
    MASCALL, Alan
    7 Hawksmoor Green
    Hutton
    CM13 1LE Brentwood
    Essex
    Segretario
    7 Hawksmoor Green
    Hutton
    CM13 1LE Brentwood
    Essex
    British32704980001
    MERRY, Anthony
    Ardleigh Acres
    Harts Lane
    CO7 7QQ Aedleigh
    Essex
    Segretario
    Ardleigh Acres
    Harts Lane
    CO7 7QQ Aedleigh
    Essex
    British74403790001
    RIGBY, Raymond Victor
    The Plantations
    Eaton Grange Long Eaton
    NG10 3QG Nottingham
    8
    Nottinghamshire
    England
    Segretario
    The Plantations
    Eaton Grange Long Eaton
    NG10 3QG Nottingham
    8
    Nottinghamshire
    England
    151629690001
    TURNER, Carol Anne
    29 Brampton Close
    Corringham
    SS17 7NS Stanford Le Hope
    Essex
    Segretario
    29 Brampton Close
    Corringham
    SS17 7NS Stanford Le Hope
    Essex
    British43945750001
    CARTER, Robert John
    76 Bramwoods Road
    Great Baddow
    CM2 7LT Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    76 Bramwoods Road
    Great Baddow
    CM2 7LT Chelmsford
    Essex
    BritishWarehouse Manager32704990002
    DICKINSON, Andrew Lewis
    9 Cheshire Close
    RM11 3ER Hornchurch
    Essex
    Amministratore
    9 Cheshire Close
    RM11 3ER Hornchurch
    Essex
    BritishSalesman53581760001
    DICKINSON, Janet Valerie
    8 Cheshire Close
    RM11 3ER Hornchurch
    Essex
    Amministratore
    8 Cheshire Close
    RM11 3ER Hornchurch
    Essex
    BritishSecretary53581560001
    GRAEME, Lesley Joyce
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Amministratore delegato nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001320001
    MASCALL, Alan
    7 Hawksmoor Green
    Hutton
    CM13 1LE Brentwood
    Essex
    Amministratore
    7 Hawksmoor Green
    Hutton
    CM13 1LE Brentwood
    Essex
    BritishSales And Office Manager32704980001
    MERRY, Anthony
    Ardleigh Acres
    Harts Lane
    CO7 7QQ Aedleigh
    Essex
    Amministratore
    Ardleigh Acres
    Harts Lane
    CO7 7QQ Aedleigh
    Essex
    United KingdomBritishSales Administrator74403790001
    RIGBY, Raymond Victor
    8 The Plantations
    Eaton Grange Long Eaton
    NG10 3QG Nottingham
    Amministratore
    8 The Plantations
    Eaton Grange Long Eaton
    NG10 3QG Nottingham
    United KingdomBritishSales Manager34821840001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mrs Judith Alexandra Stone
    Thurrock Commercial Park
    Purfleet Industrial Park London Road A13
    RM15 4YA Purfleet
    Unit 14-17
    Essex
    28 apr 2024
    Thurrock Commercial Park
    Purfleet Industrial Park London Road A13
    RM15 4YA Purfleet
    Unit 14-17
    Essex
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Wales
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Mr Martyn Peter Stone
    Thurrock Commercial Park
    Purfleet Industrial Park London Road A13
    RM15 4YA Purfleet
    Unit 14-17
    Essex
    28 apr 2024
    Thurrock Commercial Park
    Purfleet Industrial Park London Road A13
    RM15 4YA Purfleet
    Unit 14-17
    Essex
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Wales
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Mr Andrew Lewis Dickinson
    Thurrock Commercial Park
    Purfleet Industrial Park London Road A13
    RM15 4YA Purfleet
    Unit 14-17
    Essex
    06 apr 2016
    Thurrock Commercial Park
    Purfleet Industrial Park London Road A13
    RM15 4YA Purfleet
    Unit 14-17
    Essex
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Wales
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 22 mag 2002
    Consegnato il 23 mag 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    17 barleyfield hinckley leicester / hinckley and bosworth t/no: LT326589. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 10 ago 1999
    Consegnato il 12 ago 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Frteehold land k/a units 14 and 15 thurrock commercial park juliette way essex purfleet essex t/n EX566470. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 19 gen 1996
    Consegnato il 24 gen 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 24 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed equitable charge
    Creato il 27 gen 1995
    Consegnato il 04 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed equitable charge over all book debts invoice debts accounts notes bills acceptances and/or other forms of obligation. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Griffin Factors Limited
    Transazioni
    • 04 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 ago 1993
    Consegnato il 06 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 17 thurrock commercial park purfleet industrial estate london road purfleet essex.t/no.ex 430649.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 ago 1992
    Consegnato il 26 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 16, thurrock commercial park, purfleet industrial estate, london road, purfleet, essex t/no. EX436904.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 ago 1992
    Consegnato il 24 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    For full details see form 395 tc ref: M301C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0