ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED
Panoramica
Nome della società | ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02701726 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?
- Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi (46760) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Unit 14-17 Thurrock Commercial Park Purfleet Industrial Park London Road A13 RM15 4YA Purfleet Essex |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
HIREUS LIMITED | 30 mar 1992 | 30 mar 1992 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 ott 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 lug 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 ott 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 30 apr 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 14 mag 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 30 apr 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2023 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 apr 2024 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Judith Alexandra Stone come segretario in data 28 apr 2024 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Lewis Dickinson come segretario in data 28 apr 2024 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Notifica di Martyn Peter Stone come persona con controllo significativo il 28 apr 2024 | 2 pagine | PSC01 | ||||||||||
Notifica di Judith Alexandra Stone come persona con controllo significativo il 28 apr 2024 | 2 pagine | PSC01 | ||||||||||
Cessazione di Andrew Lewis Dickinson come persona con controllo significativo il 28 apr 2024 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2022 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 mag 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2021 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 mag 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2020 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2019 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2018 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Martyn Peter Stone il 13 mag 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2017 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ott 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 mag 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ott 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Lewis Dickinson il 10 dic 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STONE, Judith Alexandra | Segretario | Thurrock Commercial Park Purfleet Industrial Park London Road A13 RM15 4YA Purfleet Unit 14-17 Essex | 322549900001 | |||||||
DICKINSON, Andrew Lewis | Amministratore | Thurrock Commercial Park Purfleet Industrial Park London Road A13 RM15 4YA Purfleet Unit 14-17 Essex | Wales | British | Salesman | 53581760003 | ||||
STONE, Judith Alexandra | Amministratore | Thurrock Commercial Park Purfleet Industrial Park London Road A13 RM15 4YA Purfleet Unit 14-17 Essex | Wales | British | Government Agency Policy Maker | 165693160001 | ||||
STONE, Martyn Peter | Amministratore | Thurrock Commercial Park Purfleet Industrial Park London Road A13 RM15 4YA Purfleet Unit 14-17 Essex | Wales | British | Police Officer | 181036560001 | ||||
DICKINSON, Andrew Lewis | Segretario | Thurrock Commercial Park Purfleet Industrial Park London Road A13 RM15 4YA Purfleet Unit 14-17 Essex | 187654580001 | |||||||
DICKINSON, Janet Valerie | Segretario | 8 Cheshire Close RM11 3ER Hornchurch Essex | British | 53581560001 | ||||||
GRAEME, Dorothy May | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001330001 | ||||||
MASCALL, Alan | Segretario | 7 Hawksmoor Green Hutton CM13 1LE Brentwood Essex | British | 32704980001 | ||||||
MERRY, Anthony | Segretario | Ardleigh Acres Harts Lane CO7 7QQ Aedleigh Essex | British | 74403790001 | ||||||
RIGBY, Raymond Victor | Segretario | The Plantations Eaton Grange Long Eaton NG10 3QG Nottingham 8 Nottinghamshire England | 151629690001 | |||||||
TURNER, Carol Anne | Segretario | 29 Brampton Close Corringham SS17 7NS Stanford Le Hope Essex | British | 43945750001 | ||||||
CARTER, Robert John | Amministratore | 76 Bramwoods Road Great Baddow CM2 7LT Chelmsford Essex | British | Warehouse Manager | 32704990002 | |||||
DICKINSON, Andrew Lewis | Amministratore | 9 Cheshire Close RM11 3ER Hornchurch Essex | British | Salesman | 53581760001 | |||||
DICKINSON, Janet Valerie | Amministratore | 8 Cheshire Close RM11 3ER Hornchurch Essex | British | Secretary | 53581560001 | |||||
GRAEME, Lesley Joyce | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001320001 | ||||||
MASCALL, Alan | Amministratore | 7 Hawksmoor Green Hutton CM13 1LE Brentwood Essex | British | Sales And Office Manager | 32704980001 | |||||
MERRY, Anthony | Amministratore | Ardleigh Acres Harts Lane CO7 7QQ Aedleigh Essex | United Kingdom | British | Sales Administrator | 74403790001 | ||||
RIGBY, Raymond Victor | Amministratore | 8 The Plantations Eaton Grange Long Eaton NG10 3QG Nottingham | United Kingdom | British | Sales Manager | 34821840001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
---|---|---|---|
Mrs Judith Alexandra Stone | 28 apr 2024 | Thurrock Commercial Park Purfleet Industrial Park London Road A13 RM15 4YA Purfleet Unit 14-17 Essex | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: Wales | |||
Natura del controllo
| |||
Mr Martyn Peter Stone | 28 apr 2024 | Thurrock Commercial Park Purfleet Industrial Park London Road A13 RM15 4YA Purfleet Unit 14-17 Essex | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: Wales | |||
Natura del controllo
| |||
Mr Andrew Lewis Dickinson | 06 apr 2016 | Thurrock Commercial Park Purfleet Industrial Park London Road A13 RM15 4YA Purfleet Unit 14-17 Essex | Sì |
Nazionalità: British Paese di residenza: Wales | |||
Natura del controllo
|
ENGINE PARTS (U.K.) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creato il 22 mag 2002 Consegnato il 23 mag 2002 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 17 barleyfield hinckley leicester / hinckley and bosworth t/no: LT326589. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 10 ago 1999 Consegnato il 12 ago 1999 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Frteehold land k/a units 14 and 15 thurrock commercial park juliette way essex purfleet essex t/n EX566470. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 19 gen 1996 Consegnato il 24 gen 1996 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed equitable charge | Creato il 27 gen 1995 Consegnato il 04 feb 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed equitable charge over all book debts invoice debts accounts notes bills acceptances and/or other forms of obligation. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 26 ago 1993 Consegnato il 06 set 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Unit 17 thurrock commercial park purfleet industrial estate london road purfleet essex.t/no.ex 430649. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 18 ago 1992 Consegnato il 26 ago 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Unit 16, thurrock commercial park, purfleet industrial estate, london road, purfleet, essex t/no. EX436904. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 14 ago 1992 Consegnato il 24 ago 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari For full details see form 395 tc ref: M301C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0