MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED

MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02702022
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED?

    • (9231) /

    Dove si trova MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Quadrant House
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SPEED 2486 LIMITED31 mar 199231 mar 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 lug 2007
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mag 2008
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2006

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al31 mar 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma14 apr 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 gen 2025

    15 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 gen 2023

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 lug 2022

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 gen 2022

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 lug 2021

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 gen 2021

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 lug 2020

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 gen 2020

    5 pagine4.68

    Dimissioni di un liquidatore

    3 pagineLIQ06

    Indirizzo della sede legale modificato da Acre House 11-15 William Road London NW1 3ER a Quadrant House 4 Thomas More Square London E1W 1YW in data 07 giu 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 gen 2019

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 lug 2018

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 gen 2018

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 lug 2017

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 gen 2017

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 lug 2016

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 gen 2016

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 lug 2015

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 gen 2015

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 lug 2014

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 gen 2014

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 lug 2013

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 gen 2013

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 lug 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 gen 2012

    5 pagine4.68

    Chi sono gli amministratori di MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HUDSON, Kathleen Mary
    135 Gloucester Avenue
    NW1 8JN London
    Segretario
    135 Gloucester Avenue
    NW1 8JN London
    Australian27259310004
    MARSHALL, Wilfred Terrence
    Perth Y Felin
    SY20 9JG Dinas Mawddwy
    Gwynedd
    Amministratore
    Perth Y Felin
    SY20 9JG Dinas Mawddwy
    Gwynedd
    WalesBritish112866220001
    MBC SECRETARIES LIMITED
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    Segretario nominato
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    900000700001
    HUDSON, John Richard
    135 Gloucester Avenue
    NW1 8JN London
    Amministratore
    135 Gloucester Avenue
    NW1 8JN London
    British27259300005
    HUDSON, Kathleen Mary
    135 Gloucester Avenue
    NW1 8JN London
    Amministratore
    135 Gloucester Avenue
    NW1 8JN London
    Australian27259310004
    MILLS, Daniel
    29 Ronald Close
    BR3 3HX Beckenham
    Kent
    Amministratore
    29 Ronald Close
    BR3 3HX Beckenham
    Kent
    British100906470001
    MBC NOMINEES LIMITED
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    Amministratore delegato nominato
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    900000690001

    MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 11 lug 2006
    Consegnato il 25 lug 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    11A sharpeshall street london t/n NGL124684 including all rights attached or appurtenant to it and all buildings fixtures fittings plant and machinery from time to time situate on it. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Israel Discount Bank Limited
    Transazioni
    • 25 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over credit balance
    Creato il 11 lug 2006
    Consegnato il 25 lug 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The security account and the account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Israel Discount Bank Limited
    Transazioni
    • 25 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 11 lug 2006
    Consegnato il 25 lug 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Israel Discount Bank Limited
    Transazioni
    • 25 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 18 mag 2005
    Consegnato il 19 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold known as 11 sharpleshall st,london NW1; NGL124684; all fixed plant machinery implements utensils furniture and equipment; the goodwill of business and benefit of all covenants rights and agreements thereon.
    Persone aventi diritto
    • Cheval Bridging Finance Limited
    Transazioni
    • 19 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 24 dic 2004
    Consegnato il 06 gen 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Assigns the equipment, ssl console xl 90000K serial no. 91481 and the proceeds of all policies of insurance;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trust PLC
    Transazioni
    • 06 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 28 gen 2004
    Consegnato il 09 feb 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trust PLC
    Transazioni
    • 09 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 28 gen 2004
    Consegnato il 09 feb 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    As security for the payment or discharge of the secured monies the mortgagor as beneficial owner assigns the equipment being 1 comelit vox 200 door intercom system, 4 white window planters with plants, 1 blue sack trolley for further details of the equipment charged please refer to the form 395 and assigns to the mortgagee the proceeds of all policies of insurance and the benefit of all options and rights devolving upon the mortgagor under any such policy of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trust PLC
    Transazioni
    • 09 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 29 dic 2003
    Consegnato il 07 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H and l/h property, book debts, credit balances, stocks and shares, documents deposited with bank, goodwill, licence, patents, trademarks, copyrights floating charge undertaking and all property assets and rights present and future.
    Persone aventi diritto
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transazioni
    • 07 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 dic 2003
    Consegnato il 07 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    11A sharpleshall street london t/no NGL124684 proceeds of sale floating security all property and assets present and future specific equitable charge shares insurances building contracts and guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transazioni
    • 07 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 28 mar 2002
    Consegnato il 09 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £181250.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chattels being studio one - control room, solid state logic console 6048, recall, g eq, bargraph metering emt remote, lh producers desk, rh patchbay, built in outboard wing g+ softwear computer, twin bemouli integral synchroniser system & 3 machine s/no. 1984, lexicon 224X with larc s/no. 1329 (for further details of chattels charged please see form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • State Securities PLC
    Transazioni
    • 09 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of mortgage
    Creato il 28 mar 2002
    Consegnato il 09 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property k/a 11A sharpleshall street london NW1 8YN t/n NGL124684.
    Persone aventi diritto
    • State Securities PLC
    Transazioni
    • 09 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 28 mar 2002
    Consegnato il 09 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • State Securities PLC
    Transazioni
    • 09 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 25 set 2001
    Consegnato il 27 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Cheval Property Finance PLC
    Transazioni
    • 27 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 dic 1999
    Consegnato il 23 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 11A sharplehall street london t/n NGL124684. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 nov 1999
    Consegnato il 20 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 mar 1997
    Consegnato il 12 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A charge by way of legal mortgage over 11A sharpleshall street harrow district t/no.ngl 124684 and the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 12 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 nov 1996
    Consegnato il 27 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 11A sharpleshall street london t/no NGL124684 &. together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Chartered Trust PLC
    Transazioni
    • 27 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 27 nov 1996
    Consegnato il 27 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that policy of assurance on the life of john richard hudson with legal and general assurance society under policy no 0083671925 and all monies assured by or to become payable under the said policy and the full benefit thereof.
    Persone aventi diritto
    • Chartered Trust PLC
    Transazioni
    • 27 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Corporate mortgage
    Creato il 11 apr 1995
    Consegnato il 27 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 1ST march 1995 including any modification or replacement thereof
    Brevi particolari
    Master transport selector fitted-serial number-1984. Mitsubishi X86032 track 1" digital recorder-serial number-4057201.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 mar 1995
    Consegnato il 21 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 dic 2006Inizio dell'amministrazione
    05 gen 2009Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Mark Katz
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Praticante
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Brian N Johnson
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Praticante
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    2
    DataTipo
    05 gen 2009Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Brian N Johnson
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11/15 William Road
    London
    Praticante
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11/15 William Road
    London
    Stephen Mark Katz
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Praticante
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    David Birne
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Praticante
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0