HTSS REALISATIONS LIMITED

HTSS REALISATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHTSS REALISATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02702383
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HTSS REALISATIONS LIMITED?

    • fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a. (25990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova HTSS REALISATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    7th Floor Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HTSS REALISATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HI-TECH STEEL SERVICES LIMITED21 mag 199221 mag 1992
    HIGH-TECH STEEL SERVICES LIMITED18 mag 199218 mag 1992
    SILVER SERIES LIMITED31 mar 199231 mar 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di HTSS REALISATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per HTSS REALISATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    18 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 apr 2017

    18 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 apr 2016

    10 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 apr 2015

    12 pagine4.68

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 10 apr 2014

    17 pagine2.24B

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Risultato della riunione dei creditori

    54 pagine2.23B

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed hi-tech steel services LIMITED\certificate issued on 18/12/13
    6 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name18 dic 2013

    Risoluzione di cambio di nome della società il 25 nov 2013

    RES15

    Risoluzioni

    Resolutions
    5 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 25 nov 2013

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    57 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    32 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da * 1 St Ann Street Manchester M2 7LR* in data 18 nov 2013

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Bold Industrial Park Neills Road Bold St Helens Merseyside WA9 4TU* in data 22 ott 2013

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 apr 2013

    Stato del capitale al 12 apr 2013

    • Capitale: GBP 85,000
    SH01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2012

    28 pagineAA

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2011

    29 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 giu 2012 al 31 dic 2011

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio consolidato redatto al 01 lug 2011

    29 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di HTSS REALISATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GORMAN, Ian Christopher
    76 Harboro Road
    M33 6GE Sale
    Cheshire
    Segretario
    76 Harboro Road
    M33 6GE Sale
    Cheshire
    British27325370002
    GARDNER, Christopher Michael
    Merrybent Drive
    Merrybent
    DL2 2JZ Darlington
    17
    County Durham
    United Kingdom
    Amministratore
    Merrybent Drive
    Merrybent
    DL2 2JZ Darlington
    17
    County Durham
    United Kingdom
    EnglandBritish32950590005
    GORMAN, Ian Christopher
    76 Harboro Road
    M33 6GE Sale
    Cheshire
    Amministratore
    76 Harboro Road
    M33 6GE Sale
    Cheshire
    EnglandBritish27325370002
    WELLS, Stephen William
    The Firs
    Frog Lane Milton Green
    CH3 9DN Tattenhall
    Cheshire
    Amministratore
    The Firs
    Frog Lane Milton Green
    CH3 9DN Tattenhall
    Cheshire
    United KingdomBritish4650510001
    WOODWARD, Peter
    10 Arncliffe Grove
    DL3 8UN Darlington
    County Durham
    Amministratore
    10 Arncliffe Grove
    DL3 8UN Darlington
    County Durham
    Great BritainBritish56667770001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    MACHIN, Robert William
    64 Elm Drive
    Holmes Chapel
    CW4 7QG Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    64 Elm Drive
    Holmes Chapel
    CW4 7QG Crewe
    Cheshire
    EnglandBritish56667950001
    WILBERFORCE, Barry
    Wood Cottage
    Whitchurch Road
    CW6 9RU Spurstow
    Cheshire
    Amministratore
    Wood Cottage
    Whitchurch Road
    CW6 9RU Spurstow
    Cheshire
    Great BritainBritish27325380002
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    HTSS REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 20 ago 2010
    Consegnato il 24 ago 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 24 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 30 mag 2008
    Consegnato il 03 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 03 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 mag 1996
    Consegnato il 05 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Invoice Discounting Limited
    Transazioni
    • 05 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 21 ott 1993
    Consegnato il 28 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a factoring agreement, leasing agreement or otherwise
    Brevi particolari
    The ultimate balance due or owing to the company by tih under any factoring agreement and the ultimate balance due or owing to the company by tih under a factoring agreement dated 6/10/93 and all other book and other debts and claims due or owing to or purchased or acquired by the company and the full benefit of all rights and remedies relating thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Trade Indemnity-Heller Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 28 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 mag 1992
    Consegnato il 27 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    HTSS REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 ott 2013Inizio dell'amministrazione
    10 apr 2014Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Thornhill
    1 St Ann Street
    M2 7LR Manchester
    Praticante
    1 St Ann Street
    M2 7LR Manchester
    Geoffrey Paul Rowley
    1 St Ann Street
    M2 7LR Manchester
    Praticante
    1 St Ann Street
    M2 7LR Manchester
    2
    DataTipo
    10 apr 2014Inizio della liquidazione
    06 ott 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Geoffrey Paul Rowley
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Liquidatore proposto
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    David Thornhill
    7th Floor Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Liquidatore proposto
    7th Floor Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Geoffrey Paul Rowley
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Praticante
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    David Thornhill
    7th Floor Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Praticante
    7th Floor Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0