KRYSTAL FOUNTAIN WATER CO. LIMITED

KRYSTAL FOUNTAIN WATER CO. LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKRYSTAL FOUNTAIN WATER CO. LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02703619
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KRYSTAL FOUNTAIN WATER CO. LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova KRYSTAL FOUNTAIN WATER CO. LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit D Fleming Centre
    Fleming Way
    RH10 9NN Crawley
    West Sussex
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KRYSTAL FOUNTAIN WATER CO. LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SURFFLEX LIMITED03 apr 199203 apr 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di KRYSTAL FOUNTAIN WATER CO. LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per KRYSTAL FOUNTAIN WATER CO. LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per KRYSTAL FOUNTAIN WATER CO. LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Yariv Shapira come amministratore in data 05 feb 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Olivier Plouvin come amministratore in data 05 feb 2016

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 201 Bedford Avenue Slough Berkshire SL1 4RY a Unit D Fleming Centre Fleming Way Crawley West Sussex RH10 9NN in data 18 feb 2016

    1 pagineAD01

    Nomina di Brian Richard Macpherson come amministratore in data 05 feb 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 apr 2015

    Stato del capitale al 30 apr 2015

    • Capitale: GBP 7.7631
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 mag 2014

    Stato del capitale al 02 mag 2014

    • Capitale: GBP 7.7631
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012

    4 pagineAA

    Nomina di Maclay Murray & Spens Llp come segretario

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Sf Secretaries Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 03 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Stato del capitale al 18 gen 2011

    • Capitale: GBP 7.76
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    legacy

    2 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di KRYSTAL FOUNTAIN WATER CO. LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    Segretario
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSO300744
    119967690001
    MACPHERSON, Brian Richard
    Fleming Centre
    Fleming Way
    RH10 9NN Crawley
    Unit D
    West Sussex
    England
    Amministratore
    Fleming Centre
    Fleming Way
    RH10 9NN Crawley
    Unit D
    West Sussex
    England
    ScotlandBritish205282630001
    DIAS, Nathan Chaim
    Flat 4 Berkeley Court
    Glentworth Street
    NW1 5NA London
    Segretario
    Flat 4 Berkeley Court
    Glentworth Street
    NW1 5NA London
    British131426160001
    EDWARDS, Benjamin
    30a Eagle Road
    HA0 4SJ Wembley
    Middlesex
    Segretario
    30a Eagle Road
    HA0 4SJ Wembley
    Middlesex
    British57686240001
    HARVEY, Kristine
    2 Kinneil House
    The Furlongs
    ML3 0DX Hamilton
    South Lanarkshire
    Segretario
    2 Kinneil House
    The Furlongs
    ML3 0DX Hamilton
    South Lanarkshire
    British90110940001
    STORDY, Lawrence John
    1959 Woodlawn Terrace
    Halifax
    Nova Scotia B3h 4g5
    Canada
    Segretario
    1959 Woodlawn Terrace
    Halifax
    Nova Scotia B3h 4g5
    Canada
    Canadian55997150001
    WOOLFORD, Paul Richard Charles
    11 Bernard Mansion
    Herbrand Street
    WC1N 1LB London
    Segretario
    11 Bernard Mansion
    Herbrand Street
    WC1N 1LB London
    British56964920001
    MBC SECRETARIES LIMITED
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    Segretario nominato
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    900000700001
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    94529700001
    SF SECRETARIES LIMITED
    St. Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    123
    United Kingdom
    Segretario nominato
    St. Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    123
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC128549
    900029010002
    ALLEN, Stewart Ernest
    Flat 5 1 Saint Swithins Street
    WR1 2PY Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Flat 5 1 Saint Swithins Street
    WR1 2PY Worcester
    Worcestershire
    Canadian57767250005
    BRINDLEY, Philippa Lucy
    Chemin Aime Steinlen 10
    FOREIGN Lausanne
    1004
    Switzerland
    Amministratore
    Chemin Aime Steinlen 10
    FOREIGN Lausanne
    1004
    Switzerland
    British121958280001
    CUNIA, Gadi
    Rte Des Monts-De-Lavaux 496
    La Croix-Sur-Lutry
    Ch-1090
    Switzerland
    Amministratore
    Rte Des Monts-De-Lavaux 496
    La Croix-Sur-Lutry
    Ch-1090
    Switzerland
    Israeli95798400001
    DIAS, Nathan Chaim
    Flat 4 Berkeley Court
    Glentworth Street
    NW1 5NA London
    Amministratore
    Flat 4 Berkeley Court
    Glentworth Street
    NW1 5NA London
    EnglandBritish131426160001
    GREENFIELD, Marvin Elliot
    477 Madison Avenue
    Suite 701
    NX10022 New York
    Usa
    Amministratore
    477 Madison Avenue
    Suite 701
    NX10022 New York
    Usa
    American29075950003
    GUTTINGER, Antoine Jean Yves
    Rue De Zurich,42
    FOREIGN Ch-1201, Geneva
    Switzerland
    Amministratore
    Rue De Zurich,42
    FOREIGN Ch-1201, Geneva
    Switzerland
    French91634680002
    HECKER, Michael
    Ch. De La Bernadez, Ch-1094
    FOREIGN Paudex
    Switzerland
    Amministratore
    Ch. De La Bernadez, Ch-1094
    FOREIGN Paudex
    Switzerland
    Swiss95785580001
    HOWIE, William
    22 East Heath Road
    Hampstead
    NW3 1AH London
    9 Ladywell Court
    Amministratore
    22 East Heath Road
    Hampstead
    NW3 1AH London
    9 Ladywell Court
    United KingdomBritish131129520001
    KITLEY, Robert Gowan
    Holywell Terrace
    Holywell Street
    SY2 5DF Shrewsbury
    1
    Uk
    Amministratore
    Holywell Terrace
    Holywell Street
    SY2 5DF Shrewsbury
    1
    Uk
    United KingdomBritish133941020001
    KITLEY, Robert Gowan
    113 Abbey Foregate
    SY2 6BA Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    113 Abbey Foregate
    SY2 6BA Shrewsbury
    Shropshire
    British74088350003
    MITCHISON, Matthew
    30 Yerbury Road
    N19 4RJ London
    Amministratore
    30 Yerbury Road
    N19 4RJ London
    British101417360001
    PLOUVIN, Olivier
    59 Rue Du General Leclerc
    Audresy
    78570
    France
    Amministratore
    59 Rue Du General Leclerc
    Audresy
    78570
    France
    FranceFrench124866330001
    POLISKIN, Arnold Simon
    333 Rector Place
    NY 10280 New York City
    U S A
    Amministratore
    333 Rector Place
    NY 10280 New York City
    U S A
    American43006330001
    SCHICKLI, Dillon
    8951 Bald Eagle Drive
    Blaine
    Wa 98230
    Usa
    Amministratore
    8951 Bald Eagle Drive
    Blaine
    Wa 98230
    Usa
    American58715400004
    SHAPIRA, Yariv
    Hod-Hasharon
    Zamir 39
    45350
    Israel
    Amministratore
    Hod-Hasharon
    Zamir 39
    45350
    Israel
    IsraelIsraeli136488220001
    STEPHENS, Richard Wayne
    9 Bury Farm
    HP7 0SJ Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    9 Bury Farm
    HP7 0SJ Amersham
    Buckinghamshire
    Canadian88863720001
    WOOLFORD, Paul Richard Charles
    11 Bernard Mansion
    Herbrand Street
    WC1N 1LB London
    Amministratore
    11 Bernard Mansion
    Herbrand Street
    WC1N 1LB London
    United KingdomBritish56964920001
    MBC NOMINEES LIMITED
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    Amministratore delegato nominato
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    900000690001

    KRYSTAL FOUNTAIN WATER CO. LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 13TH may 1998
    Creato il 01 set 1998
    Consegnato il 16 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (as security agent) and/or the secured parties (as defined) or any of them; under or pursuant to the credit agreement dated 30TH april 1998 and/or the charge and/or the guarantee and debenture and/or any ancillary documents contemplated by the credit agreement and all obligations due or to become due from the borrowers (as defined) to the secured parties or any of them; under or pursuant to the credit agreement and/or any ancillary documents contemplated by the credit agreement (including any treasury contracts (as defined)) and by the other companies under or pursuant to the guarantee and debenture
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Toronto-Dominion Bank, (London Branch) as Security Agent
    Transazioni
    • 16 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 gen 1997
    Consegnato il 13 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 feb 1996
    Consegnato il 09 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ballydine Investments Limited
    Transazioni
    • 09 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 gen 1993
    Consegnato il 03 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Nmc Corp.
    Transazioni
    • 03 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0