BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02703724 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Chapman House Farnham Business Park GU9 8QL Farnham Surrey |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | 03 apr 1992 | 03 apr 1992 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2019 al 30 set 2020 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2020 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Btg Plc come persona con controllo significativo il 29 ago 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 5 Fleet Place London EC4M 7rd United Kingdom a 100 New Bridge Street London EC4V 6JA | 1 pagine | AD02 | ||||||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 100 New Bridge Street London EC4V 6JA | 1 pagine | AD03 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Timothy John Martel come amministratore in data 28 feb 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Nomina di Jonathan Richard Monson come amministratore in data 28 feb 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Elaine Maureen Johnston come segretario in data 28 feb 2020 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Elaine Maureen Johnston come amministratore in data 28 feb 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Nomina di Vance Ronald Brown come segretario in data 28 feb 2020 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||||||
Nomina di Vance Ronald Brown come amministratore in data 28 feb 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Nomina di Abogado Nominees Limited come segretario in data 16 ott 2019 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 02 dic 2019
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2019 | 19 pagine | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||||||
Stato del capitale al 02 dic 2019
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2020 al 31 dic 2019 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di John Richard Sylvester come amministratore in data 19 ago 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN, Vance Ronald | Segretario | Boston Scientific Way Marlborough 300 Ma 01752 United States | 267650420001 | |||||||||||
| ABOGADO NOMINEES LIMITED | Segretario | New Bridge Street EC4V 6JA London 100 United Kingdom |
| 73539350001 | ||||||||||
| BROWN, Vance Ronald | Amministratore | Boston Scientific Way Marlborough 300 Ma 01752 United States | United States | Canadian | 188829030001 | |||||||||
| MONSON, Jonathan Richard | Amministratore | Boston Scientific Way Marlborough 300 Ma 01752 United States | United States | American | 263413340001 | |||||||||
| ARDILL, Ian Leslie | Segretario | 21 Springfield GU18 5XP Lightwater Surrey | Northern Irish | 87485640001 | ||||||||||
| BARDWELL, John Edward | Segretario | 12 Beaufort Road SO23 9ST Winchester Hampshire | British | 14008990002 | ||||||||||
| EVANS, Fiona Maria | Segretario | 164 Duke Road Chiswick W4 2DF London | British | 49259690004 | ||||||||||
| HUNT, Michael Elliott | Segretario | Little Bourne Lavander Lane Rowledge GU10 4AX Farnham Surrey | British | 64386630001 | ||||||||||
| JOHNSTON, Elaine Maureen | Segretario | Chapman House Farnham Business Park GU9 8QL Farnham Surrey | 254569490001 | |||||||||||
| JONES, Lygia Jane | Segretario | Chapman House Farnham Business Park GU9 8QL Farnham Surrey | 166927230001 | |||||||||||
| MCLEAN, Suzanne Victoria | Segretario | 17 Elthiron Road SW6 4BN London | British | 39673610001 | ||||||||||
| MUSSENDEN, Paul Justin | Segretario | c/o Btg Plc Fleet Place EC4M 7RD London 5 | British | 157527420001 | ||||||||||
| STEADMAN, Julian Alex | Segretario | 3 Hill Place SL2 3EW Farnham Common Buckinghamshire | British | 43224360003 | ||||||||||
| ARDILL, Ian Leslie | Amministratore | 21 Springfield GU18 5XP Lightwater Surrey | England | Northern Irish | 87485640001 | |||||||||
| BARDWELL, John Edward | Amministratore | 12 Beaufort Road SO23 9ST Winchester Hampshire | British | 14008990002 | ||||||||||
| BONFIELD, William, Professor | Amministratore | 48 Harmer Green Lane AL6 0AT Welwyn Hertfordshire | England | British | 69066360001 | |||||||||
| BROWN, Gerry | Amministratore | 10 Elsley Road Tilehurst RG31 6RN Reading Berkshire | British | 109952650001 | ||||||||||
| CAHILL, Linda | Amministratore | 185 Ridge Road FOREIGN Lebanon New Jersey 08833 Usa | American | 26982780001 | ||||||||||
| CHAPMAN, Dennis, Professor | Amministratore | 10 One Tree Lane HP9 2BU Beaconsfield Buckinghamshire | British | 9340710002 | ||||||||||
| CHARLES, Stephen Alexander, Dr | Amministratore | 54 Ravencroft OX6 0YQ Bicester Oxon | British | 49912850002 | ||||||||||
| CLOHERTY, Patricia Mary | Amministratore | 155 Main Street Cold Springs Ny 10516 Usa | American | 47855820001 | ||||||||||
| CURNOCK COOK, Jeremy Lawrence | Amministratore | King Street St James's SW1Y 6RJ London 33 | United Kingdom | British | 47197010003 | |||||||||
| ENWRIGHT, Patrick | Amministratore | 1285 Avenue Of Americas New York Ny Usa | British | 34572210001 | ||||||||||
| FAIREY, Anne, Doctor | Amministratore | 6 Rasset Mead Church Crookham GU52 6DG Fleet Hampshire | British | 86855160001 | ||||||||||
| GRANT, James Deneale | Amministratore | 860 Fifth Avenue USA New York Ny10021 | American | 38496640001 | ||||||||||
| HACKER, Ann Veronica | Amministratore | Badgers Wood Beaver Lane GU46 6XJ Yateley Hampshire | British | 66948800001 | ||||||||||
| HAMBRO, James Daryl | Amministratore | 15 Elm Park Road SW3 6BP London | United Kingdom | British | 53684400001 | |||||||||
| HANKINSON, David Roger Lindon | Amministratore | The Brambles Loudwater Lane WD3 4HY Rickmansworth Hertfordshire | British | 34175410001 | ||||||||||
| HARGREAVES, Gordon | Amministratore | Little Garth Woodlands Road West GU25 4PL Virginia Water Surrey | British | 34572200001 | ||||||||||
| HARRIS, Thomas George, Sir | Amministratore | 18 Telfords Yard 6-8 The Highway E1W 2BQ London | United Kingdom | British | 103538280002 | |||||||||
| JOHNSTON, Elaine Maureen | Amministratore | Chapman House Farnham Business Park GU9 8QL Farnham Surrey | United Kingdom | Irish | 241923740002 | |||||||||
| KAPASH, Richard Jules, Dr | Amministratore | 317 Woodards Ford Road Chesapeake Va 23322 Usa | American | 60509420002 | ||||||||||
| KEEN, Nigel John | Amministratore | 19 Pembroke Square W8 6PA London | England | British | 166130001 | |||||||||
| MAKIN, Pamela Louise, Dame | Amministratore | 5 Fleet Place EC4M 7RD London Btg Plc | England | British | 111491920002 | |||||||||
| MARTEL, Timothy John | Amministratore | Chapman House Farnham Business Park GU9 8QL Farnham Surrey | United Kingdom | British | 241967150001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btg Limited | 06 apr 2016 | New Bridge Street EC4V 6JA London 100 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed supplemental to the instrument constituting $20,000,000 floating rate convertible bonds due 2007, dated 5 july 2001 | Creato il 20 set 2001 Consegnato il 21 set 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on $20,000,000 floating convertible bonds due 2007 issued by the company and constituted by the instrument dated 5 july 2001 | |
Brevi particolari 10 ordinary shares of us$1 each in the share capital of biodivysio limited (the secured property) the company shall be entitled to exercise or direct the exercise of the voting and other rights attached to the secured property and shall be entitled to retain any dividend (as defined in the fourth schedule of the deed). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Instrument constituting $20,000,000 floating rate convertible bonds due 2007 dated 5 july 2001 | Creato il 05 lug 2001 Consegnato il 19 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The payment of principal and interest on $20,000,000 floating convertible bonds due 2007 issued by the company and constituted by the instrument of even date | |
Brevi particolari 48 ordinary shares of us$1 each in the share capital of biodivysio limited ("the secured property") in accordance with the fourth schedule of the instrument subject to what follows below the company shall be entitled to exercise or direct the exercise of the voting and other rights attached to the secured property and shall be entitled to retain any dividend (as defined in the fourth schedule) derived from the secured property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge of deposit | Creato il 09 mar 2000 Consegnato il 14 mar 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All the company's liabilities to the chargee under a counter indemnity dated 9 march 2000 and entered into by the company in favour of the bank in connection with a guarantee dated 9 march 2000 issued by the bank to guarantee the obligations of the company under certain loans to be issued by the company pursuant to the terms of a loan note instrument dated 9 march 2000 | |
Brevi particolari All deposits now and in the future credited to account designation 21340874 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Instrument | Creato il 24 ott 1999 Consegnato il 10 nov 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The payment of the principal and interest due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed | |
Brevi particolari 32 ordinary shares of us$1 each in share capital of biodivysio limited together with dividends and bonuses. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 20 mag 1997 Consegnato il 28 mag 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 20TH may 1997 and/or this deed | |
Brevi particolari The contents of the deposit fund held in the name of blake lapthorn solicitors at national westminster bank PLC or other reputable bank or building society of the chargee's choosing being £58,000 exclusive of vat. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 17 mar 1997 Consegnato il 21 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 31ST january 1996 | |
Brevi particolari A rent deposit of £58,000. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment | Creato il 06 dic 1996 Consegnato il 13 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee under the facility letter and/or the assignment | |
Brevi particolari All rights of the company in and to each of the assigned cash which meansall sums of money which may now or in future be deposited in the name of the company in designated account together with all interest thereon and the debts represented by such sums and interest. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 28 mag 1996 Consegnato il 01 giu 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 1ST december 1995 and/or this deed | |
Brevi particolari The "deposit account" as defined in the rent deposit deed, namely:- an interest bearing account opened by the chargee's solicitors have placed the deposit sum being £85,140. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment | Creato il 07 mag 1996 Consegnato il 17 mag 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the facility letter and/or the assignment together being the "secured liabilities" | |
Brevi particolari The assigned assets and the charged assets as defined in the continuation sheet attached to the form 395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0