BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED

BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02703724
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Chapman House
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY03 apr 199203 apr 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2019 al 30 set 2020

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2020 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Btg Plc come persona con controllo significativo il 29 ago 2019

    2 paginePSC05

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 5 Fleet Place London EC4M 7rd United Kingdom a 100 New Bridge Street London EC4V 6JA

    1 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 100 New Bridge Street London EC4V 6JA

    1 pagineAD03

    Cessazione della carica di Timothy John Martel come amministratore in data 28 feb 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Jonathan Richard Monson come amministratore in data 28 feb 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Elaine Maureen Johnston come segretario in data 28 feb 2020

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Elaine Maureen Johnston come amministratore in data 28 feb 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Vance Ronald Brown come segretario in data 28 feb 2020

    2 pagineAP03

    Nomina di Vance Ronald Brown come amministratore in data 28 feb 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Abogado Nominees Limited come segretario in data 16 ott 2019

    2 pagineAP04

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 02/12/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    resolution

    Risoluzione di capitalizzazione o emissione di azioni bonus

    Sum of £12250000 is capitalised 02/12/2019
    RES14

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 02 dic 2019

    • Capitale: GBP 21,106,623.92
    4 pagineSH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2019

    19 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 02 dic 2019

    • Capitale: GBP 0.215638
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2020 al 31 dic 2019

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di John Richard Sylvester come amministratore in data 19 ago 2019

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROWN, Vance Ronald
    Boston Scientific Way
    Marlborough
    300
    Ma 01752
    United States
    Segretario
    Boston Scientific Way
    Marlborough
    300
    Ma 01752
    United States
    267650420001
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    Segretario
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione1688036
    73539350001
    BROWN, Vance Ronald
    Boston Scientific Way
    Marlborough
    300
    Ma 01752
    United States
    Amministratore
    Boston Scientific Way
    Marlborough
    300
    Ma 01752
    United States
    United StatesCanadian188829030001
    MONSON, Jonathan Richard
    Boston Scientific Way
    Marlborough
    300
    Ma 01752
    United States
    Amministratore
    Boston Scientific Way
    Marlborough
    300
    Ma 01752
    United States
    United StatesAmerican263413340001
    ARDILL, Ian Leslie
    21 Springfield
    GU18 5XP Lightwater
    Surrey
    Segretario
    21 Springfield
    GU18 5XP Lightwater
    Surrey
    Northern Irish87485640001
    BARDWELL, John Edward
    12 Beaufort Road
    SO23 9ST Winchester
    Hampshire
    Segretario
    12 Beaufort Road
    SO23 9ST Winchester
    Hampshire
    British14008990002
    EVANS, Fiona Maria
    164 Duke Road
    Chiswick
    W4 2DF London
    Segretario
    164 Duke Road
    Chiswick
    W4 2DF London
    British49259690004
    HUNT, Michael Elliott
    Little Bourne Lavander Lane
    Rowledge
    GU10 4AX Farnham
    Surrey
    Segretario
    Little Bourne Lavander Lane
    Rowledge
    GU10 4AX Farnham
    Surrey
    British64386630001
    JOHNSTON, Elaine Maureen
    Chapman House
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Surrey
    Segretario
    Chapman House
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Surrey
    254569490001
    JONES, Lygia Jane
    Chapman House
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Surrey
    Segretario
    Chapman House
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Surrey
    166927230001
    MCLEAN, Suzanne Victoria
    17 Elthiron Road
    SW6 4BN London
    Segretario
    17 Elthiron Road
    SW6 4BN London
    British39673610001
    MUSSENDEN, Paul Justin
    c/o Btg Plc
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    Segretario
    c/o Btg Plc
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    British157527420001
    STEADMAN, Julian Alex
    3 Hill Place
    SL2 3EW Farnham Common
    Buckinghamshire
    Segretario
    3 Hill Place
    SL2 3EW Farnham Common
    Buckinghamshire
    British43224360003
    ARDILL, Ian Leslie
    21 Springfield
    GU18 5XP Lightwater
    Surrey
    Amministratore
    21 Springfield
    GU18 5XP Lightwater
    Surrey
    EnglandNorthern Irish87485640001
    BARDWELL, John Edward
    12 Beaufort Road
    SO23 9ST Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    12 Beaufort Road
    SO23 9ST Winchester
    Hampshire
    British14008990002
    BONFIELD, William, Professor
    48 Harmer Green Lane
    AL6 0AT Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    48 Harmer Green Lane
    AL6 0AT Welwyn
    Hertfordshire
    EnglandBritish69066360001
    BROWN, Gerry
    10 Elsley Road
    Tilehurst
    RG31 6RN Reading
    Berkshire
    Amministratore
    10 Elsley Road
    Tilehurst
    RG31 6RN Reading
    Berkshire
    British109952650001
    CAHILL, Linda
    185 Ridge Road
    FOREIGN Lebanon
    New Jersey 08833
    Usa
    Amministratore
    185 Ridge Road
    FOREIGN Lebanon
    New Jersey 08833
    Usa
    American26982780001
    CHAPMAN, Dennis, Professor
    10 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    10 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British9340710002
    CHARLES, Stephen Alexander, Dr
    54 Ravencroft
    OX6 0YQ Bicester
    Oxon
    Amministratore
    54 Ravencroft
    OX6 0YQ Bicester
    Oxon
    British49912850002
    CLOHERTY, Patricia Mary
    155 Main Street
    Cold Springs
    Ny 10516
    Usa
    Amministratore
    155 Main Street
    Cold Springs
    Ny 10516
    Usa
    American47855820001
    CURNOCK COOK, Jeremy Lawrence
    King Street
    St James's
    SW1Y 6RJ London
    33
    Amministratore
    King Street
    St James's
    SW1Y 6RJ London
    33
    United KingdomBritish47197010003
    ENWRIGHT, Patrick
    1285 Avenue Of Americas
    New York Ny
    Usa
    Amministratore
    1285 Avenue Of Americas
    New York Ny
    Usa
    British34572210001
    FAIREY, Anne, Doctor
    6 Rasset Mead
    Church Crookham
    GU52 6DG Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    6 Rasset Mead
    Church Crookham
    GU52 6DG Fleet
    Hampshire
    British86855160001
    GRANT, James Deneale
    860 Fifth Avenue
    USA New York
    Ny10021
    Amministratore
    860 Fifth Avenue
    USA New York
    Ny10021
    American38496640001
    HACKER, Ann Veronica
    Badgers Wood
    Beaver Lane
    GU46 6XJ Yateley
    Hampshire
    Amministratore
    Badgers Wood
    Beaver Lane
    GU46 6XJ Yateley
    Hampshire
    British66948800001
    HAMBRO, James Daryl
    15 Elm Park Road
    SW3 6BP London
    Amministratore
    15 Elm Park Road
    SW3 6BP London
    United KingdomBritish53684400001
    HANKINSON, David Roger Lindon
    The Brambles Loudwater Lane
    WD3 4HY Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Brambles Loudwater Lane
    WD3 4HY Rickmansworth
    Hertfordshire
    British34175410001
    HARGREAVES, Gordon
    Little Garth Woodlands Road West
    GU25 4PL Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Little Garth Woodlands Road West
    GU25 4PL Virginia Water
    Surrey
    British34572200001
    HARRIS, Thomas George, Sir
    18 Telfords Yard
    6-8 The Highway
    E1W 2BQ London
    Amministratore
    18 Telfords Yard
    6-8 The Highway
    E1W 2BQ London
    United KingdomBritish103538280002
    JOHNSTON, Elaine Maureen
    Chapman House
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Chapman House
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Surrey
    United KingdomIrish241923740002
    KAPASH, Richard Jules, Dr
    317 Woodards Ford Road
    Chesapeake
    Va 23322
    Usa
    Amministratore
    317 Woodards Ford Road
    Chesapeake
    Va 23322
    Usa
    American60509420002
    KEEN, Nigel John
    19 Pembroke Square
    W8 6PA London
    Amministratore
    19 Pembroke Square
    W8 6PA London
    EnglandBritish166130001
    MAKIN, Pamela Louise, Dame
    5 Fleet Place
    EC4M 7RD London
    Btg Plc
    Amministratore
    5 Fleet Place
    EC4M 7RD London
    Btg Plc
    EnglandBritish111491920002
    MARTEL, Timothy John
    Chapman House
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Chapman House
    Farnham Business Park
    GU9 8QL Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish241967150001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    06 apr 2016
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleLaws Of England
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02670500
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BIOCOMPATIBLES INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed supplemental to the instrument constituting $20,000,000 floating rate convertible bonds due 2007, dated 5 july 2001
    Creato il 20 set 2001
    Consegnato il 21 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on $20,000,000 floating convertible bonds due 2007 issued by the company and constituted by the instrument dated 5 july 2001
    Brevi particolari
    10 ordinary shares of us$1 each in the share capital of biodivysio limited (the secured property) the company shall be entitled to exercise or direct the exercise of the voting and other rights attached to the secured property and shall be entitled to retain any dividend (as defined in the fourth schedule of the deed).
    Persone aventi diritto
    • Abbott Laboratories
    Transazioni
    • 21 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Instrument constituting $20,000,000 floating rate convertible bonds due 2007 dated 5 july 2001
    Creato il 05 lug 2001
    Consegnato il 19 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The payment of principal and interest on $20,000,000 floating convertible bonds due 2007 issued by the company and constituted by the instrument of even date
    Brevi particolari
    48 ordinary shares of us$1 each in the share capital of biodivysio limited ("the secured property") in accordance with the fourth schedule of the instrument subject to what follows below the company shall be entitled to exercise or direct the exercise of the voting and other rights attached to the secured property and shall be entitled to retain any dividend (as defined in the fourth schedule) derived from the secured property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abbott Laboratories and Other Bondholders from Time to Time
    Transazioni
    • 19 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of deposit
    Creato il 09 mar 2000
    Consegnato il 14 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the company's liabilities to the chargee under a counter indemnity dated 9 march 2000 and entered into by the company in favour of the bank in connection with a guarantee dated 9 march 2000 issued by the bank to guarantee the obligations of the company under certain loans to be issued by the company pursuant to the terms of a loan note instrument dated 9 march 2000
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 21340874 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Instrument
    Creato il 24 ott 1999
    Consegnato il 10 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The payment of the principal and interest due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Brevi particolari
    32 ordinary shares of us$1 each in share capital of biodivysio limited together with dividends and bonuses. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bondholders from Time to Time
    Transazioni
    • 10 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 20 mag 1997
    Consegnato il 28 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 20TH may 1997 and/or this deed
    Brevi particolari
    The contents of the deposit fund held in the name of blake lapthorn solicitors at national westminster bank PLC or other reputable bank or building society of the chargee's choosing being £58,000 exclusive of vat.
    Persone aventi diritto
    • Store Property Investments Limited
    Transazioni
    • 28 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 17 mar 1997
    Consegnato il 21 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 31ST january 1996
    Brevi particolari
    A rent deposit of £58,000.
    Persone aventi diritto
    • Juno Properties Limited
    Transazioni
    • 21 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment
    Creato il 06 dic 1996
    Consegnato il 13 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee under the facility letter and/or the assignment
    Brevi particolari
    All rights of the company in and to each of the assigned cash which meansall sums of money which may now or in future be deposited in the name of the company in designated account together with all interest thereon and the debts represented by such sums and interest. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Merrill Lynch International Bank Limited
    Transazioni
    • 13 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 28 mag 1996
    Consegnato il 01 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 1ST december 1995 and/or this deed
    Brevi particolari
    The "deposit account" as defined in the rent deposit deed, namely:- an interest bearing account opened by the chargee's solicitors have placed the deposit sum being £85,140. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Store Property Investments Limited
    Transazioni
    • 01 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment
    Creato il 07 mag 1996
    Consegnato il 17 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the facility letter and/or the assignment together being the "secured liabilities"
    Brevi particolari
    The assigned assets and the charged assets as defined in the continuation sheet attached to the form 395.
    Persone aventi diritto
    • Merrill Lynch International Bank Limited
    Transazioni
    • 17 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0