HERRADURA LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHERRADURA LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02703869
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HERRADURA LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HERRADURA LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HERRADURA LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LANGBOURN PROPERTY NOMINEES (NO. 1) LIMITED06 apr 199206 apr 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di HERRADURA LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per HERRADURA LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 16 nov 2020

    LRESSP

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Neil Gordon Aiken come amministratore in data 07 gen 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di James Cameron Wall come amministratore in data 07 gen 2020

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 apr 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 apr 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 apr 2016

    Stato del capitale al 04 apr 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 01 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 apr 2015

    Stato del capitale al 23 apr 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 apr 2014

    Stato del capitale al 07 apr 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    9 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HERRADURA LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WALL, James Cameron
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    Segretario
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    British11724060005
    BURROWS, Paul Richard
    Gresham Street
    EC2V 7PG London
    30
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7PG London
    30
    United KingdomEnglish126643220002
    LEVY, Anthony David
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    Amministratore
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    United KingdomBritish98888430001
    AMEY, Michelle
    4 Holme Road
    RM11 3QS Hornchurch
    Essex
    Segretario
    4 Holme Road
    RM11 3QS Hornchurch
    Essex
    British57746950002
    ASCHAM, Kathleen Rose
    26 Penns Road
    GU32 2EN Petersfield
    Hampshire
    Segretario
    26 Penns Road
    GU32 2EN Petersfield
    Hampshire
    British48164460001
    BENTICK-OWENS, Pia Anne Maria
    41 Amhurst Gardens
    TW7 6AN Isleworth
    Middlesex
    Segretario
    41 Amhurst Gardens
    TW7 6AN Isleworth
    Middlesex
    British53914450001
    DANIEL, Irina Marsovna
    Flat 1
    9 Cromwell Place
    SW7 2JN London
    Segretario
    Flat 1
    9 Cromwell Place
    SW7 2JN London
    British113609450004
    HOUGHTON, Claire Elizabeth
    21 Gilpin Road
    SG12 9LZ Ware
    Hertfordshire
    Segretario
    21 Gilpin Road
    SG12 9LZ Ware
    Hertfordshire
    British42693490001
    STEVENS, Andrew John
    3 Holly Cottages
    East End Lane
    CO7 6XG East Bergholt
    Essex
    Segretario
    3 Holly Cottages
    East End Lane
    CO7 6XG East Bergholt
    Essex
    British103050090001
    AIKEN, Neil Gordon
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    Amministratore
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    United KingdomBritish43380390001
    ALLEN, Peter John
    Hestia Woodland Way
    KT20 6PA Kingswood
    Surrey
    Amministratore
    Hestia Woodland Way
    KT20 6PA Kingswood
    Surrey
    EnglandBritish35130830001
    BARNES, Glenn
    16 Phillimore Gardens
    W8 7QE London
    Amministratore
    16 Phillimore Gardens
    W8 7QE London
    American65551660001
    BROOKS, Stephen John
    Talgarth
    Forest Road
    KT24 5BB East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Talgarth
    Forest Road
    KT24 5BB East Horsley
    Surrey
    British65674510002
    BURKE, Peter Robert
    11 Belvedere Grove
    Wimbledon
    SW19 7RQ London
    Amministratore
    11 Belvedere Grove
    Wimbledon
    SW19 7RQ London
    UkBritish106485040001
    CAVANAGH, Charles Terrence Stephen
    31 The Chase
    SW4 0NP London
    Amministratore
    31 The Chase
    SW4 0NP London
    British/American28962380001
    CHURCHILL-COLEMAN, Peter Edwin
    56 The Woodfields
    CR2 0HF Sanderstead
    Surrey
    Amministratore
    56 The Woodfields
    CR2 0HF Sanderstead
    Surrey
    EnglandBritish32456890001
    COLLINS, Keith Patrick
    11 Weald Road
    TN13 1QQ Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    11 Weald Road
    TN13 1QQ Sevenoaks
    Kent
    United KingdomIrish82321160001
    ELLIS, Peter Johnson
    La Barranca The Drive
    Tyrrells Wood
    KT22 8QH Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    La Barranca The Drive
    Tyrrells Wood
    KT22 8QH Leatherhead
    Surrey
    British11681810002
    FANE DE SALIS, Henrietta Frances Jane
    52 Colebrooke Row
    N1 8AF London
    Amministratore
    52 Colebrooke Row
    N1 8AF London
    British100519650004
    FREEMAN, Paul Richard
    Colletia
    Mill End Green Great Easton
    CM6 2DN Dunmow
    Essex
    Amministratore
    Colletia
    Mill End Green Great Easton
    CM6 2DN Dunmow
    Essex
    British65714870001
    GEIGER, Klaus Michael
    5 Gullivers Wharf
    104 Wapping Lane
    E1 9PJ London
    Amministratore
    5 Gullivers Wharf
    104 Wapping Lane
    E1 9PJ London
    German58951940002
    HUGHSON, Eric John
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    Amministratore
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    British121058230001
    KNOX, Lesley Mary Samuel
    23 Merton Lane
    N6 6NB London
    Amministratore
    23 Merton Lane
    N6 6NB London
    United KingdomBritish165715660002
    LONGCROFT, Peter Leonard
    4 Lakeside Close
    Reydon
    IP18 6YA Southwold
    Suffolk
    Amministratore
    4 Lakeside Close
    Reydon
    IP18 6YA Southwold
    Suffolk
    British32431030003
    LOWE, Stephen John
    20 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9EF London
    Amministratore
    20 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9EF London
    EnglandBritish31086660002
    LYNCH, Christopher Norman
    2 Lime Park
    Thorne Grove
    CM23 5LZ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    2 Lime Park
    Thorne Grove
    CM23 5LZ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British98874040002
    MOULD, Simon John
    19 Mckay Road
    SW20 0HT Wimbledon
    London
    Amministratore
    19 Mckay Road
    SW20 0HT Wimbledon
    London
    British81907350001
    POMFRET, Andrew David
    Beech House
    Duck Lane
    SG2 7LJ Benington
    Hertfordshire
    Amministratore
    Beech House
    Duck Lane
    SG2 7LJ Benington
    Hertfordshire
    United KingdomBritish35247140001
    REED, Sharon
    Flat 1
    15 Campden Hill Gardens
    W8 7AX London
    Amministratore
    Flat 1
    15 Campden Hill Gardens
    W8 7AX London
    American65711130001
    SCHRAGER VON ALTISHOFEN, Nicola Jane
    Oliver House Stud
    Ched Glow
    SN16 9EZ Malmesbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Oliver House Stud
    Ched Glow
    SN16 9EZ Malmesbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish110050670001
    THOMAS, Geraint Edward Bowen
    3 Lambourn Road
    SW4 0LX London
    Amministratore
    3 Lambourn Road
    SW4 0LX London
    British7429970001
    THOMAS, Jeremy David Nicholson
    Maddox Park
    Bookham
    KT23 3BW Leatherhead
    Haddon House
    Surrey
    Amministratore
    Maddox Park
    Bookham
    KT23 3BW Leatherhead
    Haddon House
    Surrey
    United KingdomBritish133776790001
    WALL, James Cameron
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    Amministratore
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    United KingdomBritish11724060005

    Chi sono le persone con controllo significativo di HERRADURA LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Gresham Street
    EC2V 7PG London
    30
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Gresham Street
    EC2V 7PG London
    30
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione681392
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    HERRADURA LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge over a cash deposit
    Creato il 25 lug 2006
    Consegnato il 07 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit and all rights and interests relating to the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dresdner Bank Ag
    Transazioni
    • 07 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over a cash deposit
    Creato il 12 lug 2006
    Consegnato il 02 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit being the sum of eur 350,000,000 together with all interests costs commissions and banking charges. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dresdner Bank Ag
    Transazioni
    • 02 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over a cash deposit
    Creato il 07 giu 2006
    Consegnato il 23 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit and all rights and interests whatsoever of the chargor relating to the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dresdner Bank Ag London Branch
    Transazioni
    • 23 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 01 feb 2006
    Consegnato il 14 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit and all rights and interests relating to the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dresdner Bank Ag London Branch
    Transazioni
    • 14 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over a cash deposit
    Creato il 18 lug 2005
    Consegnato il 29 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit being the sum of EUR600,000,000 deposited in the account being the chargor's account anlos a/c 14898200 gbp/eur (agent: DRESGB2L or 70-00-66) with the chargee, and all rights and interests relating to the deposit, together with all interests, costs, commissions and banking charges. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dresdner Bank Ag London Branch
    Transazioni
    • 29 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over a cash deposit
    Creato il 04 lug 2005
    Consegnato il 19 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit and all rights and interests whatsoever of the chargor relating to the deposit,by way of first fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dresdner Bank Ag
    Transazioni
    • 19 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HERRADURA LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 nov 2020Inizio della liquidazione
    15 feb 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0