B.I. REALISATIONS LIMITED

B.I. REALISATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàB.I. REALISATIONS LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02706460
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di B.I. REALISATIONS LIMITED?

    • (3420) /

    Dove si trova B.I. REALISATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Pricewaterhousecoopers Llp
    101 Barbirolli Square
    M2 3PW Lower Mosley Street Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di B.I. REALISATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BOALLOY INDUSTRIES LIMITED08 mar 199308 mar 1993
    LAW 427 LIMITED13 apr 199213 apr 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di B.I. REALISATIONS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 ott 2007
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 ago 2008
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2006

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per B.I. REALISATIONS LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al13 apr 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma27 apr 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per B.I. REALISATIONS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per B.I. REALISATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di Timothy Murray come amministratore in data 14 mar 2025

    1 pagineTM01

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 gen 2015

    5 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    4 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ott 2014

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 apr 2014

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ott 2013

    5 pagine4.68

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:court order-replacement liquidator
    12 pagineLIQ MISC OC

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 apr 2013

    19 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ott 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 apr 2012

    6 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ott 2011

    15 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 apr 2011

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ott 2010

    7 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 apr 2010

    18 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ott 2009

    13 pagine4.68

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:s/s cert.release of liquidator
    1 pagineLIQ MISC

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    7 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Chi sono gli amministratori di B.I. REALISATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HART, Dawn
    101 Mountsandel Road
    BT52 1TA Coleraine
    County Londonderry
    Segretario
    101 Mountsandel Road
    BT52 1TA Coleraine
    County Londonderry
    British121210700001
    ADAMS, Russell John
    Jessop Way
    Haslington
    CW1 5FU Crewe
    19
    Cheshire
    Amministratore
    Jessop Way
    Haslington
    CW1 5FU Crewe
    19
    Cheshire
    EnglandBritishProduction Director58008430002
    MURRAY, James
    71 Frosses Road
    BT53 7HN Ballymoney
    County Antrim
    Amministratore
    71 Frosses Road
    BT53 7HN Ballymoney
    County Antrim
    Northern IrelandBritishCompany Director117271120001
    MURRAY, Margaret Winifred
    71 Frosses Road
    BT53 7HN Ballymoney
    County Antrim
    Amministratore
    71 Frosses Road
    BT53 7HN Ballymoney
    County Antrim
    Northern IrelandBritishCompany Director117271100001
    MURRAY, Patrick
    71 Frosses Road
    BT53 7HN Ballymoney
    County Antrim
    Amministratore
    71 Frosses Road
    BT53 7HN Ballymoney
    County Antrim
    United KingdomBritishCompany Director117271170001
    HANCOCK, David Stanley
    171 Lache Lane
    CH4 7LU Chester
    Cheshire
    Segretario
    171 Lache Lane
    CH4 7LU Chester
    Cheshire
    BritishFinancial Director20642940001
    HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Segretario nominato
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008160001
    BROWN, Gerard
    20 Grey Road
    WA14 4BU Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    20 Grey Road
    WA14 4BU Altrincham
    Cheshire
    BritishManaging Director10069910001
    BUCKLEY, David Arthur
    Crows Nest Farm Mill Lane
    Moston
    CW11 3PT Sandbach
    Cheshire
    Amministratore
    Crows Nest Farm Mill Lane
    Moston
    CW11 3PT Sandbach
    Cheshire
    BritishProduction Director6733140001
    DUNCAN, James Blair, Sir
    17 Kingston House South
    Ennismore Gardens
    SW7 1NF London
    Amministratore
    17 Kingston House South
    Ennismore Gardens
    SW7 1NF London
    EnglandBritishChairman3477810001
    GIBB, James
    Tall Trees
    13 Barry Rise
    WA14 3JS Bowdon
    Cheshire
    Amministratore
    Tall Trees
    13 Barry Rise
    WA14 3JS Bowdon
    Cheshire
    BritishSales Marketing Director29108210002
    HANCOCK, David Stanley
    171 Lache Lane
    CH4 7LU Chester
    Cheshire
    Amministratore
    171 Lache Lane
    CH4 7LU Chester
    Cheshire
    BritishFinancial Director20642940001
    MURRAY, Timothy
    71 Frosses Road
    BT53 7HN Ballymoney
    County Antrim
    Amministratore
    71 Frosses Road
    BT53 7HN Ballymoney
    County Antrim
    BritishCompany Director117271150001
    POTTER, John Grahame
    42 Goughs Lane
    WA16 8QN Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    42 Goughs Lane
    WA16 8QN Knutsford
    Cheshire
    BritishTechnical Director20642960002
    WALEWSKI, Florian Claude Rene Colonna
    3 Avenue Rodin
    FOREIGN 75016 Paris
    France
    Amministratore
    3 Avenue Rodin
    FOREIGN 75016 Paris
    France
    FrenchDirector28387290001
    HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Amministratore delegato nominato
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008160001

    B.I. REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 05 lug 2007
    Consegnato il 10 lug 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The undertaking of the company and all its property present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank Limited
    Transazioni
    • 10 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over all book debts
    Creato il 05 lug 2007
    Consegnato il 10 lug 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts and other debts now and from time to time owing to the company.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank Limited
    Transazioni
    • 10 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Floating charge (all assets)
    Creato il 11 mar 2004
    Consegnato il 12 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited (the Security Holder)
    Transazioni
    • 12 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 02 mag 2002
    Consegnato il 04 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property at unit b kingsweston trading estate st andrews road bristol t/no: BL51372. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 feb 2001
    Consegnato il 03 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land and buildings on the west side of hayes lane stourbridge west midlands. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge (all assets)
    Creato il 23 ott 1998
    Consegnato il 28 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever whether arising under the agreement (as defined) or otherwise
    Brevi particolari
    All debts purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to an agreement for the purchase of debts (including the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the chargee for any reason. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Griffin Credit Services Limited
    Transazioni
    • 28 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Master agreement and charge
    Creato il 31 lug 1997
    Consegnato il 01 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or by virtue of any lease purchase,hire purchase,conditional sale or bailment agreement or under the charge
    Brevi particolari
    Any agreement made whether before on or after the date of the charge between the customer (as defined in the charge) and any person to whom the customer lets or agrees to let the goods on hire whereby the customer lets or agrees to let the goods forming the subject matter of any lease purchase,hire purchase,conditional sale or bailment agreement for full details please refer to form 395.
    Persone aventi diritto
    • Concord Equipment Finance Limited
    • Assetfinance Limited
    • Concord Leasing Limitedand All of the Other Companies Named Therein
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 01 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 31 lug 1997
    Consegnato il 31 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof.12 New m & g tri-axle air suspended straight frame semi-trailers complete with tautliner 2000 curtainsided bodywork.chassis nos,22845-22856 incl.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Group Limited
    Transazioni
    • 31 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 02 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 dic 1994
    Consegnato il 14 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that land comprising the "additional property" as defined within a deed of rectification of 12/8/94 (as defined)........relating to land/blds at radnor park industrial estate,back lane,congleton with all fixtures/fittings; the benefits of all rights,licences and goodwill of business.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 ago 1993
    Consegnato il 28 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property the land and buildings at back lane congleton cheshire. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 ago 1993
    Consegnato il 28 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F.h land on the north east side of back lane congleton. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 ago 1993
    Consegnato il 28 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property units 7 and 8 radnor park industrial estate back lane congleton. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 ago 1993
    Consegnato il 28 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings lying to the north east of back lane congleton. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 ago 1993
    Consegnato il 28 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property units 1 to 5 (inclusive) radnor prk industrial estate back lane congleton. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 ago 1993
    Consegnato il 28 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property unit 6 radnor park industrial estate back lane congleton. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 23 lug 1992
    Consegnato il 29 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    And patents. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    B.I. REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 ott 2007Inizio dell'amministrazione
    23 ott 2008Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Russell Stewart Cash
    Messrs Pricewaterhousecoopers
    101 Barbirolli Square
    M2 3PW Manchester
    Praticante
    Messrs Pricewaterhousecoopers
    101 Barbirolli Square
    M2 3PW Manchester
    Garth Andrew Calow
    Pricewaterhousecoopers
    Waterfront Plaza
    BT1 3LR 8 Laganbank Road
    Belfast
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers
    Waterfront Plaza
    BT1 3LR 8 Laganbank Road
    Belfast
    2
    DataTipo
    23 ott 2008Inizio della liquidazione
    30 apr 2015Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Russell Stewart Cash
    Messrs Pricewaterhousecoopers
    101 Barbirolli Square
    M2 3PW Manchester
    Praticante
    Messrs Pricewaterhousecoopers
    101 Barbirolli Square
    M2 3PW Manchester
    Garth Andrew Calow
    Pricewaterhousecoopers
    Waterfront Plaza
    BT1 3LR 8 Laganbank Road
    Belfast
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers
    Waterfront Plaza
    BT1 3LR 8 Laganbank Road
    Belfast
    Craig Livesey
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Paul Gerald Rooney
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Stephen Arthur Cave
    8 Waterfront Plaza Laganbank Road
    BT1 3LR Belfast
    County Antrim
    Praticante
    8 Waterfront Plaza Laganbank Road
    BT1 3LR Belfast
    County Antrim

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0