HYTORK CONTROLS LIMITED

HYTORK CONTROLS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHYTORK CONTROLS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02707915
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HYTORK CONTROLS LIMITED?

    • fabbricazione di pompe (28131) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova HYTORK CONTROLS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o EMERSON
    Accurist House
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HYTORK CONTROLS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HYTEK TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED16 apr 199216 apr 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di HYTORK CONTROLS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per HYTORK CONTROLS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Teresa Field come segretario in data 30 set 2016

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 mag 2016

    Stato del capitale al 10 mag 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di Ryan Lee Schrick come amministratore in data 30 set 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher David Burley come amministratore in data 30 set 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 apr 2015

    Stato del capitale al 30 apr 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 16 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 mag 2014

    Stato del capitale al 13 mag 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Mr Jeremy Rowley come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Eric Saussaye come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Mr Eric Saussaye come amministratore

    2 pagineAP01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata

    1 pagineAD04

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2012

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Ryan Lee Schrick come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Brian Mcginnis come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 16 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 6 Bracken Hill South West Industrial Estate Peterlee SR8 2LS* in data 04 mag 2012

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2011

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HYTORK CONTROLS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMITH, Victoria Jane
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    148912590001
    ROWLEY, Jeremy
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    EnglandBritish83374470001
    BURLEY, Christopher David
    5 The Spinney
    The Camp
    GL6 7HP Stroud
    Gloucestershire
    Segretario
    5 The Spinney
    The Camp
    GL6 7HP Stroud
    Gloucestershire
    British27439320002
    FIELD, Teresa
    c/o Emerson
    Floor Accurist House
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    2nd
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Emerson
    Floor Accurist House
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    2nd
    United Kingdom
    148883110001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRADSHAW, John Andrew
    Underleaf
    Upleaden
    GL18 Newent
    Glos
    Amministratore
    Underleaf
    Upleaden
    GL18 Newent
    Glos
    British31322070001
    BURLEY, Christopher David
    5 The Spinney
    The Camp
    GL6 7HP Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    5 The Spinney
    The Camp
    GL6 7HP Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritish27439320002
    CHURCH, Anthony
    381 Painswick Road
    Matson
    GL4 4DD Gloucester
    Gloucestershire
    Amministratore
    381 Painswick Road
    Matson
    GL4 4DD Gloucester
    Gloucestershire
    British69258420001
    DUNCAN, Rodney Alexander
    High Ridings Mill Lane
    Strensham
    WR8 9LB Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    High Ridings Mill Lane
    Strensham
    WR8 9LB Worcester
    Worcestershire
    British8556850001
    KELLY, Joseph Kevin Christopher
    17 Grovebury
    SO31 6PL Locks Heath
    Hampshire
    Amministratore
    17 Grovebury
    SO31 6PL Locks Heath
    Hampshire
    EnglandBritish164085470002
    MCCLUSKEY, Frederick Anthony
    12 Alpine Way
    SR3 1TN Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    12 Alpine Way
    SR3 1TN Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish104802100001
    MCGINNIS, Brian Paul
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    UsaUnited States141136680001
    SAUSSAYE, Eric
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    FranceFrench178235200001
    SCHRICK, Ryan Lee
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    UsaAmerican171439980001
    SHAW, Ralph Vincent
    104 Hunters Hill
    Alexandria
    Kentucky 41001
    Usa
    Amministratore
    104 Hunters Hill
    Alexandria
    Kentucky 41001
    Usa
    American72475510001
    STEWART, Duncan Ross
    The Old Vicarage
    Gloucester Road, Upleadon
    GL18 1EJ Newent
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Gloucester Road, Upleadon
    GL18 1EJ Newent
    EnglandBritish94476640001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    HYTORK CONTROLS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 23 feb 1999
    Consegnato il 03 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Triplex works on the south east side of eastern avenue gloucester gloucestershire t/n GR67362.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 18 ago 1998
    Consegnato il 19 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal sum of £18,755.34 and all other sums due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed charge over 1XBMW 520I motor car,reg/no nesl 625.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 19 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 19 ago 1997
    Consegnato il 22 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 x 1991 pollard mori seiki mh 40 horizontal machining centre with fanuc omc control system serial no.621 Complete with standard equipment and the proceeds and products thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royscot Trust PLC,Royscot Leasing Limited, Royscot Industrial Leasing Limited, Royscot Commercial Leasing Limited& Royscot Spa Leasing Limited
    Transazioni
    • 22 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 22 mag 1992
    Acquisito il 01 mag 1992
    Consegnato il 22 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of fixed and floating charge all book debts and other debts and the undertaking and all assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mag 1992Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 27 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 01 mag 1992
    Consegnato il 15 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee onany account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 ref M621C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0