MERSEYRIDER LIMITED

MERSEYRIDER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMERSEYRIDER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02708460
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MERSEYRIDER LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova MERSEYRIDER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MERSEYRIDER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per MERSEYRIDER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP in data 14 set 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 04 set 2012

    LRESSP

    Cessazione della carica di Richard Anthony Bowler come amministratore in data 28 ago 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Philip Martin Stone come amministratore in data 28 ago 2012

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 26 mag 2012

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 22 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 apr 2012

    Stato del capitale al 23 apr 2012

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Nomina di Kenneth Mcintyre Carlaw come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Turner come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 22 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Anthony Bowler il 22 apr 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Paul Turner il 22 apr 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip Martin Stone il 22 apr 2011

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Malcolm Gilkerson come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 22 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 22 apr 2010

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MERSEYRIDER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVIES, Elizabeth Anne
    Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne & Wear
    Segretario
    Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne & Wear
    British102907000002
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    Amministratore
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    EnglandBritish161250030001
    MILLINGTON, Ronald Gordon
    3 Teddington Close
    Dudlows Green
    WA4 5QG Warrington
    Cheshire
    Segretario
    3 Teddington Close
    Dudlows Green
    WA4 5QG Warrington
    Cheshire
    British30257840002
    MORRIS, Roderick Gruffydd
    26 Greenhill Place
    The Park Huyton Wnn Roby
    L36 5RU Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    26 Greenhill Place
    The Park Huyton Wnn Roby
    L36 5RU Liverpool
    Merseyside
    British102834790001
    THORPE, Elizabeth Anne
    2 Oakwood
    DH7 0NP Lanchester
    County Durham
    Segretario
    2 Oakwood
    DH7 0NP Lanchester
    County Durham
    British102907000001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    VIRTUE, John
    91 Hollywood Avenue
    Gosforth
    NE3 5BU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    91 Hollywood Avenue
    Gosforth
    NE3 5BU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British102404840001
    WOODWARD, Deborah Anne
    37a Lavender Gardens
    SW11 1DJ London
    Segretario
    37a Lavender Gardens
    SW11 1DJ London
    British3219400004
    CORPORATE NOMINEE SECRETARIES LIMITED
    Falcon House
    24 North John Street
    L2 9RP Liverpool
    Segretario nominato
    Falcon House
    24 North John Street
    L2 9RP Liverpool
    900001010001
    BOWLER, Richard Anthony
    Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish35116070001
    BRADY, Dominic
    54 High Street
    Hale Village
    L24 4AF Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    54 High Street
    Hale Village
    L24 4AF Liverpool
    Merseyside
    UkBritish125406360001
    CAMPBELL, Iain Fraser
    3 Hallgate
    Daisy Hill Westhoughton
    BL5 2SF Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    3 Hallgate
    Daisy Hill Westhoughton
    BL5 2SF Bolton
    Lancashire
    British66379980001
    CLAYTON, Stephen John
    New Hall Farmhouse Fanhams Hall
    Road Newhall Green Wareside
    SG12 7SD Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    New Hall Farmhouse Fanhams Hall
    Road Newhall Green Wareside
    SG12 7SD Ware
    Hertfordshire
    EnglandBritish46866840005
    COLEMAN, Alan Hague
    17 Kent Close
    Bromborough
    L63 0EF Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    17 Kent Close
    Bromborough
    L63 0EF Wirral
    Merseyside
    British18844210001
    COOMBES, Peter Geoffrey
    7 Mclauchlan Rise
    Aberdour
    KY3 0SS Burntisland
    Fife
    Scotland
    Amministratore
    7 Mclauchlan Rise
    Aberdour
    KY3 0SS Burntisland
    Fife
    Scotland
    British34146400001
    FULLER, Colin Eric
    Broadmore House
    Broadmore Lane
    ST18 0LD Stowe-By-Chartley
    Staffordshire
    Amministratore
    Broadmore House
    Broadmore Lane
    ST18 0LD Stowe-By-Chartley
    Staffordshire
    EnglandBritish59600860003
    GILKERSON, Malcolm
    111 Min-Y-Don
    LL22 7LY Abergele
    Clwyd
    Amministratore
    111 Min-Y-Don
    LL22 7LY Abergele
    Clwyd
    United KingdomBritish46793270001
    HIND, Robert Andrew
    18 Maplewell Road
    Woodhouse Eaves
    LE12 8QZ Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    18 Maplewell Road
    Woodhouse Eaves
    LE12 8QZ Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish21961900002
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Amministratore
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritish4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001
    MILLINGTON, Ronald Gordon
    3 Teddington Close
    Dudlows Green
    WA4 5QG Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    3 Teddington Close
    Dudlows Green
    WA4 5QG Warrington
    Cheshire
    British30257840002
    MORRIS, Roderick Gruffydd
    26 Greenhill Place
    The Park Huyton Wnn Roby
    L36 5RU Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    26 Greenhill Place
    The Park Huyton Wnn Roby
    L36 5RU Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritish102834790001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Amministratore
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    British58415290001
    ROBERTS, Graham Stanley
    Wheelwrights
    Todenham
    GL56 9NZ Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Amministratore
    Wheelwrights
    Todenham
    GL56 9NZ Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    British72671680001
    SNAPE, Paul
    51 Seaton Way
    Cambridge Park
    PR9 9GJ Southport
    Merseyside
    Amministratore
    51 Seaton Way
    Cambridge Park
    PR9 9GJ Southport
    Merseyside
    British34326560001
    STONE, Philip Martin
    Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish69200640003
    STONE, Philip Martin
    21 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    Amministratore
    21 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    EnglandBritish69200640003
    TURNER, David Paul
    Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish48937720001
    CORPORATE NOMINEE SERVICES LIMITED
    Falcon House
    24 North John Street
    L2 9RP Liverpool
    Amministratore delegato nominato
    Falcon House
    24 North John Street
    L2 9RP Liverpool
    900001020001

    MERSEYRIDER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental debenture
    Creato il 07 feb 1997
    Consegnato il 27 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security trustee on behalf of the beneficiaries as identified in the debenture dated 3RD july 1996) under the terms of this supplemental debenture dated 7TH february 1997 or by the debenture dated 3RD july 1996 (as supplemented by a supplemental deed dated 19TH december 1996)
    Brevi particolari
    The company with full title guarantee charges in favour of the security trustee all its property, assets and undertaking on the terms set out in clause 4 of the debenture (as defined).. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • First National Bank of Boston
    Transazioni
    • 27 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 03 lug 1996
    Consegnato il 22 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys obligations and liabilities due or to become due from the company or by any other company named therein to the chargee under the facility agreement and/or the security documents as defined in the guarantee and debenture
    Brevi particolari
    F/H land and buildings comprising edge lane works and garage liverpool, f/h land and buildings carnegie road garage green lane liverpool f/h land and buildings garston bus depot speke road liverpool t/no MS156996 f/h land and buildings gilmoss garage east lancashire road gilmoss liverpool and all the other properties as detailed in part v of the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston as Agent and Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 22 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture as supplemented by a supplemental deed to the guarantee and debenture dated 26TH october 1994 and created by london bus company limited
    Creato il 26 ott 1994
    Consegnato il 11 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    Various properties as defined in the charge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 17 dic 1992
    Consegnato il 06 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from mtl trust holdings limited to merseyside passenger transport authority ("the chargee") under the terms of a sale and purchase agreement, an agreement and a deed of covenant all dated 17TH december 1992 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this guarantee and debenture
    Brevi particolari
    (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Merseyside Passenger Transport Authority
    Transazioni
    • 06 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MERSEYRIDER LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 apr 2013Data di scioglimento
    04 set 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praticante
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Andrew Timothy Clay
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praticante
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0