MERSEYRIDER LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MERSEYRIDER LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02708460 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MERSEYRIDER LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova MERSEYRIDER LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di MERSEYRIDER LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per MERSEYRIDER LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 8 pagine | 4.71 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP in data 14 set 2012 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Anthony Bowler come amministratore in data 28 ago 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Philip Martin Stone come amministratore in data 28 ago 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 26 mag 2012 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 apr 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Kenneth Mcintyre Carlaw come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Turner come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 apr 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Richard Anthony Bowler il 22 apr 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Paul Turner il 22 apr 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip Martin Stone il 22 apr 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Malcolm Gilkerson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 apr 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 22 apr 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2008 | 6 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2007 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MERSEYRIDER LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIES, Elizabeth Anne | Segretario | Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne & Wear | British | 102907000002 | ||||||
| CARLAW, Kenneth Mcintyre | Amministratore | Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 | England | British | 161250030001 | |||||
| MILLINGTON, Ronald Gordon | Segretario | 3 Teddington Close Dudlows Green WA4 5QG Warrington Cheshire | British | 30257840002 | ||||||
| MORRIS, Roderick Gruffydd | Segretario | 26 Greenhill Place The Park Huyton Wnn Roby L36 5RU Liverpool Merseyside | British | 102834790001 | ||||||
| THORPE, Elizabeth Anne | Segretario | 2 Oakwood DH7 0NP Lanchester County Durham | British | 102907000001 | ||||||
| TURNER, David Paul | Segretario | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | British | 48937720001 | ||||||
| VIRTUE, John | Segretario | 91 Hollywood Avenue Gosforth NE3 5BU Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 102404840001 | ||||||
| WOODWARD, Deborah Anne | Segretario | 37a Lavender Gardens SW11 1DJ London | British | 3219400004 | ||||||
| CORPORATE NOMINEE SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | Falcon House 24 North John Street L2 9RP Liverpool | 900001010001 | |||||||
| BOWLER, Richard Anthony | Amministratore | Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 35116070001 | |||||
| BRADY, Dominic | Amministratore | 54 High Street Hale Village L24 4AF Liverpool Merseyside | Uk | British | 125406360001 | |||||
| CAMPBELL, Iain Fraser | Amministratore | 3 Hallgate Daisy Hill Westhoughton BL5 2SF Bolton Lancashire | British | 66379980001 | ||||||
| CLAYTON, Stephen John | Amministratore | New Hall Farmhouse Fanhams Hall Road Newhall Green Wareside SG12 7SD Ware Hertfordshire | England | British | 46866840005 | |||||
| COLEMAN, Alan Hague | Amministratore | 17 Kent Close Bromborough L63 0EF Wirral Merseyside | British | 18844210001 | ||||||
| COOMBES, Peter Geoffrey | Amministratore | 7 Mclauchlan Rise Aberdour KY3 0SS Burntisland Fife Scotland | British | 34146400001 | ||||||
| FULLER, Colin Eric | Amministratore | Broadmore House Broadmore Lane ST18 0LD Stowe-By-Chartley Staffordshire | England | British | 59600860003 | |||||
| GILKERSON, Malcolm | Amministratore | 111 Min-Y-Don LL22 7LY Abergele Clwyd | United Kingdom | British | 46793270001 | |||||
| HIND, Robert Andrew | Amministratore | 18 Maplewell Road Woodhouse Eaves LE12 8QZ Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | 21961900002 | |||||
| LONSDALE, Stephen Philip | Amministratore | 5 Lintfort Picktree Farm Picktree NE38 9HX Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | 4971910001 | |||||
| MARTIN, David Robert | Amministratore | Bondwood Barn Repton Shrubs Bretby DE15 0RJ Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 6874440001 | |||||
| MILLINGTON, Ronald Gordon | Amministratore | 3 Teddington Close Dudlows Green WA4 5QG Warrington Cheshire | British | 30257840002 | ||||||
| MORRIS, Roderick Gruffydd | Amministratore | 26 Greenhill Place The Park Huyton Wnn Roby L36 5RU Liverpool Merseyside | United Kingdom | British | 102834790001 | |||||
| RAY, John Alfred | Amministratore | 50 The Gables Sedgefield TS21 3EU Stockton On Tees Cleveland | British | 58415290001 | ||||||
| ROBERTS, Graham Stanley | Amministratore | Wheelwrights Todenham GL56 9NZ Moreton In Marsh Gloucestershire | British | 72671680001 | ||||||
| SNAPE, Paul | Amministratore | 51 Seaton Way Cambridge Park PR9 9GJ Southport Merseyside | British | 34326560001 | ||||||
| STONE, Philip Martin | Amministratore | Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne & Wear | England | British | 69200640003 | |||||
| STONE, Philip Martin | Amministratore | 21 Beechfield Road Mayfield PR25 3BG Leyland Lancashire | England | British | 69200640003 | |||||
| TURNER, David Paul | Amministratore | Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 48937720001 | |||||
| CORPORATE NOMINEE SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Falcon House 24 North John Street L2 9RP Liverpool | 900001020001 |
MERSEYRIDER LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental debenture | Creato il 07 feb 1997 Consegnato il 27 feb 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee (as security trustee on behalf of the beneficiaries as identified in the debenture dated 3RD july 1996) under the terms of this supplemental debenture dated 7TH february 1997 or by the debenture dated 3RD july 1996 (as supplemented by a supplemental deed dated 19TH december 1996) | |
Brevi particolari The company with full title guarantee charges in favour of the security trustee all its property, assets and undertaking on the terms set out in clause 4 of the debenture (as defined).. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 03 lug 1996 Consegnato il 22 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys obligations and liabilities due or to become due from the company or by any other company named therein to the chargee under the facility agreement and/or the security documents as defined in the guarantee and debenture | |
Brevi particolari F/H land and buildings comprising edge lane works and garage liverpool, f/h land and buildings carnegie road garage green lane liverpool f/h land and buildings garston bus depot speke road liverpool t/no MS156996 f/h land and buildings gilmoss garage east lancashire road gilmoss liverpool and all the other properties as detailed in part v of the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture as supplemented by a supplemental deed to the guarantee and debenture dated 26TH october 1994 and created by london bus company limited | Creato il 26 ott 1994 Consegnato il 11 nov 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the charge) | |
Brevi particolari Various properties as defined in the charge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 17 dic 1992 Consegnato il 06 gen 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from mtl trust holdings limited to merseyside passenger transport authority ("the chargee") under the terms of a sale and purchase agreement, an agreement and a deed of covenant all dated 17TH december 1992 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this guarantee and debenture | |
Brevi particolari (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
MERSEYRIDER LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0