EVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED
Panoramica
Nome della società | EVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02709572 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova EVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | - Clayton Lane Clayton M11 4SR Manchester England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
LAPORTE SPECIALITY ORGANICS LIMITED | 18 ott 1999 | 18 ott 1999 |
LAPORTE PERFORMANCE CHEMICALS LIMITED | 07 apr 1999 | 07 apr 1999 |
INSPEC GROUP PLC | 04 giu 1992 | 04 giu 1992 |
NOVABURST LIMITED | 24 apr 1992 | 24 apr 1992 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per EVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthias Kittler come amministratore in data 24 gen 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2024 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2023 al 23 nov 2023 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2022 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Matthias Kittler come amministratore in data 09 giu 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Unit 6 Greenford Park Ockham Drive Greenford Middlesex UB6 0FD England a - Clayton Lane Clayton Manchester M11 4SR in data 04 apr 2023 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2021 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2022 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Dr Andrew Timothy Boam come amministratore in data 26 ott 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Anh Tu Luu il 02 lug 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Julio Diniz Pereira De Almeida come amministratore in data 31 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Tego House Chippenham Drive Kingston Milton Keynes Buckinghamshire MK10 0AF a Unit 6 Greenford Park Ockham Drive Greenford Middlesex UB6 0FD in data 18 set 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Dr Liane Monika Deusser come amministratore in data 30 giu 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Julio Diniz Peirera De Almeida come amministratore in data 30 giu 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di EVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAPLETON, Geneva Angela | Segretario | Clayton Lane Clayton M11 4SR Manchester - England | British | 76343050001 | ||||||
BOAM, Andrew Timothy, Dr | Amministratore | Clayton Lane Clayton M11 4SR Manchester - England | England | British | Chemical Engineer | 206737460001 | ||||
DEUSSER, Liane Monika, Dr | Amministratore | Clayton Lane Clayton M11 4SR Manchester - England | Germany | German | Chief Financial Officer | 271439500001 | ||||
LUU, Anh Tu | Amministratore | Clayton Lane Clayton M11 4SR Manchester - England | England | British | Solicitor | 167485430002 | ||||
CORSI, Gary Stephen | Segretario | Littlebourn Shirley Holms Road SO41 8NH Lymington Hampshire | British | Finance Director | 62569200001 | |||||
STOKES, Martin Howard | Segretario | 1 Hazel Grove SO22 4PQ Winchester Hampshire | British | 7345750001 | ||||||
TONER, Daniel Francis | Segretario | 2 Southwood Mansions Southwood Lane N6 5SZ London | British | 63504340002 | ||||||
WHALLEY, Amanda | Segretario | 12 Merchant Court 61 Wapping Wall Wapping E1W 3SD London | British | 124348320001 | ||||||
ABOGADO CUSTODIANS LIMITED | Segretario nominato | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London | 900021140001 | |||||||
THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED | Segretario nominato | 83 Leonard Street EC2A 4QS London | 900003220001 | |||||||
ALMEIDA, Julio Diniz Pereira De | Amministratore | Greenford Park Ockham Drive UB6 0FD Greenford Unit 6 Middlesex England | England | Brazilian | Accountant | 247356060002 | ||||
ANDREWS, Donald Charles Mackenzie | Amministratore | The White House 45 Kimbolton Road MK40 2PG Bedford | United Kingdom | British | Md & Dir Of Property Risk & Ad | 75302170001 | ||||
BATTERSBY, George William | Amministratore | 7th Floor The Point 37 North Wharf Road W2 1LA London | British | Human Resources Manager | 122127880001 | |||||
BRANDON, John Robert | Amministratore | 28 Marsh Lane Mill Hill NW7 4QP London | United Kingdom | British | Businessman | 99584240001 | ||||
BROWN, Douglas Richard | Amministratore | Mountleigh 16 The Barton KT11 2NJ Cobham Surrey | American | Business Executive | 24706840001 | |||||
BROWN, John Allan | Amministratore | 37 Observatory Road SW14 7QB London | England | British | Chartered Accountant | 45956440002 | ||||
CHAMBLESS, William Henry | Amministratore | 6700 Ishnala Tr Plano Tx 75023 Usa | American | Company Director | 43097390001 | |||||
CORSI, Gary Stephen | Amministratore | Littlebourn Shirley Holms Road SO41 8NH Lymington Hampshire | United Kingdom | British | Finance Director | 62569200001 | ||||
CURRIE, Andrew Christopher | Amministratore | South Marden Rhinefield Road SO42 7SQ Brockenhurst Hampshire | British | Sales And Marketing Director | 38220340001 | |||||
FEARN, Peter Hugh Colin | Amministratore | Hunters Lodge Pot Kiln Lane RG8 7SR Goring Heath Oxfordshire | United Kingdom | British | F.C.A. | 48874760001 | ||||
HAMILTON, John Lambert | Amministratore | The Poplars 1 Eythrope Road HP17 8PH Stone Buckinghamshire | England | Uk | Company Secretarial & Admin | 27290050003 | ||||
HARVEY, Bernard George | Amministratore | Tego House Chippenham Drive Kingston MK10 0AF Milton Keynes Buckinghamshire | England | English | Joint Managing Director | 134099360019 | ||||
HEATH, Roger Anthony Frederick | Amministratore | Iron Pear Tree House Tilburstow Hill Road RH9 8NA South Godstone Surrey | British | Banker | 5640920001 | |||||
HOLLOWOOD, John, Dr | Amministratore | Roches Fleuries Les Courtes Fallaize, St. Martins GY4 6DH Guernsey | British | Chairman | 60688710003 | |||||
INGLES, David William | Amministratore | Deer Park Cottage Loxhill GU8 4BQ Godalming Surrey | British | Consultant | 58641440001 | |||||
KAYSER, Michael Arthur | Amministratore | 17 Hartsbourne Avenue WD23 1JP Bushey Heath Hertfordshire | United Kingdom | British | Finance Director | 141893610001 | ||||
KITTLER, Matthias | Amministratore | Clayton Lane Clayton M11 4SR Manchester - England | Germany | German | Legal Counsel | 310337060001 | ||||
KITTLER, Matthias | Amministratore | Tego House Chippenham Drive Kingston MK10 0AF Milton Keynes Buckinghamshire | Germany | German | Legal Counsel | 167996510001 | ||||
LANPHERE, Scott Allen | Amministratore | 20 Blandford Close N2 0DH London | Us Citizen | Investment Manager | 64952610001 | |||||
LENG, James William | Amministratore | Caledonian Crescent Gleneagles PH3 1NG Auchterarder Glenuyll Perthshire | British | Company Executive | 134713800001 | |||||
LIPMAN, Jonathan Philip Reuben | Amministratore | 19 Bradgate Road MK40 3DE Bedford Bedfordshire | British | Senior Counsel & Company Secre | 103945940001 | |||||
MACLEOD, Nigel | Amministratore | Tego House Chippenham Drive Kingston MK10 0AF Milton Keynes Buckinghamshire | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 122030870001 | ||||
MEY, Johannes Georg | Amministratore | Tego House Chippenham Drive Kingston MK10 0AF Milton Keynes Buckinghamshire | Germany | German | Human Resources Manager | 178487810001 | ||||
MOBERLEY, Stuart Greville | Amministratore | Old Berrow Hill Farm Berrow Hill Lane B96 6QL Feckenham Worcestershire | British | Chartered Accountant | 72543520002 | |||||
RANKIN, Clive Taunton, Dr | Amministratore | 13 Greville House Kinnerton Street SW1X 8EY London | England | British | Vice Pres & Gen Mgr | 78087820003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di EVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evonik Uk Holdings Limited | 06 apr 2016 | Chippenham Drive Kingston MK10 0AF Milton Keynes Tego House United Kingdom | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
|
EVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Pledge agreement | Creato il 30 dic 1993 Consegnato il 06 gen 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company,international speciality chemicals limited,allco acquisition corporation and certain other subsidiaries of the company to the governor and the company of the bank of scotland as agent and trustee as defined | |
Brevi particolari 1,000 shares of capital stock of allco acquisition corporation and the certificates representing the pledged shares, and any additional stock or other property from time to time received receivable or otherwise distributed in respect of or in exchange for any or all of the pledged shares.b)all proceeds of any of all the foregoing. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee and debenture | Creato il 30 set 1992 Consegnato il 16 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the secured loan stockdeed and this charge (as defined) | |
Brevi particolari See form 395 ref m*715C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee and debenture | Creato il 30 set 1992 Consegnato il 14 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or in connection with the "debenture" as amended and supplemented by a supplemental deed dated 14TH october 1992 (together,the "debenture") | |
Brevi particolari See doc ref M124 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee and debenture | Creato il 30 set 1992 Consegnato il 07 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facilities agreement dated 30TH september 1992 and this charge | |
Brevi particolari See form 395 ref m*81. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0