EVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED

EVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02709572
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova EVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    - Clayton Lane
    Clayton
    M11 4SR Manchester
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LAPORTE SPECIALITY ORGANICS LIMITED18 ott 199918 ott 1999
    LAPORTE PERFORMANCE CHEMICALS LIMITED07 apr 199907 apr 1999
    INSPEC GROUP PLC04 giu 199204 giu 1992
    NOVABURST LIMITED24 apr 199224 apr 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di EVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per EVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Cessazione della carica di Matthias Kittler come amministratore in data 24 gen 2024

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2024 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2023 al 23 nov 2023

    1 pagineAA01

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2022

    15 pagineAA

    Nomina di Mr Matthias Kittler come amministratore in data 09 giu 2023

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 6 Greenford Park Ockham Drive Greenford Middlesex UB6 0FD England a - Clayton Lane Clayton Manchester M11 4SR in data 04 apr 2023

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2021

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2022 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Dr Andrew Timothy Boam come amministratore in data 26 ott 2021

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Anh Tu Luu il 02 lug 2021

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Julio Diniz Pereira De Almeida come amministratore in data 31 dic 2020

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Tego House Chippenham Drive Kingston Milton Keynes Buckinghamshire MK10 0AF a Unit 6 Greenford Park Ockham Drive Greenford Middlesex UB6 0FD in data 18 set 2020

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    17 pagineAA

    Nomina di Dr Liane Monika Deusser come amministratore in data 30 giu 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Julio Diniz Peirera De Almeida come amministratore in data 30 giu 2020

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di EVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STAPLETON, Geneva Angela
    Clayton Lane
    Clayton
    M11 4SR Manchester
    -
    England
    Segretario
    Clayton Lane
    Clayton
    M11 4SR Manchester
    -
    England
    British76343050001
    BOAM, Andrew Timothy, Dr
    Clayton Lane
    Clayton
    M11 4SR Manchester
    -
    England
    Amministratore
    Clayton Lane
    Clayton
    M11 4SR Manchester
    -
    England
    EnglandBritishChemical Engineer206737460001
    DEUSSER, Liane Monika, Dr
    Clayton Lane
    Clayton
    M11 4SR Manchester
    -
    England
    Amministratore
    Clayton Lane
    Clayton
    M11 4SR Manchester
    -
    England
    GermanyGermanChief Financial Officer271439500001
    LUU, Anh Tu
    Clayton Lane
    Clayton
    M11 4SR Manchester
    -
    England
    Amministratore
    Clayton Lane
    Clayton
    M11 4SR Manchester
    -
    England
    EnglandBritishSolicitor167485430002
    CORSI, Gary Stephen
    Littlebourn
    Shirley Holms Road
    SO41 8NH Lymington
    Hampshire
    Segretario
    Littlebourn
    Shirley Holms Road
    SO41 8NH Lymington
    Hampshire
    BritishFinance Director62569200001
    STOKES, Martin Howard
    1 Hazel Grove
    SO22 4PQ Winchester
    Hampshire
    Segretario
    1 Hazel Grove
    SO22 4PQ Winchester
    Hampshire
    British7345750001
    TONER, Daniel Francis
    2 Southwood Mansions
    Southwood Lane
    N6 5SZ London
    Segretario
    2 Southwood Mansions
    Southwood Lane
    N6 5SZ London
    British63504340002
    WHALLEY, Amanda
    12 Merchant Court
    61 Wapping Wall Wapping
    E1W 3SD London
    Segretario
    12 Merchant Court
    61 Wapping Wall Wapping
    E1W 3SD London
    British124348320001
    ABOGADO CUSTODIANS LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Segretario nominato
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021140001
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    Segretario nominato
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    900003220001
    ALMEIDA, Julio Diniz Pereira De
    Greenford Park
    Ockham Drive
    UB6 0FD Greenford
    Unit 6
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Greenford Park
    Ockham Drive
    UB6 0FD Greenford
    Unit 6
    Middlesex
    England
    EnglandBrazilianAccountant247356060002
    ANDREWS, Donald Charles Mackenzie
    The White House
    45 Kimbolton Road
    MK40 2PG Bedford
    Amministratore
    The White House
    45 Kimbolton Road
    MK40 2PG Bedford
    United KingdomBritishMd & Dir Of Property Risk & Ad75302170001
    BATTERSBY, George William
    7th Floor The Point
    37 North Wharf Road
    W2 1LA London
    Amministratore
    7th Floor The Point
    37 North Wharf Road
    W2 1LA London
    BritishHuman Resources Manager122127880001
    BRANDON, John Robert
    28 Marsh Lane
    Mill Hill
    NW7 4QP London
    Amministratore
    28 Marsh Lane
    Mill Hill
    NW7 4QP London
    United KingdomBritishBusinessman99584240001
    BROWN, Douglas Richard
    Mountleigh 16 The Barton
    KT11 2NJ Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Mountleigh 16 The Barton
    KT11 2NJ Cobham
    Surrey
    AmericanBusiness Executive24706840001
    BROWN, John Allan
    37 Observatory Road
    SW14 7QB London
    Amministratore
    37 Observatory Road
    SW14 7QB London
    EnglandBritishChartered Accountant45956440002
    CHAMBLESS, William Henry
    6700 Ishnala Tr
    Plano Tx 75023
    Usa
    Amministratore
    6700 Ishnala Tr
    Plano Tx 75023
    Usa
    AmericanCompany Director43097390001
    CORSI, Gary Stephen
    Littlebourn
    Shirley Holms Road
    SO41 8NH Lymington
    Hampshire
    Amministratore
    Littlebourn
    Shirley Holms Road
    SO41 8NH Lymington
    Hampshire
    United KingdomBritishFinance Director62569200001
    CURRIE, Andrew Christopher
    South Marden
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    Amministratore
    South Marden
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    BritishSales And Marketing Director38220340001
    FEARN, Peter Hugh Colin
    Hunters Lodge Pot Kiln Lane
    RG8 7SR Goring Heath
    Oxfordshire
    Amministratore
    Hunters Lodge Pot Kiln Lane
    RG8 7SR Goring Heath
    Oxfordshire
    United KingdomBritishF.C.A.48874760001
    HAMILTON, John Lambert
    The Poplars
    1 Eythrope Road
    HP17 8PH Stone
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Poplars
    1 Eythrope Road
    HP17 8PH Stone
    Buckinghamshire
    EnglandUkCompany Secretarial & Admin27290050003
    HARVEY, Bernard George
    Tego House
    Chippenham Drive Kingston
    MK10 0AF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Tego House
    Chippenham Drive Kingston
    MK10 0AF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandEnglishJoint Managing Director134099360019
    HEATH, Roger Anthony Frederick
    Iron Pear Tree House
    Tilburstow Hill Road
    RH9 8NA South Godstone
    Surrey
    Amministratore
    Iron Pear Tree House
    Tilburstow Hill Road
    RH9 8NA South Godstone
    Surrey
    BritishBanker5640920001
    HOLLOWOOD, John, Dr
    Roches Fleuries
    Les Courtes Fallaize, St. Martins
    GY4 6DH Guernsey
    Amministratore
    Roches Fleuries
    Les Courtes Fallaize, St. Martins
    GY4 6DH Guernsey
    BritishChairman60688710003
    INGLES, David William
    Deer Park Cottage
    Loxhill
    GU8 4BQ Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Deer Park Cottage
    Loxhill
    GU8 4BQ Godalming
    Surrey
    BritishConsultant58641440001
    KAYSER, Michael Arthur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director141893610001
    KITTLER, Matthias
    Clayton Lane
    Clayton
    M11 4SR Manchester
    -
    England
    Amministratore
    Clayton Lane
    Clayton
    M11 4SR Manchester
    -
    England
    GermanyGermanLegal Counsel310337060001
    KITTLER, Matthias
    Tego House
    Chippenham Drive Kingston
    MK10 0AF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Tego House
    Chippenham Drive Kingston
    MK10 0AF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    GermanyGermanLegal Counsel167996510001
    LANPHERE, Scott Allen
    20 Blandford Close
    N2 0DH London
    Amministratore
    20 Blandford Close
    N2 0DH London
    Us CitizenInvestment Manager64952610001
    LENG, James William
    Caledonian Crescent
    Gleneagles
    PH3 1NG Auchterarder
    Glenuyll
    Perthshire
    Amministratore
    Caledonian Crescent
    Gleneagles
    PH3 1NG Auchterarder
    Glenuyll
    Perthshire
    BritishCompany Executive134713800001
    LIPMAN, Jonathan Philip Reuben
    19 Bradgate Road
    MK40 3DE Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    19 Bradgate Road
    MK40 3DE Bedford
    Bedfordshire
    BritishSenior Counsel & Company Secre103945940001
    MACLEOD, Nigel
    Tego House
    Chippenham Drive Kingston
    MK10 0AF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Tego House
    Chippenham Drive Kingston
    MK10 0AF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChief Financial Officer122030870001
    MEY, Johannes Georg
    Tego House
    Chippenham Drive Kingston
    MK10 0AF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Tego House
    Chippenham Drive Kingston
    MK10 0AF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    GermanyGermanHuman Resources Manager178487810001
    MOBERLEY, Stuart Greville
    Old Berrow Hill Farm
    Berrow Hill Lane
    B96 6QL Feckenham
    Worcestershire
    Amministratore
    Old Berrow Hill Farm
    Berrow Hill Lane
    B96 6QL Feckenham
    Worcestershire
    BritishChartered Accountant72543520002
    RANKIN, Clive Taunton, Dr
    13 Greville House
    Kinnerton Street
    SW1X 8EY London
    Amministratore
    13 Greville House
    Kinnerton Street
    SW1X 8EY London
    EnglandBritishVice Pres & Gen Mgr78087820003

    Chi sono le persone con controllo significativo di EVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Evonik Uk Holdings Limited
    Chippenham Drive
    Kingston
    MK10 0AF Milton Keynes
    Tego House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Chippenham Drive
    Kingston
    MK10 0AF Milton Keynes
    Tego House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    EVONIK SPECIALITY ORGANICS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Pledge agreement
    Creato il 30 dic 1993
    Consegnato il 06 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company,international speciality chemicals limited,allco acquisition corporation and certain other subsidiaries of the company to the governor and the company of the bank of scotland as agent and trustee as defined
    Brevi particolari
    1,000 shares of capital stock of allco acquisition corporation and the certificates representing the pledged shares, and any additional stock or other property from time to time received receivable or otherwise distributed in respect of or in exchange for any or all of the pledged shares.b)all proceeds of any of all the foregoing.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 30 set 1992
    Consegnato il 16 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the secured loan stockdeed and this charge (as defined)
    Brevi particolari
    See form 395 ref m*715C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Advent International Corporationas Trustee for the Stockholders
    Transazioni
    • 16 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 30 set 1992
    Consegnato il 14 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or in connection with the "debenture" as amended and supplemented by a supplemental deed dated 14TH october 1992 (together,the "debenture")
    Brevi particolari
    See doc ref M124 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bp Chemicals Limitedas Agent ("Bpc") for Bp International Limited ("Bpi")
    Transazioni
    • 14 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 30 set 1992
    Consegnato il 07 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facilities agreement dated 30TH september 1992 and this charge
    Brevi particolari
    See form 395 ref m*81. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee
    Transazioni
    • 07 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0