SMITH CASHMAN BORKETT LIMITED

SMITH CASHMAN BORKETT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSMITH CASHMAN BORKETT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02713821
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SMITH CASHMAN BORKETT LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova SMITH CASHMAN BORKETT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    29 Clerkenwell Road
    London
    EC1M 5TA
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SMITH CASHMAN BORKETT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SMITH CASHMAN BORKETT HILL HEADLAND LTD.11 apr 199611 apr 1996
    SMITH CASHMAN BORKETT LIMITED04 nov 199204 nov 1992
    SMITH CASHMAN LIMITED12 mag 199212 mag 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di SMITH CASHMAN BORKETT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per SMITH CASHMAN BORKETT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 giu 2010

    Stato del capitale al 10 giu 2010

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Richard Morpeth Jameson il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Morpeth Jameson il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Stephen Parish il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    1 pagineAA

    legacy

    1 pagine225

    Bilancio redatto al 31 gen 2008

    1 pagineAA

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    1 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    1 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    3 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di SMITH CASHMAN BORKETT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JAMESON, Richard Morpeth
    Clerkenwell Road
    EC1M 5TA London
    29
    United Kingdom
    Segretario
    Clerkenwell Road
    EC1M 5TA London
    29
    United Kingdom
    Other130270600001
    CASHMAN, Simon John
    The Old Post Office
    The Street
    RH20 3EP Thakeham
    Sussex
    Amministratore
    The Old Post Office
    The Street
    RH20 3EP Thakeham
    Sussex
    United KingdomBritishAdvertising Consultants220063710003
    JAMESON, Richard Morpeth
    Clerkenwell Road
    EC1M 5TA London
    29
    United Kingdom
    Amministratore
    Clerkenwell Road
    EC1M 5TA London
    29
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector13367160002
    PARISH, Stephen
    Clerkenwell Road
    EC1M 5TA London
    29
    United Kingdom
    Amministratore
    Clerkenwell Road
    EC1M 5TA London
    29
    United Kingdom
    EnglandBritishProduction76442900001
    BRUCE-MORGAN, Llewellyn
    15 Lady Margaret Road
    Kentish Town
    NW5 2NG London
    Segretario
    15 Lady Margaret Road
    Kentish Town
    NW5 2NG London
    BritishCompany Director8164040002
    MILLER, Moira Josephine
    4 Nye Way
    Bovingdon
    HP3 0HX Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Segretario
    4 Nye Way
    Bovingdon
    HP3 0HX Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British14691880002
    SMITH, Michael Edmund
    Mouse Cottage
    Clackhams Lane
    TN6 3RN Jarvis Brook
    East Sussex
    Segretario
    Mouse Cottage
    Clackhams Lane
    TN6 3RN Jarvis Brook
    East Sussex
    British10152470001
    THOMAS, Howard
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    Segretario nominato
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British900000900001
    WILSHER, Bryan Guy
    21 Stamford Road
    N1 4JP London
    Segretario
    21 Stamford Road
    N1 4JP London
    British3588500007
    WILSHER, Bryan Guy
    17 Baalbec Road
    Highbury
    N5 1QN London
    Segretario
    17 Baalbec Road
    Highbury
    N5 1QN London
    British3588500002
    BORKETT, John Henry
    The Old Rectory
    Rectory Road
    MK42 5AT Steppingley
    Bedfordshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Rectory Road
    MK42 5AT Steppingley
    Bedfordshire
    BritishDirector118276070001
    BRUCE-MORGAN, Llewellyn
    15 Lady Margaret Road
    Kentish Town
    NW5 2NG London
    Amministratore
    15 Lady Margaret Road
    Kentish Town
    NW5 2NG London
    BritishChartered Accountant8164040002
    BUCKLEY, Christopher John
    8 Longdown Road
    KT17 3PT Epsom
    Surrey
    Amministratore
    8 Longdown Road
    KT17 3PT Epsom
    Surrey
    BritishSales Director23475300001
    CLANCEY, Christopher John
    71 Marshals Drive
    AL1 4RD St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    71 Marshals Drive
    AL1 4RD St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector7673650002
    GAINES, James Henry
    49 Chestnut Grove
    CR2 7LL South Croydon
    Surrey
    Amministratore
    49 Chestnut Grove
    CR2 7LL South Croydon
    Surrey
    BritishSales Director23475290001
    HILL, John
    The Old Forge The Green
    Wickham St Paul
    CO9 2PT Halstead
    Essex
    Amministratore
    The Old Forge The Green
    Wickham St Paul
    CO9 2PT Halstead
    Essex
    BritishRetoucher Manager47963810001
    RICE, Christopher
    Ventham Court
    Allens Green
    CM21 0LS Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Ventham Court
    Allens Green
    CM21 0LS Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    BritishSales Director7673640004
    SMITH, Michael Edmund
    Mouse Cottage
    Clackhams Lane
    TN6 3RN Jarvis Brook
    East Sussex
    Amministratore
    Mouse Cottage
    Clackhams Lane
    TN6 3RN Jarvis Brook
    East Sussex
    United KingdomBritishAdvertising Consultants10152470001
    WILSHER, Bryan Guy
    17 Baalbec Road
    Highbury
    N5 1QN London
    Amministratore
    17 Baalbec Road
    Highbury
    N5 1QN London
    BritishManagement Consultant3588500002

    SMITH CASHMAN BORKETT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and set-off
    Creato il 29 set 1993
    Consegnato il 06 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the agreement
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 29 set 1993
    Consegnato il 05 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0