DM REALISATIONS LIMITED

DM REALISATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDM REALISATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02715504
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DM REALISATIONS LIMITED?

    • Altra vendita al dettaglio non in negozi, bancarelle o mercati (47990) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova DM REALISATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Interpath Advisory 4th Floor Tailors Corner
    Thirsk Row
    LS1 4JF Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DM REALISATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DRINKMASTER LIMITED19 mag 199219 mag 1992
    GMW INVESTMENTS12 mag 199212 mag 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di DM REALISATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per DM REALISATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    21 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 mag 2022

    23 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Sovereign Square Sovereign Street Leeds LS1 4DA a C/O Interpath Advisory 4th Floor Tailors Corner Thirsk Row Leeds LS1 4JF in data 11 gen 2022

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 mag 2021

    22 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    29 pagine600

    Dimissioni di un liquidatore

    3 pagineLIQ06

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    29 pagineAM22

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    27 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    25 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    27 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    33 pagineAM10

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    12 pagineAM02

    Risultato della riunione dei creditori

    5 pagineAM07

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed drinkmaster LIMITED\certificate issued on 05/07/18
    3 pagineCERTNM

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    46 pagineAM03

    Indirizzo della sede legale modificato da 27 Broad Street Wokingham Berkshire RG40 1AU a 1 Sovereign Square Sovereign Street Leeds LS1 4DA in data 21 giu 2018

    2 pagineAD01

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016

    23 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2017 al 31 dic 2016

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    23 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 nov 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di DM REALISATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STEPTO, Jon Morgan
    7 Tors Road
    EX20 1EF Okehampton
    Devon
    Amministratore
    7 Tors Road
    EX20 1EF Okehampton
    Devon
    United KingdomBritish69287320002
    CAULFIELD, Paul James
    9 Vicarage Close
    Menheniot
    PL14 3QG Liskeard
    Cornwall
    Segretario
    9 Vicarage Close
    Menheniot
    PL14 3QG Liskeard
    Cornwall
    British35032320001
    GARNER, Brian Stephen
    Cornerways
    Kilpin Green
    MK16 9LZ North Crawley
    Buckinghamshire
    Segretario
    Cornerways
    Kilpin Green
    MK16 9LZ North Crawley
    Buckinghamshire
    British27162650001
    JAMES, Timothy Henry Thorpe
    Broad Street
    RG40 1AU Wokingham
    27
    Berkshire
    Segretario
    Broad Street
    RG40 1AU Wokingham
    27
    Berkshire
    British154419180001
    SHIELDS, Mark Anthony
    116 Dunraven Drive
    Derriford
    PL6 6AT Plymouth
    Devon
    Segretario
    116 Dunraven Drive
    Derriford
    PL6 6AT Plymouth
    Devon
    British61878750002
    STEPTO, Jon Morgan
    7 Tors Road
    EX20 1EF Okehampton
    Devon
    Segretario
    7 Tors Road
    EX20 1EF Okehampton
    Devon
    British69287320002
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    CAULFIELD, Paul James
    9 Vicarage Close
    Menheniot
    PL14 3QG Liskeard
    Cornwall
    Amministratore
    9 Vicarage Close
    Menheniot
    PL14 3QG Liskeard
    Cornwall
    British35032320001
    DE SILVA, Jivan
    Loft 13 Soho Lofts
    10 Richmond Mews
    W1V 5AG London
    Amministratore
    Loft 13 Soho Lofts
    10 Richmond Mews
    W1V 5AG London
    British69465410001
    GANSSER POTTS, Michael David
    17 Alexandra Court
    171-175 Queens Gate
    SW7 5HG London
    Amministratore
    17 Alexandra Court
    171-175 Queens Gate
    SW7 5HG London
    United KingdomBritish86921870001
    GARNER, Brian Stephen
    Cornerways
    Kilpin Green
    MK16 9LZ North Crawley
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Cornerways
    Kilpin Green
    MK16 9LZ North Crawley
    Buckinghamshire
    EnglandBritish27162650001
    HAMER, Jeremy John
    Broad Street
    RG40 1AU Wokingham
    27
    Berkshire
    Amministratore
    Broad Street
    RG40 1AU Wokingham
    27
    Berkshire
    EnglandBritish10425110003
    HUGGETT, Steven Charles
    Rees Farm
    Old Packards Lane Wormingford
    CO6 3AH Colchester
    Essex
    Amministratore
    Rees Farm
    Old Packards Lane Wormingford
    CO6 3AH Colchester
    Essex
    United KingdomBritish88165550001
    JAMES, Timothy Henry Thorpe
    Broad Street
    RG40 1AU Wokingham
    27
    Berkshire
    Amministratore
    Broad Street
    RG40 1AU Wokingham
    27
    Berkshire
    EnglandBritish91033980001
    JENKINS, Blair Ashley Bedford
    Broad Street
    RG40 1AU Wokingham
    27
    Berkshire
    Amministratore
    Broad Street
    RG40 1AU Wokingham
    27
    Berkshire
    EnglandBritish154394500001
    RAWLINS, Steven Clive
    Rufus Business Centre
    Ravensbury Terrace
    SW18 4RL London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rufus Business Centre
    Ravensbury Terrace
    SW18 4RL London
    17
    United Kingdom
    EnglandUnited Kingdom240837130001
    ROMCOLTHOFF, Derk Hendrik
    Rufus Business Centre
    Ravensbury Terrace
    SW18 4RL London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rufus Business Centre
    Ravensbury Terrace
    SW18 4RL London
    17
    United Kingdom
    Dutch139661460001
    SANTILLO, Alan John
    13 Cowling Gardens
    Menheniot
    PL14 3QJ Liskeard
    Cornwall
    Amministratore
    13 Cowling Gardens
    Menheniot
    PL14 3QJ Liskeard
    Cornwall
    British67790780001
    SHIELDS, Mark Anthony
    5 Carisbrooke Close
    Caldy
    L48 2LQ Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    5 Carisbrooke Close
    Caldy
    L48 2LQ Wirral
    Merseyside
    British61878750001
    SMITH, Douglas
    9 Stewarts Grove
    SW3 6PD London
    Amministratore
    9 Stewarts Grove
    SW3 6PD London
    British69467730002
    STONE, Mark James
    Ravensbury Terrace
    SW18 4RL London
    Unit 17, Rufus Business Centre
    England
    Amministratore
    Ravensbury Terrace
    SW18 4RL London
    Unit 17, Rufus Business Centre
    England
    EnglandBritish194641300001
    VICKERS, Paul
    Broad Street
    RG40 1AU Wokingham
    27
    Berkshire
    Amministratore
    Broad Street
    RG40 1AU Wokingham
    27
    Berkshire
    EnglandBritish96405250002
    WILLIAMS, Brian Frank Rodney
    36 Eliot Drive
    St Germans
    PL12 5NL Saltash
    Cornwall
    Amministratore
    36 Eliot Drive
    St Germans
    PL12 5NL Saltash
    Cornwall
    British13663950001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DM REALISATIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Uvenco Uk Plc
    Ravensbury Terrace
    SW18 4RL London
    17 Rufus Business Centre
    England
    06 apr 2016
    Ravensbury Terrace
    SW18 4RL London
    17 Rufus Business Centre
    England
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione06135746
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    DM REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 12 ago 2016
    Consegnato il 16 ago 2016
    In corso
    Breve descrizione
    The freehold property known as drinkmaster LTD, plymouth road, liskeard (PL14 3PG) registered at the land registry with title number CL80621.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Reward Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 16 ago 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 12 ago 2016
    Consegnato il 16 ago 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Reward Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 16 ago 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal charge
    Creato il 24 ago 2007
    Consegnato il 06 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Former cartuther works plymouth road liskeard cornwall t/no CL80621 floating charge over all unfixed plant machinery and other assets and equipment. Assignment of the goodwill, the benefit of licence or certificate and the right to recover and receive any compensation payable in respect of the licence or certificate.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 06 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 24 ago 2007
    Consegnato il 31 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Former cartuther works plymouth road liskeard cornwall t/n CL80621,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 25 ott 2000
    Consegnato il 01 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 ott 2000
    Consegnato il 01 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Part of former cartuther works plymouth road liskeard cornwall t/no;-CL80621. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An instrument constituting £1M 10/12% guaranteed secured loan stock 2006 of drinkmaster holdings limited (the instrument)
    Creato il 28 apr 1998
    Consegnato il 16 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from drinkmaster holdings limited and guaranteed by the company to the chargee pursuant to the instrument to the stockholders (as therein defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Holders for the Time Being of the Stock as Constituted by the Instrument
    Transazioni
    • 16 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 apr 1998
    Consegnato il 07 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 28 apr 1998
    Consegnato il 07 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Life policy 2931506LH of brian steven garner for the sum assured of £1,000,000 for 5 years from 24 october 1997 with the insurer general accident life assurance limited of ga life south and service centre,po box 2413,300 kings road,reading RG1 4XY.all sums assured by the policy and other bonuses and benefits which may arise under the policy.the company's whole right,title and interest present and future in the policy.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Instrument
    Creato il 18 mag 1992
    Consegnato il 27 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from ingleby (592) limited to the chargee as defined (constituting £1,000,000 15% guaranteed secured loan stock 2000) under the terms of the charge
    Brevi particolari
    See 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Stockholders
    Transazioni
    • 27 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Instrument
    Creato il 18 mag 1992
    Consegnato il 27 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from ingleby (592) limited to the stockholders, as defined, (constituting £1,000,000 15% guaranteed secured loan stock 2000) under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Please see doc full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Stockholders, as Defined
    Transazioni
    • 27 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of warranties
    Creato il 18 mag 1992
    Consegnato il 23 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights, title and interest in respect of the warranties and indemnities.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Dbenture
    Creato il 18 mag 1992
    Consegnato il 22 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mag 1992
    Consegnato il 22 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property at plymouth road, liskeard,cornwall.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mag 1992
    Consegnato il 22 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 50, block b, brittania way, lichfield, staffs.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    DM REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 mag 2018Inizio dell'amministrazione
    20 mag 2020Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Howard Smith
    1 Sovereign Square Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Sovereign Square Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    West Yorkshire
    David James Costley-Wood
    1 Sovereign Square Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Sovereign Square Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    West Yorkshire
    2
    DataTipo
    20 mag 2020Inizio della liquidazione
    27 apr 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David James Costley-Wood
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Praticante
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Howard Smith
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Praticante
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Richard John Harrison
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Praticante
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0