LPNS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LPNS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02719478 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LPNS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova LPNS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Cavendish House Lakpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LPNS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CHARCO 500 LIMITED | 02 giu 1992 | 02 giu 1992 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LPNS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per LPNS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Henry Whitehead come amministratore in data 05 giu 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Carl Michael Brown come amministratore in data 05 giu 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 feb 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Collison come amministratore in data 31 gen 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 20 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 feb 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Mark Preece come amministratore in data 16 feb 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Mark Pethick come amministratore in data 31 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Richard Mark Preece come amministratore in data 22 gen 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 gen 2016 al 31 dic 2015 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Collison come amministratore in data 22 gen 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Victoria Haynes come segretario in data 01 dic 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Enbrook Park Sandgate Folkestone Kent CT20 3SE a Cavendish House Lakpur Court Staffordshire Technology Park Stafford ST18 0FX in data 04 dic 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy Mark Pethick come amministratore in data 09 set 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Darryn Stanley Gibson come amministratore in data 09 set 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr John Henry Whitehead il 01 mar 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Victoria Haynes come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Taguma Ngondonga come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LPNS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN, Carl Michael | Amministratore | Lakpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House United Kingdom | England | British | 232841280001 | |||||
| COLLISON, David | Segretario | 44 Lowther Road SW13 9NU London England | British | 34835160001 | ||||||
| DAVIES, John | Segretario | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | 158563050001 | |||||||
| DAVIES, John | Segretario | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | 158275520001 | |||||||
| FAULKNER, Keith John | Segretario | Pantiles Boyndon Road SL6 4EU Maidenhead Berkshire | British | 52027680001 | ||||||
| HAYNES, Victoria | Segretario | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | British | 182412280001 | ||||||
| HIGGINS, Jean Margaret Lindsay | Segretario | Wallings Heathfield Lane BR7 6AH Chislehurst Kent | British | 30133150001 | ||||||
| MUIR, Donald Weir | Segretario | 3a Westholme Orpington BR6 0AN Kent | British | 109407620001 | ||||||
| NGONDONGA, Taguma | Segretario | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire United Kingdom | 171612760001 | |||||||
| NICHOL, Dominic Paul | Segretario | Fairview 5 Gravel Hill UB8 1PB Uxbridge Middlesex | British | 2392710001 | ||||||
| ROBERTS THOMAS, Caroline Emma | Segretario | 5 Broomsleigh Street NW6 1QQ London | British | 76032450005 | ||||||
| WINDMILL, Andrew Lewis | Segretario | Bell Crescent Longwick HP27 9SE Princes Risborough 42 Buckinghamshire | British | 24690030001 | ||||||
| WINDMILL, Andrew Lewis | Segretario | Bell Crescent Longwick HP27 9SE Princes Risborough 42 Buckinghamshire | British | 24690030001 | ||||||
| HALCO SECRETARIES LIMITED | Segretario | 8-10 New Fetter Lane EC4A 1RS London | 42871950001 | |||||||
| BENNETT, Lilian Margery | Amministratore | 67 Porchester Terrace W2 3TT London | British | 33621670001 | ||||||
| BOOTY, Stephen Martin | Amministratore | South Lodge Guildford Road KT24 5QE Effingham Surrey | England | British | 147928010001 | |||||
| COLLISON, David | Amministratore | Lakpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House United Kingdom | United Kingdom | British | 34835160001 | |||||
| DAVIES, David Bruce | Amministratore | 27 Hogback Wood Road HP9 1JT Beaconsfield Buckinghamshire | British | 42256820001 | ||||||
| ELIAS, Lynn | Amministratore | The Willows West Street SL7 2BS Marlow Buckinghamshire | British | 36599830001 | ||||||
| ELLIS, Martyn Anthony | Amministratore | Beaconsfield Road AL10 8HU Hatfield Beaconsfield Court Hertfordshire United Kingdom | England | British | 95749550002 | |||||
| GEORGE-JONES, Susan Mary | Amministratore | 8 Heron Island Caversham RG4 8DQ Reading Berkshire | British | 20742250001 | ||||||
| GIBSON, Darryn Stanley | Amministratore | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | United Kingdom | New Zealander | 177930490001 | |||||
| GIFFIN, Michael | Amministratore | 19 Burntwood Road TN13 1PS Sevenoaks Kent | British | 30133140001 | ||||||
| GRAY, Susan Annette | Amministratore | 64 South Worple Way SW14 8PA London | British | 55858850003 | ||||||
| HERBERTSON, Iain James Wilson | Amministratore | 19 Bryanston Mews West W1H 2BW London | England | British | 67717790003 | |||||
| HIGGINS, Jean Margaret Lindsay | Amministratore | Wallings Heathfield Lane BR7 6AH Chislehurst Kent | British | 30133150001 | ||||||
| HORGAN, Michael David | Amministratore | 7 Lady Yorke Park Seven Hills Road SL0 0PD Iver Buckinghamshire | England | British | 107985980001 | |||||
| HOWARD, Stuart Michael | Amministratore | Enbrook Park CT20 3SE Folkestone 2 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 160271430001 | |||||
| HOWARD, Stuart Michael | Amministratore | Enbrook Park CT20 3SE Folkestone 2 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 160271430001 | |||||
| IVERS, John Joseph | Amministratore | Sandon Brook Manor Maldon Road CM2 7RZ Chelmsford Brook Lodge Essex | United Kingdom | British | 77692980002 | |||||
| JEWITT, Justin Allan Spaven, Professor | Amministratore | The Stables 89 Aston End Road Aston SG2 7EY Stevenage Hertfordshire | England | British | 39701670001 | |||||
| LYON, David Oliver | Amministratore | 41 Park Avenue North AL5 2EE Harpenden Hertfordshire | England | British | 51084280003 | |||||
| MIFFLING, Maureen | Amministratore | The Garden House Dodington Chipping Sodbury BS17 6SG Bristol | British | 6062360002 | ||||||
| MUIR, Donald Weir | Amministratore | 3a Westholme Orpington BR6 0AN Kent | United Kingdom | British | 109407620001 | |||||
| NICHOL, Dominic Paul | Amministratore | Fairview 5 Gravel Hill UB8 1PB Uxbridge Middlesex | England | British | 2392710001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LPNS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestor Healthcare Group Limited | 06 apr 2016 | Lakhpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
LPNS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Creato il 25 giu 1993 Consegnato il 01 lug 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0