CORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED

CORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02720955
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    URBANCHAIN LIMITED11 dic 200311 dic 2003
    PREMIERE EMPLOYMENT GROUP LIMITED03 gen 199503 gen 1995
    PREMIERE EMPLOYMENT LIMITED17 lug 199217 lug 1992
    GREATUSUAL LIMITED08 giu 199208 giu 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di CORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per CORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Jack Rainer Ullmann come amministratore in data 12 mar 2021

    1 pagineTM01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 027209550014 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Chris Martin Kenneally come amministratore in data 16 mar 2020

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 027209550015 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 gen 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    7 pagineAA

    Conti modificati per una società dormiente redatti al 31 dic 2016

    7 pagineAAMD

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 giu 2016 al 31 dic 2016

    1 pagineAA01

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2016 al 30 giu 2016

    1 pagineAA01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2015

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 mag 2016

    Stato del capitale al 12 mag 2016

    • Capitale: GBP 52,632
    SH01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 giu 2015 al 31 dic 2015

    1 pagineAA01

    Nomina di Mr Chris Kenneally come amministratore in data 17 set 2015

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di CORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CONNOR, Alan
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Segretario
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    British118003220001
    ULLMANN, Phillip Lionel
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Amministratore
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    EnglandBritish46458480002
    BELCHEM, Gary
    17 Turkey Oak Close
    Upper Norwood
    SE19 2NZ London
    Segretario
    17 Turkey Oak Close
    Upper Norwood
    SE19 2NZ London
    British66391670002
    GARRATT, Mark Jonathan
    21 Stradella Road
    Herne Hill
    SE24 9HN London
    Segretario
    21 Stradella Road
    Herne Hill
    SE24 9HN London
    British118003050001
    MARKS, Dorian Alan
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    Segretario
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    British94546740001
    MARKS, Dorian Alan
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    Segretario
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    British94546740001
    MILLER, David
    3 Worsdell Way
    SG4 0EB Hitchin
    Hertfordshire
    Segretario
    3 Worsdell Way
    SG4 0EB Hitchin
    Hertfordshire
    British59650030004
    TAYLOR, Michael John
    6 Garratts Lane
    SM7 2DZ Banstead
    Surrey
    Segretario
    6 Garratts Lane
    SM7 2DZ Banstead
    Surrey
    British64380001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BIDDULPH, David Paul
    34 Clough Fold
    Radcliffe
    M26 1GZ Manchester
    Amministratore
    34 Clough Fold
    Radcliffe
    M26 1GZ Manchester
    UkBritish57327250001
    BLEASDALE, Kathleen Veronica
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish67650680001
    CARISS, John Stuart
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish69554890001
    CHAPMAN, Clive Richard
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    Amministratore
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    United KingdomBritish86129050001
    DURSTON, Robert
    13 Roundell Road
    BB18 6EB Barnoldswick
    Lancashire
    Amministratore
    13 Roundell Road
    BB18 6EB Barnoldswick
    Lancashire
    British110017830001
    HALLIDAY, Steven Don
    Laneside Wallbank Road
    Bramhall
    SK7 3AP Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Laneside Wallbank Road
    Bramhall
    SK7 3AP Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish61413670001
    KENNEALLY, Chris Martin
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Amministratore
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    WalesBritish267876240001
    KIRKPATRICK, Steven William
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Amministratore
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Northern IrelandNorthern Irish185295780002
    MARKS, Dorian Alan
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    Amministratore
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    British94546740001
    MARKS, Dorian Alan
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    Amministratore
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    British94546740001
    O'BRIEN, Fergal
    79 Hermitage Road
    WA15 8BW Hale
    Cheshire
    Amministratore
    79 Hermitage Road
    WA15 8BW Hale
    Cheshire
    Irish78893160002
    O'BRIEN, Fergal
    79 Hermitage Road
    WA15 8BW Hale
    Cheshire
    Amministratore
    79 Hermitage Road
    WA15 8BW Hale
    Cheshire
    Irish78893160002
    PERCIVAL, Lorraine Elizabeth
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Amministratore
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    United KingdomBritish85413680001
    PILGRIM, Alan John Templer
    44 Pepper Hill
    Great Amwell
    SG12 9RZ Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    44 Pepper Hill
    Great Amwell
    SG12 9RZ Ware
    Hertfordshire
    EnglandBritish11755290002
    PINDER, John Richard
    West Pelham
    Manor Park
    BR7 5QE Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    West Pelham
    Manor Park
    BR7 5QE Chislehurst
    Kent
    British78379030001
    ULLMANN, Jack Rainer
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Amministratore
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    EnglandBritish11342820001
    ULLMANN, Marianne Flora
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Amministratore
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    EnglandBritish6228260001
    WILLIAMSON, Lynda
    277 Hardsough Lane
    Irwell Vale Ewood Bridge
    BL0 0QF Rossendale
    Lancashire
    Amministratore
    277 Hardsough Lane
    Irwell Vale Ewood Bridge
    BL0 0QF Rossendale
    Lancashire
    British39140490001
    WILLIAMSON, Mark
    94 Ringley Road
    Whitefield
    M45 7UV Manchester
    Amministratore
    94 Ringley Road
    Whitefield
    M45 7UV Manchester
    British64862020001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Cordant Professional Staffing Limited
    Long Lane
    Hillingdon
    UB10 9PF Uxbridge
    346
    England
    06 apr 2016
    Long Lane
    Hillingdon
    UB10 9PF Uxbridge
    346
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEnglish
    Luogo di registrazioneUk Companies House
    Numero di registrazione1397983
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    CORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 04 giu 2015
    Consegnato il 12 giu 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Fixed and floating charges over all the assets and undertaking of the company, present and future, as more particularly described in clause 3 of the debenture.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 04 giu 2015
    Consegnato il 12 giu 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Fixed and floating charges over all the assets and undertaking of the company, present and future, as more particularly described in clause 2 of the debenture.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 12 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 set 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 mag 2011
    Consegnato il 28 mag 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 28 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 set 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 mag 2011
    Consegnato il 27 mag 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 set 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security accession deed to a debenture originally dated 14 june 2007 and
    Creato il 05 ago 2009
    Consegnato il 19 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties and from the chargors to rbs invoice finance limited under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, investments. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 19 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 05 feb 2007
    Consegnato il 16 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC (C/O the Royal Bank of Scotland PLC)
    Transazioni
    • 16 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 09 dic 2003
    Consegnato il 12 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as premiere employment group limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 12 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 07 gen 2000
    Consegnato il 26 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Security Beneficiaries
    Transazioni
    • 26 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 30 dic 1999
    Consegnato il 15 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £25,041.60 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Brevi particolari
    The interest in the deposit account in which the initial deposit of £25,041.60 has been placed and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norscot Investments Limited
    Transazioni
    • 15 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 18 ago 1999
    Consegnato il 25 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Security Trustee for the Securitybeneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 25 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 ago 1998
    Consegnato il 12 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 22 dic 1997
    Consegnato il 09 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 01 ott 1993
    Consegnato il 08 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit agreement
    Creato il 30 ott 1992
    Consegnato il 09 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 30/10/92
    Brevi particolari
    £10,672.20.
    Persone aventi diritto
    • National and Provincial Building Society
    Transazioni
    • 09 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 ago 1992
    Consegnato il 24 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trust PLC
    Transazioni
    • 24 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0