ANS CONTRACT HEALTHCARE (HARTLEPOOL) LIMITED

ANS CONTRACT HEALTHCARE (HARTLEPOOL) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàANS CONTRACT HEALTHCARE (HARTLEPOOL) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02725154
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ANS CONTRACT HEALTHCARE (HARTLEPOOL) LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova ANS CONTRACT HEALTHCARE (HARTLEPOOL) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bridge House, Outwood Lane
    Horsforth
    LS18 4UP Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ANS CONTRACT HEALTHCARE (HARTLEPOOL) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GOULDITAR NO. 226 LIMITED23 giu 199223 giu 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di ANS CONTRACT HEALTHCARE (HARTLEPOOL) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per ANS CONTRACT HEALTHCARE (HARTLEPOOL) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Nicholas Tetley Beazley il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Simon Philip Reiter il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mahboob Ali Merchant il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Fraser David Gregory il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Ellerby il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    legacy

    4 pagine363a

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 07/01/2009
    RES13

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    12 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine403a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    14 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ANS CONTRACT HEALTHCARE (HARTLEPOOL) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Segretario
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    107319700001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish105797560001
    ELLERBY, Mark
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish40582650004
    GREGORY, Fraser David
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    Amministratore
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    United KingdomBritish107664270001
    MERCHANT, Mahboob Ali
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    Amministratore
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish56732410001
    REITER, Simon Philip
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    England
    Amministratore
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    England
    United KingdomBritish135845570001
    KING, Robert Frederick
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    Segretario
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    British10012650001
    MEENAGHAN, Evelyn Maria
    48 Cedars Avenue
    E17 7QN London
    Segretario nominato
    48 Cedars Avenue
    E17 7QN London
    British900001370001
    SLC REGISTRARS LIMITED
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    Segretario
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    34893920001
    DALY, Geoffrey William Stuart
    Sixpenny Buckle
    Coldhouse Hill
    GU22 0QS Woking
    Surrey
    Amministratore
    Sixpenny Buckle
    Coldhouse Hill
    GU22 0QS Woking
    Surrey
    United KingdomBritish19464860003
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish29367700001
    DHANDSA, Narinder, Dr
    D102 Montevetro
    100 Battersea Church Road Battersea
    SW11 3YL London
    Amministratore
    D102 Montevetro
    100 Battersea Church Road Battersea
    SW11 3YL London
    EnglandBritish115844000001
    GRASSBY, Kevin Michael Peter
    5 Campden Hill Court
    Campden Hill Road
    W8 7HX London
    Amministratore
    5 Campden Hill Court
    Campden Hill Road
    W8 7HX London
    United KingdomBritish66022700002
    KENT, Benjamin David Jemphrey
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish93897360003
    SEATON, Stuart Neil
    12 Priory Walk
    SW10 9SP London
    Amministratore delegato nominato
    12 Priory Walk
    SW10 9SP London
    United KingdomBritish900001360001
    SINCLAIR BROWN, Frederick John
    Rudge House
    Itchel Lane Crondall
    GU10 5PR Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Rudge House
    Itchel Lane Crondall
    GU10 5PR Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish8070730003
    TAYLOR, Neil Robert
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    Amministratore
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    United KingdomBritish62846800003
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish6658190001

    ANS CONTRACT HEALTHCARE (HARTLEPOOL) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 09 gen 2004
    Consegnato il 14 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest from time to time in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 14 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 mar 2001
    Consegnato il 11 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations of the company to the chargee or any of the other secured parties under the facilities or mezzanine loan facility
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge and assignment
    Creato il 30 apr 1998
    Consegnato il 19 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of charge all the agreement details of which are set out in the schedule and the benefit of the same.by way of assignment all moneys due or owing or from time to time becoming due to the company under the agreement.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 apr 1998
    Consegnato il 13 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Brierton lodge nursing home brierton lane hartlepool county of hartlepool t/n-CE132044.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 apr 1998
    Consegnato il 07 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 dic 1994
    Consegnato il 28 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility agreement dated 23RD december 1994 and the deed (as defined therein)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Meespierson N.V.
    Transazioni
    • 28 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0