PILLAR RETAIL NO.1 LIMITED

PILLAR RETAIL NO.1 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPILLAR RETAIL NO.1 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02725160
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PILLAR RETAIL NO.1 LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova PILLAR RETAIL NO.1 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    KPMG RESTRUCTURING
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PILLAR RETAIL NO.1 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PARDEV (WEST GEORGE STREET) LIMITED21 dic 199221 dic 1992
    GOULDITAR NO. 231 LIMITED23 giu 199223 giu 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di PILLAR RETAIL NO.1 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per PILLAR RETAIL NO.1 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    3 pagineAA

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    5 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da York House 45 Seymour Street London W1H 7LX in data 10 gen 2011

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "In Specie"
    1 pagineLIQ MISC RES

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 09 dic 2010

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 ago 2010

    Stato del capitale al 03 ago 2010

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    19 pagineAA

    Nomina di Benjamin Toby Grose come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Valentine Beresford come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Philip John Martin come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Jones come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Stirling come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    3 pagineAA

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    3 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine287

    Chi sono gli amministratori di PILLAR RETAIL NO.1 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARTIN, Philip John
    Runwick Hill
    Runwick Lane
    GU10 5EE Farnham
    Surrey
    Segretario
    Runwick Hill
    Runwick Lane
    GU10 5EE Farnham
    Surrey
    British35118050001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    MARTIN, Philip John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish35118050001
    MEENAGHAN, Evelyn Maria
    48 Cedars Avenue
    E17 7QN London
    Segretario nominato
    48 Cedars Avenue
    E17 7QN London
    British900001370001
    BERESFORD, Valentine Tristram
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    Amministratore
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    EnglandBritish40766290003
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Amministratore
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    MAXTED, Robert David
    Vanhurst
    Thorncombe Street
    GU5 0ND Bramley
    Surrey
    Amministratore
    Vanhurst
    Thorncombe Street
    GU5 0ND Bramley
    Surrey
    British37177990001
    MCGANN, Martin Francis
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    Amministratore
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    British109383240001
    MOULD, Harold Raymond
    40 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    Amministratore
    40 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    EnglandBritish35576350006
    PRICE, Humphrey James Montgomery
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    Amministratore
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    UkBritish14448630001
    SEATON, Stuart Neil
    12 Priory Walk
    SW10 9SP London
    Amministratore delegato nominato
    12 Priory Walk
    SW10 9SP London
    United KingdomBritish900001360001
    STIRLING, Mark Andrew
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritish106882210001
    VAUGHAN, Patrick Lionel
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    Amministratore
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    United KingdomBritish73972350001

    PILLAR RETAIL NO.1 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 26 nov 2003
    Consegnato il 05 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H land and buildings k/a fosse park south, south narborough, leicester t/no. LT254104. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hypo Real Estate Capital Limited as Agent and Trustee for the Finance Parties (The "Facilityagent")
    Transazioni
    • 05 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 08 gen 2002
    Consegnato il 22 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (actual or contingent and whether jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to each finance party under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    Various properties headed by f/h land k/a broughton shopping park chester t/no;-WA875009 and f/h land k/a deepdale retail park blackpool road preston lancashire LA624965. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und-Vereinsbank Aktienegesellschaft London Branch(As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 22 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 16 mar 1998
    Consegnato il 01 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to each finance party under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    Land lying to the east of narborough road south narborough leicestershire known as fosse park south (formerly fosse plaza) t/n LT254104 st james retail park knaresborough north yorkshire t/n NYK191096 land and buildings on the north side of manchester road known as northwich retail park manchester road northwich t/n CH289431 CH302431. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft(Agent)
    Transazioni
    • 01 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation of rents
    Creato il 16 mar 1998
    Consegnato il 20 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company, pillar retail parks limited and/or any other obligor (as defined in the credit agreement) to the chargee as agent and trustee for itself and the other finance parties (as defined in the credit agreement) under the terms of the credit agreement
    Brevi particolari
    The company's right title and interest in and to the rental income (as defined in the credit agreement) payable in respect of the lease dated 29TH october 1997 and 9TH january 1998 and the subjects at dumfries retail park, glasgow road, dumfries. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transazioni
    • 20 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 17TH march 1998
    Creato il 11 mar 1998
    Consegnato il 25 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations monies and liabilities due or to become due from the company and/or pillar retail parks limited and/or any other obligor (as defined in the credit agreement) to the chargee as agent and trustee for itself and the other finance parties (as defined in the credit agreement) pursuant to a credit agreement dated 11TH march 1998 and each finance document
    Brevi particolari
    Land lying to the south of dumfries by-pass and north east of glasgow road dumfries and land lying to the west, land lying between glasgow road and college road, land at lincluden dumfries. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transazioni
    • 25 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 13 apr 1993
    Consegnato il 15 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and whole a building comprising the development of shops banking and offices k/a and forming consort house west george street glasgow. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rheinhyp Rheinische Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 15 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 05 apr 1993
    Consegnato il 15 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Rheinhyp Rheinische Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 15 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PILLAR RETAIL NO.1 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 dic 2011Data di scioglimento
    09 dic 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0