UKRD GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàUKRD GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02725453
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di UKRD GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova UKRD GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Media House Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di UKRD GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    UK RADIO HOLDINGS LIMITED04 nov 199204 nov 1992
    PRINTRECORD LIMITED24 giu 199224 giu 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di UKRD GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per UKRD GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2020

    12 pagineAA

    legacy

    46 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 giu 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2020 al 31 dic 2020

    1 pagineAA01

    Bilancio consolidato redatto al 30 set 2019

    38 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 02 ott 2020

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 15/09/2020
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 14 set 2020

    • Capitale: GBP 14,198,749.95
    3 pagineSH01

    Seconda presentazione di uno stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 20 ago 2020

    • Capitale: GBP 12,485,749.95
    4 pagineRP04SH01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 20 ago 2020

    • Capitale: GBP 12,485,750
    4 pagineSH01
    Note
    DataNota
    23 set 2020Clarification A second filed SH01 was registered on 23/09/2020

    Cessazione della carica di James Laws Wenger come amministratore in data 20 ago 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Bauer Group Secretariat Ltd come segretario in data 20 ago 2020

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Andrew Richard Preece come amministratore in data 20 ago 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Preece come segretario in data 20 ago 2020

    1 pagineTM02

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Memorandum e Statuto

    11 pagineMA

    Chi sono gli amministratori di UKRD GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAUER GROUP SECRETARIAT LTD
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Segretario
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione944753
    270106790001
    FORD, Deidre Ann
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    United KingdomBritish109666380002
    KEENAN, Paul Anthony
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    EnglandBritish243390510001
    VICKERY, Sarah Jane
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    EnglandBritish119137220004
    CLAYTON, Yvonne Lynn
    South Bank
    31a Woodland Avenue
    TR10 8PG Penryn
    Cornwall
    Segretario
    South Bank
    31a Woodland Avenue
    TR10 8PG Penryn
    Cornwall
    British40640850001
    HUMM, Roger James
    Dinghurst Road
    Churchill
    BS25 5PJ Winscombe
    Westfield Orchard
    Avon
    Segretario
    Dinghurst Road
    Churchill
    BS25 5PJ Winscombe
    Westfield Orchard
    Avon
    British29914990003
    HYDE, Gerard Joseph
    74 South Audley Street
    W1Y 5FF London
    Segretario
    74 South Audley Street
    W1Y 5FF London
    British78298560002
    PREECE, Andrew
    Carn Brea Studios
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Ukrd Group Limited
    Cornwall
    United Kingdom
    Segretario
    Carn Brea Studios
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Ukrd Group Limited
    Cornwall
    United Kingdom
    157611600001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AARONSON, Glenn Hunter
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    United Kingdom
    Amministratore
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    United Kingdom
    NetherlandsAmerican129927520014
    ANDERSON, Michael
    40 Evans Street
    Bronte
    New South Wales
    2024
    Australia
    Amministratore
    40 Evans Street
    Bronte
    New South Wales
    2024
    Australia
    Australian96506420001
    BENSON, Peter Michael
    Juli Garreta 22
    Girona
    Catalonia 17002
    Spain
    Amministratore
    Juli Garreta 22
    Girona
    Catalonia 17002
    Spain
    Australian69167380004
    BICKMORE, Brian Lindsay
    26a Lansell Road
    Toorak
    Melbourne 3142
    Australia
    Amministratore
    26a Lansell Road
    Toorak
    Melbourne 3142
    Australia
    AustraliaAustralian153909330001
    BODDY, David James
    7 The Sanctuary Parliament Square
    Westminster
    SW1P 3JS London
    Amministratore
    7 The Sanctuary Parliament Square
    Westminster
    SW1P 3JS London
    New Zealand30018020004
    BRUCE, David Kevin
    Rose Cottage
    Wanborough
    GU3 2JR Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Rose Cottage
    Wanborough
    GU3 2JR Guildford
    Surrey
    British37948150003
    DARCH, Jonathan Robert
    The Barn, Court Farm
    Station Road, Blagdon
    BS40 7TD Bristol
    Avon
    Amministratore
    The Barn, Court Farm
    Station Road, Blagdon
    BS40 7TD Bristol
    Avon
    EnglandBritish40673150002
    EVERETT, Anthony David
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    Amministratore
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    EnglandBritish172501910001
    FOO, Peter Edwin
    460 Kangaroo Ground
    Warrandyte Road
    Kangaroo Ground
    Victoria 3097
    Australia
    Amministratore
    460 Kangaroo Ground
    Warrandyte Road
    Kangaroo Ground
    Victoria 3097
    Australia
    Australian50668310001
    HANDLEY, Valerie Jayne
    Spring Cottage
    Stoney Bottom Grayshott
    GU26 6HN Hindhead
    Surrey
    Amministratore
    Spring Cottage
    Stoney Bottom Grayshott
    GU26 6HN Hindhead
    Surrey
    EnglandBritish44328220001
    HASKELL, Mark John
    Manor Cottage
    Lower Netherton
    TQ12 4RL Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    Manor Cottage
    Lower Netherton
    TQ12 4RL Newton Abbot
    Devon
    British24095130004
    HASKELL, Mark John
    1 Copperwood Close
    Ashburton
    TQ13 7JQ Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    1 Copperwood Close
    Ashburton
    TQ13 7JQ Newton Abbot
    Devon
    British24095130003
    HEPBURN, John Keith
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    Amministratore
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    EnglandCanadian16344860001
    HUMM, Roger James
    Dinghurst Road
    Churchill
    BS25 5PJ Winscombe
    Westfield Orchard
    Avon
    Amministratore
    Dinghurst Road
    Churchill
    BS25 5PJ Winscombe
    Westfield Orchard
    Avon
    EnglandBritish29914990003
    HYDE, Gerard Joseph
    74 South Audley Street
    W1Y 5FF London
    Amministratore
    74 South Audley Street
    W1Y 5FF London
    British78298560002
    IBBOTSON, Peter Stamford
    Newnham Farm House
    OX10 8BW Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Newnham Farm House
    OX10 8BW Wallingford
    Oxfordshire
    British8069000001
    KITNEY, Stephen James
    Sunchyme15 Tongham Road
    Runfold
    GU10 1PH Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Sunchyme15 Tongham Road
    Runfold
    GU10 1PH Farnham
    Surrey
    British90188890001
    LAWLEY, Richard Henry John
    3 Pine Bank
    GU26 6SR Hindhead
    Surrey
    Amministratore
    3 Pine Bank
    GU26 6SR Hindhead
    Surrey
    EnglandBritish83623820001
    MCCGWIRE, Patrick Conor
    76a Deodar Road
    SW15 2NJ London
    Amministratore
    76a Deodar Road
    SW15 2NJ London
    British59628620001
    ORME, Simon Patrick
    1 Aubrey Road
    W8 7JJ London
    Amministratore
    1 Aubrey Road
    W8 7JJ London
    American39459500001
    PINCHAM, Roger James
    7 The Postern
    Wood Street, Barbican
    EC2Y 8BJ London
    Amministratore
    7 The Postern
    Wood Street, Barbican
    EC2Y 8BJ London
    United KingdomBritish16343790001
    POWELL, Michael Leslie
    Nightingale Cottage
    Great Holt Old Lane Dockenfield
    GU10 4HQ Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Nightingale Cottage
    Great Holt Old Lane Dockenfield
    GU10 4HQ Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish11273310001
    PREECE, Andrew Richard
    Carn Brea Studios
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Ukrd Group Limited
    Cornwall
    United Kingdom
    Amministratore
    Carn Brea Studios
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Ukrd Group Limited
    Cornwall
    United Kingdom
    EnglandBritish158905700001
    REDFARN, Stephen Charles
    Moray House
    PL20 6DF Yelverton
    Devon
    Amministratore
    Moray House
    PL20 6DF Yelverton
    Devon
    United KingdomBritish75074990002
    ROGERS, William James Gerald
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    Amministratore
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    EnglandBritish37957110009
    SMALLWOOD, Trevor
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    United Kingdom
    Amministratore
    Barncoose Industrial Estate
    TR15 3RQ Redruth
    Carn Brea Studios
    Cornwall
    United Kingdom
    United KingdomBritish1535550001

    Chi sono le persone con controllo significativo di UKRD GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bauer Radio Limited
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    31 mar 2019
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per UKRD GROUP LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    24 giu 201731 mar 2019La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    UKRD GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 01 giu 2012
    Consegnato il 07 giu 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 mag 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deposit agreement
    Creato il 06 ott 2008
    Consegnato il 16 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all such rights to the repayment of the deposit as the depositor may have under the terms upon which the deposit was made. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 12 dic 2006
    Consegnato il 20 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 12 set 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 15 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over shares and memorandum of deposit
    Creato il 02 dic 2002
    Consegnato il 17 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and pirate to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the shares warrants coupons talons and/or intruments representing such shares and all cash securities dividends rights and other property all other property hereafter delivered to the security trustee. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Baring Trust Co Limited Acting as Security Trustee on Behalf of the Loan Stock Holders
    Transazioni
    • 17 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 09 ott 2002
    Consegnato il 29 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £600,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All of its right title and interest in and to the shares (being all of the issued a ordinary shares and b ordinary shares of pirate fm limited) and all proceeds therefrom.
    Persone aventi diritto
    • Marazion Holdings Limited, John Hepburn, Trevor Smallwood and Simon Orme
    Transazioni
    • 29 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of deposit
    Creato il 25 set 2001
    Consegnato il 04 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits credited to account designation 10054572 with the bank and any deposit or account of any other currency. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 dic 1999
    Consegnato il 21 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creato il 30 set 1994
    Consegnato il 05 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company,previously known as UK radio holdings limited,to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    468,500 shares in the capital of cornwall independent radio limited with all dividends declared and all shares stocks securities rights or properties offered to shareholders. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 set 1994
    Consegnato il 22 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cornwall Independent Radio Limited
    Transazioni
    • 22 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 set 1992
    Consegnato il 05 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 ref. M237C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0