OPTRON HOLDING LIMITED

OPTRON HOLDING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOPTRON HOLDING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02725981
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OPTRON HOLDING LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso di apparecchiature e componenti elettronici e di telecomunicazione (46520) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova OPTRON HOLDING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Mazars Llp Tower Brdige House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OPTRON HOLDING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AURIGA (EUROPE) LIMITED12 feb 201012 feb 2010
    AURIGA (EUROPE) PLC10 feb 201010 feb 2010

    Quali sono gli ultimi bilanci di OPTRON HOLDING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per OPTRON HOLDING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    14 pagineLIQ13

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Keens Shay Keens Mk Llp Sovereign Court 230 Upper Fifth Street Central Milton Keynes Bucks MK9 2HR United Kingdom a Sovereign Court U230 Pper Fifth Street Central Milton Keynes Bucks MK9 2HR

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8HJ United Kingdom a C/O Mazars Llp Tower Brdige House St Katharines Way London E1W 1DD in data 24 apr 2020

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 01 apr 2020

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    8 pagineLIQ01

    Cessazione della carica di Keens Shay Keens (Nominees) Limited come segretario in data 01 apr 2020

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Michael Christopher Bowers come amministratore in data 10 feb 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Kevin Gerald Hayden come amministratore in data 10 feb 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Joseph Edward Gallagher come amministratore in data 10 feb 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert Maxey Crowder come amministratore in data 10 feb 2020

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2019

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2018

    16 pagineAA

    Notifica di Optronics Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2017

    25 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8nd a Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8HJ in data 30 ott 2017

    1 pagineAD01

    Notifica di Optronics Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC02

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 giu 2017 con aggiornamenti

    8 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    25 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name12 set 2016

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 09 set 2016

    RES15

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di OPTRON HOLDING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BOWERS, Michael Christopher
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8HJ Milton Keynes
    C/O Optron Holdings Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8HJ Milton Keynes
    C/O Optron Holdings Limited
    United Kingdom
    United KingdomAmerican257748550002
    HAYDEN, Kevin Gerald
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8HJ Milton Keynes
    C/O Optron Holdings Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8HJ Milton Keynes
    C/O Optron Holdings Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish267145030001
    SENG, Kheng
    Tower Brdige House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    C/O Mazars Llp
    Amministratore
    Tower Brdige House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    C/O Mazars Llp
    United KingdomSingaporean199936160001
    REID, Christopher
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    Segretario
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    British157947720001
    REID, Christopher
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    Segretario
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    British157947720001
    STONEHAM, Roy
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8ND Milton Keynes
    Segretario
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8ND Milton Keynes
    181763170001
    CFH COMPANY FORMATIONS LIMITED
    4 Cornwood House
    Weston Road
    GU31 4JF Petersfield
    Hampshire
    Segretario
    4 Cornwood House
    Weston Road
    GU31 4JF Petersfield
    Hampshire
    28069290001
    KEENS SHAY KEENS (NOMINEES) LIMITED
    230 Upper Fifth Street
    MK9 2HR Central Milton Keynes
    Sovereign Court
    Bucks
    United Kingdom
    Segretario
    230 Upper Fifth Street
    MK9 2HR Central Milton Keynes
    Sovereign Court
    Bucks
    United Kingdom
    Forma giuridicaLIMITED
    Tipo di documento di identificazioneExtra-SEE
    Autorità legaleENGLAND & WALES
    189995630001
    REID & CO PROFESSIONAL SERVICES LIMITED
    Witan Court
    305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    Witan Court
    305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    41052090008
    BISHOP, Andrew James
    19 Walton Road
    Walnut Tree
    MK7 7AG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    19 Walton Road
    Walnut Tree
    MK7 7AG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritish68652960002
    CROWDER, Robert Maxey
    Knowlhill
    MK5 8HJ Milton Keynes
    Davy Avenue
    United Kingdom
    Amministratore
    Knowlhill
    MK5 8HJ Milton Keynes
    Davy Avenue
    United Kingdom
    United StatesAmerican181743220001
    DOWNIE, Mike
    21 Leycester Road
    WA16 8QR Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    21 Leycester Road
    WA16 8QR Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish88763870001
    EDWARDS, Phillip Llewellyn
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8ND Milton Keynes
    Amministratore
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8ND Milton Keynes
    WalesBritish191693810001
    GALLAGHER, Joseph Edward
    Knowlhill
    MK5 8HJ Milton Keynes
    Davy Avenue
    United Kingdom
    Amministratore
    Knowlhill
    MK5 8HJ Milton Keynes
    Davy Avenue
    United Kingdom
    United StatesAmerican160633500001
    GLADWELL, Ronald Thomas
    Martins Cottage
    Brook
    SO43 7HE Lyndhurst
    Hampshire
    Amministratore
    Martins Cottage
    Brook
    SO43 7HE Lyndhurst
    Hampshire
    United KingdomBritish29973390001
    GLADWELL, Ronald Thomas
    Martins Cottage
    Brook
    SO43 7HE Lyndhurst
    Hampshire
    Amministratore
    Martins Cottage
    Brook
    SO43 7HE Lyndhurst
    Hampshire
    United KingdomBritish29973390001
    GRILLO, Gianfranco
    Rustlings
    The Woodlands
    SL9 8DE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Rustlings
    The Woodlands
    SL9 8DE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandItalian69542290001
    GRILLO, Gianfranco
    Rustlings
    The Woodlands
    SL9 8DE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Rustlings
    The Woodlands
    SL9 8DE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandItalian69542290001
    HACKETT, Christopher
    76 Clare Gardens
    GU31 4UE Petersfield
    Hampshire
    Amministratore delegato nominato
    76 Clare Gardens
    GU31 4UE Petersfield
    Hampshire
    British900005630001
    HILL, Alison Jane
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8ND Milton Keynes
    Auriga Building
    Bucks
    Amministratore
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8ND Milton Keynes
    Auriga Building
    Bucks
    British140191950001
    JARVIS PEARSON, Colin
    40 Tallis Lane
    Browns Wood
    MK7 8DZ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    40 Tallis Lane
    Browns Wood
    MK7 8DZ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British121672920001
    LIPSON, Graham Keith
    14 Bell Close
    Helmdon
    NN13 5UH Brackley
    Northamptonshire
    Amministratore
    14 Bell Close
    Helmdon
    NN13 5UH Brackley
    Northamptonshire
    British41683080001
    LIPSON, Graham Keith
    14 Bell Close
    Helmdon
    NN13 5UH Brackley
    Northamptonshire
    Amministratore
    14 Bell Close
    Helmdon
    NN13 5UH Brackley
    Northamptonshire
    British41683080001
    REID, Christopher
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    EnglandBritish157947720001
    REID, Christopher
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    EnglandBritish157947720001
    SENIOR, David Mark
    16 Southdown Drive
    SW20 8EZ London
    Amministratore
    16 Southdown Drive
    SW20 8EZ London
    EnglandBritish98000850002
    SWANSON, Albert Louis
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8ND Milton Keynes
    Amministratore
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8ND Milton Keynes
    UsaAmerican181742960001
    GLG ASSOCIATES LIMITED
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    58606320001
    KEATS CONSULTANTS LIMITED
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    Central Milton Keynes
    MK9 1EH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    Central Milton Keynes
    MK9 1EH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    41994070001
    REID & CO CORPORATE SERVICES LIMITED
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    59541290001
    RTG CONSULTANTS LIMITED
    Martins Cottage
    Brook
    SO43 7HE Lyndhurst
    Hampshire
    Amministratore
    Martins Cottage
    Brook
    SO43 7HE Lyndhurst
    Hampshire
    44937120001
    TREVOR KIDD CONSULTANTS LIMITED
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    77633710002

    Chi sono le persone con controllo significativo di OPTRON HOLDING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Optronics Limited
    Knowlhill
    MK5 8ND Milton Keynes
    Davy Avenue
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Knowlhill
    MK5 8ND Milton Keynes
    Davy Avenue
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited
    Autorità legaleEngland & Wales
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    OPTRON HOLDING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 16 ott 2012
    Consegnato il 18 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts including associated rights relating thereto.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transazioni
    • 18 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 21 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge (all assets)
    Creato il 16 ott 2012
    Consegnato il 18 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transazioni
    • 18 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal assignment of contract monies
    Creato il 09 ago 2012
    Consegnato il 10 ago 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 05 gen 2012
    Consegnato il 07 gen 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 07 gen 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 30 set 2003
    Consegnato il 10 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage and otherwise by way of fixed charge the land in davy avenue knowlhill milton keynes (to the full extent of the mortgagor's interest in the property or its proceeds of sale). By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of covenant
    Creato il 30 set 2003
    Consegnato il 10 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1 together with all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    1.27 acres of land at knowlhill milton keynes.
    Persone aventi diritto
    • Commission for the New Towns
    Transazioni
    • 10 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of legal charge
    Creato il 26 set 2001
    Consegnato il 03 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee including but not limited to a loan of £1,300,000
    Brevi particolari
    Land at davey avenue knowlhill milton keynes (site r) containing an area of one decimal point two seven acres or thereabouts and all fixtures and fittings fixed plant and machinery. By way of first floating charge all its undertaking and assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 31 ago 2001
    Consegnato il 08 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the financing agreement (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited (The "Securityholder")
    Transazioni
    • 08 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment and charge
    Creato il 14 ago 2001
    Consegnato il 28 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee (the "secured party") pursuant to the terms of an advice of borrowing terms dated 27TH april 2001 on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the chargor's right in the building contract. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 14 ago 2001
    Consegnato il 18 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed charge over book debts
    Creato il 16 set 1998
    Consegnato il 22 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to the charged asets being all monies payable to the company and all other rights under a business finance agreement between the company and chargee together with all debts arising from the sale of goods the subject thereof together with any right title property or interest of the company in or to the goods to which a debt relatesand all related rights thereto and thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nmb-Heller Limited
    Transazioni
    • 22 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 29 nov 1996
    Consegnato il 03 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge on all book and other debts and by way of floating charge on all proceeds of book debts present & future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alex. Lawrie Receivables Financing Limited
    Transazioni
    • 03 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 11 set 1996
    Consegnato il 23 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 23 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 08 gen 1996
    Consegnato il 15 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or fibrefab limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 22 set 1992
    Consegnato il 09 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the debenture
    Brevi particolari
    All right title and interest of the company ir or arising out of a factoring or invoice discounting deed dated 14/8/92 and any deed amending or replacing the same (the charged deeds) and all book debts and other debts the subject of the charged deeds as and when the same shall become due or owing to the company upon revesting in the company whether pursuant to the charged deeds or otherwise (for full details see form 395 tc ref: M277C).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 ago 1992
    Consegnato il 19 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    OPTRON HOLDING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 apr 2020Inizio della liquidazione
    06 feb 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon David Chandler
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0