CIBC WORLD MARKETS LIMITED

CIBC WORLD MARKETS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCIBC WORLD MARKETS LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02733036
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di CIBC WORLD MARKETS LIMITED?

    • Banche (64191) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova CIBC WORLD MARKETS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O INTERPATH LTD
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CIBC WORLD MARKETS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CIBC WORLD MARKETS PLC28 apr 199928 apr 1999
    CIBC WOOD GUNDY PLC24 nov 199524 nov 1995
    CIBC BANK PLC02 nov 199202 nov 1992
    STOCKCAPITAL PUBLIC LIMITED COMPANY21 lug 199221 lug 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di CIBC WORLD MARKETS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 ott 2021
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 lug 2022
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2020

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CIBC WORLD MARKETS LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al27 ott 2021
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma10 nov 2021
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al27 ott 2020
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per CIBC WORLD MARKETS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 feb 2025

    21 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 feb 2024

    23 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 feb 2023

    24 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    104 pagineLIQ10

    Indirizzo della sede legale modificato da 10 Fleet Place London EC4M 7QS a 10 Fleet Place London EC4M 7RB in data 04 lug 2022

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 feb 2022

    12 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 15 Canada Square London E14 5GL a 10 Fleet Place London EC4M 7QS in data 14 dic 2021

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    42 pagine600

    Dimissioni di un liquidatore

    3 pagineLIQ06

    Seconda presentazione per la nomina di Mr Wayne Lee come amministratore

    6 pagineRP04AP01

    Dichiarazione di solvibilità

    7 pagineLIQ01

    Indirizzo della sede legale modificato da 150 Cheapside London EC2V 6ET a 15 Canada Square London E14 5GL in data 18 feb 2021

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Carla Craig come segretario in data 04 feb 2021

    2 pagineTM02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 04 feb 2021

    LRESSP

    Cessazione della carica di Marshall Charles Bailey come amministratore in data 31 dic 2020

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 ott 2020

    117 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    2 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 ott 2020 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di CIBC WORLD MARKETS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ATKINSON, Paul David
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    10
    Amministratore
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    10
    EnglandBritish193722190001
    CLIMO, Donald Christopher Bryce
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    10
    Amministratore
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    10
    CanadaCanadian241500930001
    FOREMAN-PURVES, Meghan Alice
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    United KingdomBritish,Australian260945620002
    LEE, Wayne
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    United KingdomCanadian250441360001
    AUSTIN, David Richard
    5 Widford Hill
    Widford
    SG12 8SW Ware
    Hertfordshire
    Segretario
    5 Widford Hill
    Widford
    SG12 8SW Ware
    Hertfordshire
    British56913080001
    BASHFORTH, Jonathan Howie
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    Segretario
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    164968080001
    CRAIG, Carla
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    Segretario
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    256435170001
    HOURIGAN, Louise Frances
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    Segretario
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    203782990001
    PURVES, Meghan
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    Segretario
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    214607900001
    SCOTT, Angus George James
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    Segretario
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    British74173430002
    SORRELL, David John
    12 Ruskin Road
    DA17 5BB Belvedere
    Kent
    Segretario
    12 Ruskin Road
    DA17 5BB Belvedere
    Kent
    British7749400001
    TANNA, Shashi
    16 Southfield Way
    AL4 9JJ St Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    16 Southfield Way
    AL4 9JJ St Albans
    Hertfordshire
    Uk1515730001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AUSTIN, David Richard
    5 Widford Hill
    Widford
    SG12 8SW Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 Widford Hill
    Widford
    SG12 8SW Ware
    Hertfordshire
    British56913080001
    BAILEY, Marshall Charles
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    United KingdomBritish187892510002
    BUCKLEY, David
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    United KingdomBritish214028790001
    COHEN, Graham John
    48 Melody Road
    Wandsworth
    SW18 2QF London
    Amministratore
    48 Melody Road
    Wandsworth
    SW18 2QF London
    UkAustralian42403580001
    CORNFORD, Michael
    Hunsdonbury
    Hunsdon
    SG12 8PW Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    Hunsdonbury
    Hunsdon
    SG12 8PW Ware
    Hertfordshire
    British43733590001
    CRADDOCK, Geoffrey James
    Stepping Stone Lane
    CT 06830 Greenwich
    11
    Connecticut
    Usa
    Amministratore
    Stepping Stone Lane
    CT 06830 Greenwich
    11
    Connecticut
    Usa
    Dual Uk/Us128677580001
    DE GIORGIO-MILLER, Joseph
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    EnglandBritish104947380002
    DENHAM, Gillian Helen
    42 Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PE London
    Amministratore
    42 Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PE London
    Canadian45518860001
    DENHAM, Gillian Helen
    42 Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PE London
    Amministratore
    42 Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PE London
    Canadian45518860001
    DLUGAN, Dennis
    21 Overlea Blvd
    Unit 1703
    M4H 1P2 Toronto
    Ontaria
    Canada
    Amministratore
    21 Overlea Blvd
    Unit 1703
    M4H 1P2 Toronto
    Ontaria
    Canada
    Canadian86374670001
    DODIG, Edward
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    United KingdomCanadian163882730001
    DORAN, John
    2270 Saxony Court
    FOREIGN Mississauga
    Ontario L5h 4b5
    Canada
    Amministratore
    2270 Saxony Court
    FOREIGN Mississauga
    Ontario L5h 4b5
    Canada
    Canadian18251240001
    ELLEN, Simon Tudor
    Sbj Ltd
    100 Whitechapel Road
    E1 1JG London
    Amministratore
    Sbj Ltd
    100 Whitechapel Road
    E1 1JG London
    United KingdomBritish111926600001
    FERGUSON, Daniel Stanley
    Four Winds Old Avenue
    KT13 0QB Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Four Winds Old Avenue
    KT13 0QB Weybridge
    Surrey
    Canadian17148400002
    GERBER, Chuck
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    UsaUsa152590660001
    HAYES, Derek Cumberland
    287 Erskine Avenue
    Toronto
    M4P 1Z6 Ontario
    Canada
    Amministratore
    287 Erskine Avenue
    Toronto
    M4P 1Z6 Ontario
    Canada
    Canadian45821740001
    HOURIGAN, Louise Frances
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    United KingdomBritish191119100001
    HUGHES, Simon Philip Griffith
    52 Ringmer Avenue
    SW6 5LW London
    Amministratore
    52 Ringmer Avenue
    SW6 5LW London
    United KingdomBritish100548100001
    INSKIP, Cliff
    Ballards Mead Ballards Lane
    Limpsfield
    RH8 0SN Oxted
    Surrey
    Amministratore
    Ballards Mead Ballards Lane
    Limpsfield
    RH8 0SN Oxted
    Surrey
    Canadian31785020001
    KELLY, Tom
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    IrelandIrish165532010001
    KENYON, Andrew Graham
    Suite 503
    50 Old Mill Road
    Oakville
    L6j 7w1
    Canada
    Amministratore
    Suite 503
    50 Old Mill Road
    Oakville
    L6j 7w1
    Canada
    Canadian70849700002
    KILGOUR, Peter Kenneth
    78 Thorncrest Road
    Toronto
    Ontario
    M9a 1s9
    Canada
    Amministratore
    78 Thorncrest Road
    Toronto
    Ontario
    M9a 1s9
    Canada
    Canadian122850930001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per CIBC WORLD MARKETS LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    27 ott 2016La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    CIBC WORLD MARKETS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Registered definitive note (the "note") executed by cibc world markets PLC (the "company") and r+v lebensversicherung ag (the "noteholder"),pursuant to which the company with full title guarantee has assigned by way of security in favour of the noteholder
    Creato il 01 ott 1999
    Consegnato il 19 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the company's rights,title and interest in and to the underlying asset (as defined in the note) (including all rights in respect thereof or relating thereto (whether or not against third parties)) as security for all the monies and other liabilities payable or owing by the company under the note,
    Brevi particolari
    All rights,title and interest in and to the underlying asset,as defined. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • R + V Lebensversicherung Ag
    Transazioni
    • 19 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 dic 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Registered definitive note (the "note") executed by cibc world markets PLC (the "company") and r+v lebensversicherung ag (the "noteholder"),pursuant to which the company with full title guarantee has assigned by way of security in favour of the noteholder
    Creato il 01 ott 1999
    Consegnato il 19 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the company's rights,title and interest in and to the underlying asset (as defined in the note) (including all rights in respect thereof or relating thereto (whether or not against third parties)) as security for all the monies and other liabilities payable or owing by the company under the note,
    Brevi particolari
    All rights,title and interest in and to the underlying asset (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • R + V Lebensversicherung Ag
    Transazioni
    • 19 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 dic 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered definitive note (the "note")
    Creato il 22 set 1999
    Consegnato il 13 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the note
    Brevi particolari
    First fixed security in favour of the noteholder all the company's right title and interest in and to the underlying assets (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • R & V Lebensversicherung Ag
    Transazioni
    • 13 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 31 dic 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over securities
    Creato il 30 set 1998
    Consegnato il 08 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee (the bank) arising out of transactions between the bank and the company in connection with the cgo and all monies due under the charge
    Brevi particolari
    All eligible stock held by or on behalf of or for the account of the company in the cgo and all and any property rights or interests of the company in or rights of the company to eligible stock in the cgo. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge and assignment
    Creato il 31 lug 1998
    Consegnato il 13 ago 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement or under the structured notes (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to the principal protected notes and in and to the guaranty. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alternative Management Company S.A.(On Behalf of Alternative Leadership Fund Innovation)
    Transazioni
    • 13 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Registered definitive note representing DEM15,000,000 12.4 per cent. Secured amortising note due 2015 (the note) executed by the company and deutscher ring versicherungen (the noteholder)
    Creato il 13 mar 1998
    Consegnato il 25 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the moneys and other liabilities payable or owing by the company under the note
    Brevi particolari
    All the company's rights title and interest in and to the swap transaction including the benefit of the security therefor over the underlying assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutscher Ring Versicherungen
    Transazioni
    • 25 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 06 feb 1998
    Consegnato il 25 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The dem 50,000,000 floating rate secured notes due 2005 pursuant to which the company with full title guarantee has in the trust deed assigned by way of security in favour of the trustee (I) all the company's rights,title and interest in and to the swap transaction (as defined in the trust deed) (including the benefit of the security therefore over the underlying assets (as defined in the trust deed) and (ii) all the company's rights ,title and interest in and to the custody agreement (as defined in the trust deed) and the obligations of the custodian (as define in the trust deed) represented thereby as security for all the moneys and other liabilities payable or owing by the company under the trust deed
    Brevi particolari
    All its rights title and interest in and to the swap transaction (as defined) the custody agreement (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cibc Mellon Trust Company(As Trustee)
    Transazioni
    • 25 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered definitive note (the "note")
    Creato il 01 dic 1997
    Consegnato il 08 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the note (as defined)
    Brevi particolari
    All the company's rights, title and interest in and to the swap transaction (as defined) (including the benefit of the security therfor over the underlying assets (as defined in the schedule)).
    Persone aventi diritto
    • R+V Lebensverischerung Ag
    Transazioni
    • 08 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Declaration of pledge of securities and claims to guarantor by the pledgor accepted by cedel bank on behalf of the guarantor
    Creato il 25 nov 1997
    Consegnato il 04 dic 1997
    In corso
    Importo garantito
    All present and future obligations of the pledgor to the guarantor (a syndicate of banks whose lead bank is citibank N.A.and whose members as at the date of this certificate include banque bruxelles lambert S.A.banque generale du luxembourg S.A.banque internationale a luxembourg S.A.credit commercial de france kredietbank N.V.kredietbank S.A.luxemburgeoise union bank of switzerland and whose composition may periodically change) arising from its guarantee of the pledgor's borrowings of securities arranged under the cedel securities lending and borrowing rules and regulations of march 1997 as amended from time to time (the rules)
    Brevi particolari
    All present and future securities, bonds, notes, certificates of deposit, instruments or rights representing property rights or claims (including a right not represented by a writing) as well as other debentures which may be pledged in the same form as securities according to luxembourg law ("securities"). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Guarantor; Being a Syndicate of Banks Whose Lead Bank is Citibank N.A. Brussels Branch
    Transazioni
    • 04 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Declaration of pledge of securities and claims to guarantor by the pledgor accepted by cedel bank on behalf of the guarantor
    Creato il 25 nov 1997
    Consegnato il 04 dic 1997
    In corso
    Importo garantito
    All present and future obligations of the pledgor to the guarantor (a syndicate of banks whose lead bank is citibank N.A.and whose members as at the date of this certificate include banque bruxelles lambert S.A.banque generale du luxembourg S.A.banque internationale a luxembourg S.A.credit commercial de france kredietbank N.V.kredietbank S.A.luxemburgeoise union bank of switzerland and whose composition may periodically change) arising from its guarantee of the pledgor's borrowings of securities arranged under the cedel securities lending and borrowing rules and regulations of march 1997 as amended from time to time 9THE rules)
    Brevi particolari
    All present and future securities, bonds, notes, certificates of deposit, instruments or rights representing property rights or claims (including a right not represented by a writing) as well as other debentures which may be pledged in the same form as securities according to luxembourg law ("securities"). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Guarantor; Being a Syndicate of Banks Whose Lead Bank is Citibank N.A. Brussels Branch
    Transazioni
    • 04 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    A registered definitive note (the "note")
    Creato il 07 nov 1997
    Consegnato il 25 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "note"
    Brevi particolari
    All rights title and interest in and to the swap transaction (as defined) including the benefit of the security therefor over the underlying assets (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • R+V Lebensversicherung Ag
    Transazioni
    • 25 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Registered definitive note
    Creato il 29 ott 1997
    Consegnato il 17 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and other liabilities due or to become due from the company to the chargee under the note
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to the swap transaction (as defined in the schedule to form 395) including the benefit of the security therefor over the underlying assets (as defined in the schedule) please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • R+V Lebensversicherung Ag
    Transazioni
    • 17 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Cibc share charge
    Creato il 08 ott 1997
    Consegnato il 22 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from dudley waste services limited to the chargee under or pursuant to the secured documents
    Brevi particolari
    As a continuing security the charged shares by way of first legal mortgage and a first fixed charge and by way of first fixed charge the charged accrued share assets meaning all rights,monies,benefits and other property which may at any time accrue or be offered or arise by way of conversion,redemption,bonus,preference,option or otherwise in respect of any of the shares or in substitution or exchange for any of the shares.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Trustee Company Limited (Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Cibc share charge
    Creato il 08 ott 1997
    Consegnato il 22 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from wolverhampton waste services limited to the chargee under or pursuant to the secured documents
    Brevi particolari
    As a continuing security the charged shares by way of first legal mortgage and a first fixed charge and by way of first fixed charge the charged accrued share assets meaning all rights,monies,benefits and other property which may at any time accrue or be offered or arise by way of conversion,redemption,bonus,preference,option or otherwise in respect of any of the shares or in substitution or exchange for any of the shares.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Trustee Company Limited (Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Collateral agreement
    Creato il 19 mar 1996
    Consegnato il 22 mar 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in whatever form that relates to the company's use of the euroclear system
    Brevi particolari
    All collateral including cash securities and clearance accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transazioni
    • 22 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)

    CIBC WORLD MARKETS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 feb 2021Inizio della liquidazione
    04 feb 2021Data della dichiarazione di solvibilità giurata
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Howard Smith
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0