STADIUM PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED

STADIUM PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTADIUM PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02733211
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STADIUM PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova STADIUM PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STADIUM PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SOVCO 476 LIMITED21 lug 199221 lug 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di STADIUM PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per STADIUM PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2012

    4 pagineAA

    Nomina di Mrs Amanda Jayne Standish come amministratore in data 27 set 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Andrew Stuart Fish come segretario in data 27 set 2012

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Shaun Willox come amministratore in data 27 set 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Clive Crooks come amministratore in data 27 set 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Clive Crooks come segretario in data 27 set 2012

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 21 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 lug 2012

    Stato del capitale al 25 lug 2012

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2011

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Stuart Fish il 21 lug 2011

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Shaun Willox come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Andrew Stuart Fish come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Paul Nigel Swales come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Michael Clive Crooks il 21 lug 2010

    2 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Clive Crooks il 21 lug 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Dyson Healey il 21 lug 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2009

    4 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 giu 2008

    4 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di STADIUM PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FISH, Andrew Stuart
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Segretario
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    172413370001
    FISH, Andrew Stuart
    Aberford Road
    Oulton
    LS26 8LD Leeds
    36
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Aberford Road
    Oulton
    LS26 8LD Leeds
    36
    East Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish99181180003
    HEALEY, Edwin Dyson
    West Ella Hall
    West Ella Road West Ella
    HU10 7RP Hull
    East Yorkshire
    Amministratore
    West Ella Hall
    West Ella Road West Ella
    HU10 7RP Hull
    East Yorkshire
    EnglandBritish1798990001
    HEALEY, Paul Dyson
    Spout Hill
    Brantingham
    HU15 1QP Brough
    Brantingham Wold Grange,
    North Humberside
    Amministratore
    Spout Hill
    Brantingham
    HU15 1QP Brough
    Brantingham Wold Grange,
    North Humberside
    EnglandBritish7349500004
    STANDISH, Amanda Jayne
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Amministratore
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    United KingdomBritish172278520001
    SWALES, Paul Nigel
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Amministratore
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    United KingdomBritish42213720002
    CROOKS, Michael Clive
    Eppleworth Road,
    Raywell
    HU16 5ZA Cottingham
    Woodhouse Grange, Westfield Road,
    East Yorkshire
    Segretario
    Eppleworth Road,
    Raywell
    HU16 5ZA Cottingham
    Woodhouse Grange, Westfield Road,
    East Yorkshire
    British48504730008
    HAYMER, Jonathan
    Ravenscar
    Alvanley Road
    WA6 9PS Helsby
    Cheshire
    Segretario
    Ravenscar
    Alvanley Road
    WA6 9PS Helsby
    Cheshire
    British1553510001
    SOVSHELFCO (SECRETARIAL) LIMITED
    PO BOX 8
    Sovereign House South Parade
    LS1 1HQ Leeds
    West Yorkshire
    Segretario nominato
    PO BOX 8
    Sovereign House South Parade
    LS1 1HQ Leeds
    West Yorkshire
    900003500001
    CROOKS, Michael Clive
    Eppleworth Road,
    Raywell,
    HU16 5ZA Cottingham
    Woodhouse Grange Westfield Road
    East Yorkshire
    Amministratore
    Eppleworth Road,
    Raywell,
    HU16 5ZA Cottingham
    Woodhouse Grange Westfield Road
    East Yorkshire
    United KingdomBritish48504730009
    WILLOX, Shaun
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    Amministratore
    Welton Grange
    Welton
    HU15 1NB Brough
    East Yorkshire
    United KingdomBritish99708360002
    SOVSHELFCO (FORMATIONS) LIMITED
    PO BOX 8
    Sovereign House South Parade
    LS1 1HQ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    PO BOX 8
    Sovereign House South Parade
    LS1 1HQ Leeds
    West Yorkshire
    900003490001

    STADIUM PROPERTY ASSET MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Insurance policy proceeds assignment
    Creato il 10 giu 2002
    Consegnato il 17 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due or to become due from neue mitte oberhausen projektentwicklung gmbh & co. (As principal borrower) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All monies of whatsoever kind payable by the insurers to or for the account of the borrowers arising out of or as a result of the policies including all claims for damages arising out of any breach of any of the policies wher the account means the account number 5804327799 with the agent (sort code 70020270) "the policy proceeds account". See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag (As Agent for Itself and the Banks, as Defined)
    Transazioni
    • 17 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 giu 1999
    Consegnato il 19 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In favour of the chargee all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) and stadium developments limited to each finance party under each finance document (as defined) except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hvb Real Estate Capital Limited (The "Facility Agent")
    Transazioni
    • 19 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 ott 1996
    Consegnato il 05 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (as defined) to each finance party under each finance document (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft,London Branch,as Agent and Trusteefor the Finance Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 05 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 ott 1993
    Consegnato il 10 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 18/10/93
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 10 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 nov 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rental assignment
    Creato il 21 ott 1993
    Consegnato il 10 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 18/10/93
    Brevi particolari
    All right title interest in and to all spam rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transazioni
    • 10 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 nov 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 28 set 1993
    Consegnato il 15 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    The rents and/or licences and all interest under the terms of the leases. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transazioni
    • 15 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 01 lug 1993
    Consegnato il 12 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement and/or this charge
    Brevi particolari
    Unit 11B retail park parkgate rotherham south yorkshire together with all buildings and fixtures and fittings.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Weschel-Bank Ag
    Transazioni
    • 12 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 01 lug 1993
    Consegnato il 12 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement ,the charge and the scl charge
    Brevi particolari
    Unit 11B retail park parkgate rotherham south yorkshire together with all buildings fixtures and fittings.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transazioni
    • 12 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mar 1993
    Consegnato il 08 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement of even date
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transazioni
    • 08 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of rental income
    Creato il 31 mar 1993
    Consegnato il 08 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement of even date
    Brevi particolari
    By way of assignment the benefit of all rents and/or licence fees or any other sums whatsoever payable under the leases in the nature of rent or licence fees payable. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transazioni
    • 08 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 31 mar 1993
    Consegnato il 08 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 3/11/92 the finance documents (as defined) and/or this charge
    Brevi particolari
    Second fixed charge the personal agreements and covenants by the tenants lessees or licencees under the letting documents and by all guarantors and all security held by the mortgagor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transazioni
    • 08 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge
    Creato il 31 mar 1993
    Consegnato il 08 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dted 3/11/92 the finance documents (as defined) and/or this charge
    Brevi particolari
    Second fixed charge on the personal agreements covenants by the tenants lessees or licencees under the letting documents and by all guarantors and all security held by the mortgagor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transazioni
    • 08 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 31 mar 1993
    Consegnato il 08 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement, the debenture or otherwise
    Brevi particolari
    The benefit of all rents and/or licence fees or any other sums payable under the leases. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transazioni
    • 08 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0