TELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED

TELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02743032
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED?

    • Attività di produzione di programmi televisivi (59113) / Informazione e comunicazione
    • Creazione artistica (90030) / Attività artistiche, sportive e di divertimento

    Dove si trova TELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House 1
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di TELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 dic 2015

    20 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    22 pagine4.71

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution insolvency:res re liquidators account
    1 pagineLIQ MISC RES

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 dic 2014

    14 pagine4.68

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    2 pagineAD02

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 dic 2013

    15 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da * Maple House 149 Tottenham Court Road London W1T 7NF* in data 28 dic 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution insolvency:special resolution ;- "in specie"
    2 pagineLIQ MISC RES

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Approve the implementation of those aspects of the simplification excise relating to the company and other company business 11/12/2012
    RES13

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 lug 2012 al 31 dic 2012

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 31 lug 2011

    13 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christian Thieme il 24 mar 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christian Thieme il 24 mar 2012

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Christian Thieme come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Geoffrey Walker come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Sukhjiwan Kaur Tung come segretario

    3 pagineAP03

    Nomina di Mr Geoffrey Hulbert Walker come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di David Allmark come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Edward Laurence Catchpole come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jeffrey Dunn come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Sangeeta Desai come amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di TELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SALVO, Joseph Pasqualino
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Segretario
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Other135617080001
    TUNG, Sukhjiwan Kaur
    Vanwall Business Group
    Vanwall Road
    SL6 4UB Maidenhead
    Mattel House
    Berkshire
    Segretario
    Vanwall Business Group
    Vanwall Road
    SL6 4UB Maidenhead
    Mattel House
    Berkshire
    British167011710001
    ALLMARK, David
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Amministratore
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    United StatesBritish166738850001
    CATCHPOLE, Edward Laurence
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Amministratore
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    United KingdomBritish166738690001
    THIEME, Christian
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Amministratore
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    EnglandGerman167467740002
    BYRNE, Katharine Helen
    The Old Coach House
    Stockbridge Road
    SO51 0NE Timsbury
    Romsey
    Segretario
    The Old Coach House
    Stockbridge Road
    SO51 0NE Timsbury
    Romsey
    British76551670002
    BYRNE, Katharine Helen
    The Old Coach House
    Stockbridge Road
    SO51 0NE Timsbury
    Romsey
    Segretario
    The Old Coach House
    Stockbridge Road
    SO51 0NE Timsbury
    Romsey
    British76551670002
    HILTON, Timothy James
    6 Ashton Cross
    East Wellow
    SO51 6AY Romsey
    Hampshire
    Segretario
    6 Ashton Cross
    East Wellow
    SO51 6AY Romsey
    Hampshire
    British45519470002
    PEARCE, Simon Marshall
    5 Oaklands Avenue
    KT10 8HX Esher
    Surrey
    Segretario
    5 Oaklands Avenue
    KT10 8HX Esher
    Surrey
    British38325900002
    ROWLAND, Janet Lesley
    2 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    Segretario
    2 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    British83715050001
    URIE, Suzanne
    Woodlands
    Ulcombe Road Langley
    ME17 3JE Maidstone
    Kent
    Segretario
    Woodlands
    Ulcombe Road Langley
    ME17 3JE Maidstone
    Kent
    British30145210002
    P S SECRETARIES LIMITED
    Suite One Second Floor
    1/4 Christina Street
    EC2A 4PA London
    Segretario nominato
    Suite One Second Floor
    1/4 Christina Street
    EC2A 4PA London
    900001620001
    BIRRELL, Nigel Norman
    40 St John's Park
    Blackheath
    SE3 7JH London
    Amministratore
    40 St John's Park
    Blackheath
    SE3 7JH London
    British72014940002
    CAMINADA, Charles Jerome
    56 Lamont Road
    SW10 0HX London
    Amministratore
    56 Lamont Road
    SW10 0HX London
    EnglandBritish114598050001
    DESAI, Sangeeta
    Maple House
    149 Tottenham Court Road
    W1T 7NF London
    Amministratore
    Maple House
    149 Tottenham Court Road
    W1T 7NF London
    United KingdomBritish80563180001
    DUNN, Jeffrey Doubleday
    Maple House
    149 Tottenham Court Road
    W1T 7NF London
    Amministratore
    Maple House
    149 Tottenham Court Road
    W1T 7NF London
    United StatesAmerican129211540001
    FALZON, Charles John
    R R 21
    Acton
    L7J 2L8 Ontario
    Canada
    Amministratore
    R R 21
    Acton
    L7J 2L8 Ontario
    Canada
    Canadian54681970001
    HARRIS, William Stuart
    Ash Lea Dixons Lane
    Broughton
    SO20 8AT Stockbridge
    Hampshire
    Amministratore
    Ash Lea Dixons Lane
    Broughton
    SO20 8AT Stockbridge
    Hampshire
    United KingdomBritish1444030002
    HILTON, Timothy James
    6 Ashton Cross
    East Wellow
    SO51 6AY Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    6 Ashton Cross
    East Wellow
    SO51 6AY Romsey
    Hampshire
    British45519470002
    LAWES, Robert Ian
    9 Finlay Street
    SW6 6HE London
    Amministratore
    9 Finlay Street
    SW6 6HE London
    British24399410004
    PEARCE, David
    9 Saint Albans Avenue
    W4 5LL London
    Amministratore
    9 Saint Albans Avenue
    W4 5LL London
    EnglandBritish89691560001
    RICKETTS, Timothy Walker
    49 Lakewood Road
    SO53 1EU Chandlers Ford
    Hampshire
    Amministratore
    49 Lakewood Road
    SO53 1EU Chandlers Ford
    Hampshire
    EnglandBritish119035710001
    STEINBERG, Bruce David
    58 Frognal
    NW3 6XG London
    Amministratore
    58 Frognal
    NW3 6XG London
    United KingdomAmerican107396950001
    SULLIVAN, Sean Stephen
    Maple House
    149 Tottenham Court Road
    W1T 7NF London
    Amministratore
    Maple House
    149 Tottenham Court Road
    W1T 7NF London
    United StatesAmerican135856320001
    URIE, Peter
    Woodlands
    Ulcombe Road, Langley
    ME17 3JE Maidstone
    Kent
    Amministratore
    Woodlands
    Ulcombe Road, Langley
    ME17 3JE Maidstone
    Kent
    British66697340001
    WALKER, Geoffrey Hulbert
    Vanwall Business Park
    Vanwall Road
    SL6 4UB Maidenhead
    Mattel House
    Berkshire
    Amministratore
    Vanwall Business Park
    Vanwall Road
    SL6 4UB Maidenhead
    Mattel House
    Berkshire
    United KingdomAmerican158295080001
    WEIGHT, James Dominic
    11 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    Amministratore
    11 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    EnglandBritish73750450005
    P S NOMINEES LIMITED
    Suite One Second Floor
    1/4 Christina Street
    EC2A 4PA London
    Amministratore delegato nominato
    Suite One Second Floor
    1/4 Christina Street
    EC2A 4PA London
    900001610001

    TELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second lien accession deed supplemental to the second lien debenture dated 23 november 2010 and
    Creato il 23 nov 2010
    Consegnato il 10 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cantor Fitzgerald Securities
    Transazioni
    • 10 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security accession deed
    Creato il 23 nov 2010
    Consegnato il 03 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the administrative agent and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All material property,fixed charge investments,book debts,intellectual property,bank balances see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Merrill Lynch Capital Corporation
    Transazioni
    • 03 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 27 lug 2001
    Consegnato il 14 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations due or to become due from the company to the chargee as trustee for the secured parties (as defined) on the terms and conditions set out in the facility agreement (the "security trustee") or any of the other secured parties under or pursuant to the finance documents (as defined) (including the debenture) including any liability in respect of further advances made under the finance documents and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 mag 2000
    Consegnato il 31 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TELEVISION SUPPORT SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 dic 2012Inizio della liquidazione
    18 apr 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0