NOBLEREVEL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | NOBLEREVEL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02743181 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NOBLEREVEL LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova NOBLEREVEL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di NOBLEREVEL LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per NOBLEREVEL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione | 6 pagine | 1.4 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 17 ago 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore | 4 pagine | 1.1 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2010 | 18 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 7 pagine | MG01 | ||||||||||
Nomina di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di William Mcleish come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 gen 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 27 set 2009 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Smith come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di NOBLEREVEL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| COPELAND, Robert Nigel | Segretario | Cherry Tree Cottage Hearns Lane Gallows Tree Common RG4 9DE Reading Berkshire | British | 5690880001 | ||||||
| FEENEY, Martin | Segretario | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | British | 53915080001 | ||||||
| FORD, Colin Andrew | Segretario | 12 Willow Drive Milton Of Campsie G66 8DY Glasgow Lanarkshire | British | 70144650001 | ||||||
| HURRELL, Steven Alfred | Segretario | 8 Hamilton Crescent Bearsden G61 3JP Glasgow Strathclyde | British | 82311390001 | ||||||
| KIME, Sean Thomas | Segretario | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
| MACFARLANE, Rona Jane | Segretario | 2/2 5 Doune Quadrant G20 6DL Glasgow | British | 62509960001 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Segretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158305360001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Segretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
| MURPHY, Charles Furber | Segretario | 8 Tidwells Lea Warfield RG42 3TP Bracknell Berkshire | British | 69603410001 | ||||||
| MURRAY, Karen Mary | Segretario | Willerton Trumpsgreen Road GU25 4HH Virginia Water Surrey | British | 27248850001 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Segretario | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ABLETT, Julie | Amministratore | 166 Rutland Road West Bridgford NG2 5DZ Nottingham | British | 57906600001 | ||||||
| BARLOW, George Edward | Amministratore | 41 Nidd Approach LS22 7UJ Wetherby West Yorkshire | England | British | 66559170001 | |||||
| BOLOT, Timothy James | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BRADEEN, Chester Howard | Amministratore | Barberry Cottage Cheapside Road SL5 7QR Ascot Berkshire | Us Citizen | 44958580001 | ||||||
| BUCHAN, William James | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 79917240001 | |||||
| COLVIN, William | Amministratore | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| COPELAND, Robert Nigel | Amministratore | Cherry Tree Cottage Hearns Lane Gallows Tree Common RG4 9DE Reading Berkshire | United Kingdom | British | 5690880001 | |||||
| FARRALL, Elaine Ann | Amministratore | Manton Lodge Clumber Park S80 3AX Worksop Nottinghamshire | British | 14241020001 | ||||||
| FEENEY, Martin | Amministratore | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | Scotland | British | 53915080001 | |||||
| FLAHERTY, James Paul | Amministratore | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | 100530310001 | ||||||
| FOULKES, Kamma | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| GOSLING, Mark David | Amministratore | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | 66801660002 | ||||||
| HAMILTON, Thomas Banks | Amministratore | 29 Montrose Avenue G52 4LA Hillington Park Glasgow | British | 79846610001 | ||||||
| JAP, Chee Miau | Amministratore | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | 101200680001 | |||||
| LAWRENCE, Stephen John | Amministratore | The Old Barn Littleton SO22 6QS Winchester Hants | England | British | 5579020001 | |||||
| LOCK, Jason David | Amministratore | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| MARK, Larry Edward | Amministratore | 29 Cedar Drive SL5 0UA Sunningdale Berkshire | New Zealander | 5076900001 | ||||||
| MCINTEER, Warren Hill | Amministratore | 11 Thorn Road Bearsden G61 4PP Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 100131200001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 110640170001 | |||||
| MORETON, John Ernest | Amministratore | The Old Farm Winkfield Row RG12 6NG Reading Berkshire | New Zealander | 80392940001 | ||||||
| MOSS, John Rhys | Amministratore | Bryn Y Gwynt Graigfechan LL15 2EY Ruthin Clwyd | British | 36148600001 | ||||||
| MURPHY, Charles Furber | Amministratore | 8 Tidwells Lea Warfield RG42 3TP Bracknell Berkshire | British | 69603410001 |
NOBLEREVEL LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental legal mortgage | Creato il 06 mag 2011 Consegnato il 20 mag 2011 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Land on the north side of bury new road heywood t/no GM608227 see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession and charge | Creato il 21 ago 2008 Consegnato il 02 set 2008 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 26 mag 2000 Consegnato il 15 giu 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or owing by the UK guarantor to the ("chargees") or any ofthem under or in connection with guaranty agreement on any account whatsoever (as defined therein) and all liabilities whether actual or contingent at any time incurred by the company to the chargees under the amended and restated participation agreement (as defined therein) and/or any deed or document executed by the company pursuant thereto | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture deed | Creato il 10 feb 1997 Consegnato il 12 feb 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage deed | Creato il 17 dic 1996 Consegnato il 19 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold property known as bullace row camberwell southwark london; sgl 502718; all fixtures/fittings,fixed plant,machinery,book/other debts,licences,goodwill of business and all guarantees or covenants; see form 395. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage deed | Creato il 17 dic 1996 Consegnato il 19 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold property known as 10 brook rd,south benfleet castle point essex with all buildings,fixtures/fittings,plant and machinery thereon; ex 85951; all book/other debts,licences,goodwill of business and all guarantees or covenants; see form 395. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 01 ago 1995 Consegnato il 04 ago 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/as wellgate nursing home, wellgate, rotherham, S. yorkshire t/nos SYK316915 and SYK344344 the goodwill of the business the benefit of all guarantees and covenants. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Single debenture | Creato il 22 feb 1994 Consegnato il 28 feb 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattel mortgage | Creato il 28 mag 1993 Consegnato il 10 giu 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The loose fittings and furnishings at garden lodge nursing home middlemass hey netherley merseyside. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattel mortgage | Creato il 28 mag 1993 Consegnato il 10 giu 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The loose fittings and furniture at maple lodge nursing home arncliffe road halewood liverpool. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 28 mag 1993 Consegnato il 10 giu 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H maple lodge nursing home arncliffe road liverpool merseyside and gardenlodge nursing home and land adjoining at middlemass hey netherley merseyside and land adjoining maple lodge nursing home aforesaid. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
NOBLEREVEL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA) |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0