MEARS HOMECARE LIMITED

MEARS HOMECARE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMEARS HOMECARE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02744787
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MEARS HOMECARE LIMITED?

    • Attività delle agenzie di lavoro interinale (78200) / Attività amministrative e di supporto
    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova MEARS HOMECARE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1390 Montpellier Court, Gloucester Business Park
    Brockworth
    GL3 4AH Gloucester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MEARS HOMECARE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CARE UK HOMECARE LIMITED11 ott 200111 ott 2001
    HOMECARING LIMITED15 apr 199315 apr 1993
    FIT BITZ LIMITED03 set 199203 set 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di MEARS HOMECARE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per MEARS HOMECARE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2022

    14 pagineAA

    legacy

    167 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 lug 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Stato del capitale al 03 apr 2023

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c and capital redemption reserve 27/03/2023
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2021

    14 pagineAA

    legacy

    171 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 lug 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    22 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Mears Care (Holdings) Limited come persona con controllo significativo il 01 lug 2021

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2019

    26 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    25 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di MEARS HOMECARE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WESTRAN, Ben Robert
    Montpellier Court, Gloucester Business Park
    Brockworth
    GL3 4AH Gloucester
    1390
    Segretario
    Montpellier Court, Gloucester Business Park
    Brockworth
    GL3 4AH Gloucester
    1390
    198336280001
    SMITH, Andrew Christopher Melville
    Montpellier Court, Gloucester Business Park
    Brockworth
    GL3 4AH Gloucester
    1390
    England
    Amministratore
    Montpellier Court, Gloucester Business Park
    Brockworth
    GL3 4AH Gloucester
    1390
    England
    EnglandBritish121328600001
    MEARS GROUP PLC
    Montpellier Court, Gloucester Business Park
    Brockworth
    GL3 4AH Gloucester
    1390
    England
    Amministratore
    Montpellier Court, Gloucester Business Park
    Brockworth
    GL3 4AH Gloucester
    1390
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione03232863
    149799340001
    BISHOP, Bryon
    Great Woodley Farm House
    Woodley Lane
    SO51 7PE Romsey
    Hampshire
    Segretario
    Great Woodley Farm House
    Woodley Lane
    SO51 7PE Romsey
    Hampshire
    British22786840001
    BOOKER, Roger Ian
    4 Southgate Gardens
    Long Melford
    CO10 9HB Sudbury
    Suffolk
    Segretario
    4 Southgate Gardens
    Long Melford
    CO10 9HB Sudbury
    Suffolk
    British14044530002
    CALOW, Jonathan David
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Segretario
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    165449440001
    GRIFFITHS, Freda Margaret
    2 Hiltingbury Road
    SO53 5SW Eastleigh
    Hampshire
    Segretario
    2 Hiltingbury Road
    SO53 5SW Eastleigh
    Hampshire
    British30316030001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    Segretario
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    British33223550003
    CARE UK SERVICES LTD
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2482660
    125241530002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BENN, Geoffrey Richard
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    EnglandBritish73786580001
    BISHOP, Bryon
    Great Woodley Farm House
    Woodley Lane
    SO51 7PE Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    Great Woodley Farm House
    Woodley Lane
    SO51 7PE Romsey
    Hampshire
    United KingdomBritish22786840001
    BOOKER, Roger Ian
    Fairview
    17a Queens Road
    WA15 9HF Hale
    Cheshire
    Amministratore
    Fairview
    17a Queens Road
    WA15 9HF Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish14044530003
    BOOKER, Roger Ian
    4 Southgate Gardens
    Long Melford
    CO10 9HB Sudbury
    Suffolk
    Amministratore
    4 Southgate Gardens
    Long Melford
    CO10 9HB Sudbury
    Suffolk
    British14044530002
    BRYANT, James Richard Stansfeld
    Drapers Farmhouse
    Rushden
    SG9 0TB Buntingford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Drapers Farmhouse
    Rushden
    SG9 0TB Buntingford
    Hertfordshire
    EnglandBritish7897550001
    CLOUGH, Richard Stanley
    Hanini 50 Second Avenue
    CO13 9LX Frinton On Sea
    Essex
    Amministratore
    Hanini 50 Second Avenue
    CO13 9LX Frinton On Sea
    Essex
    EnglandBritish7897560001
    CULHANE, Angela
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    EnglandBritish68602910001
    GRIFFITHS, Freda Margaret
    2 Hiltingbury Road
    SO53 5SW Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    2 Hiltingbury Road
    SO53 5SW Eastleigh
    Hampshire
    British30316030001
    HASTINGS, Roy
    Wallis Road
    RG21 3DN Basingstoke
    20
    Hampshire
    Amministratore
    Wallis Road
    RG21 3DN Basingstoke
    20
    Hampshire
    United KingdomBritish130098430001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    United KingdomBritish33223550003
    MARRIOTT-LAVERY, Deborah Jane
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    United KingdomBritish151689670002
    PAGE, Jacalyn Frances
    15 Chessel Crescent
    Bitterne
    SO19 4BR Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    15 Chessel Crescent
    Bitterne
    SO19 4BR Southampton
    Hampshire
    British30316040001
    PARISH, Michael Robert
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    EnglandBritish78828750003
    QUINN, David Laurence, Mr.
    6 Whitecross Road
    HP17 8BA Haddenham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    6 Whitecross Road
    HP17 8BA Haddenham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish123356660001
    RUSSELL, Andrew Philip Thomas
    37 Woodley Lane
    SO51 7JL Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    37 Woodley Lane
    SO51 7JL Romsey
    Hampshire
    EnglandBritish23099130001
    RUSSELL, Vivienne Patricia
    37 Woodley Lane
    SO51 7JL Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    37 Woodley Lane
    SO51 7JL Romsey
    Hampshire
    EnglandBritish33748240001
    SCOTT, Christine Jennifer
    166 Bucklesham Road
    Purdis Farm
    IP3 8SW Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    166 Bucklesham Road
    Purdis Farm
    IP3 8SW Ipswich
    Suffolk
    British24581020002
    UMBERS, Douglas
    SO53
    Amministratore
    SO53
    United KingdomBritish90541690001
    VOCKINS, Anthony Frederick
    4 Main Street
    Croxton Kerrial
    NG32 1QF Grantham
    The Old Post Office
    Lincolnshire
    Amministratore
    4 Main Street
    Croxton Kerrial
    NG32 1QF Grantham
    The Old Post Office
    Lincolnshire
    EnglandBritish130512090002
    WATSON, Paul John
    Montpellier Court, Gloucester Business Park
    Brockworth
    GL3 4AH Gloucester
    1390
    England
    Amministratore
    Montpellier Court, Gloucester Business Park
    Brockworth
    GL3 4AH Gloucester
    1390
    England
    United KingdomBritish82460360003
    WEEKS, Catherine Jane
    8 Chancellery Mews
    Risbygate Street
    IP33 3AB Bury St. Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    8 Chancellery Mews
    Risbygate Street
    IP33 3AB Bury St. Edmunds
    Suffolk
    British72222500003
    WHITECROSS, Philip James
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    EnglandBritish193730760001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MEARS HOMECARE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Gloucester Business Park
    GL3 4AH Brockworth
    1390 Montpellier Court
    Gloucester
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Gloucester Business Park
    GL3 4AH Brockworth
    1390 Montpellier Court
    Gloucester
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03689426
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) detengono, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    MEARS HOMECARE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 22 feb 2018
    Consegnato il 22 feb 2018
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 22 feb 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 17 mag 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 26 set 2014
    Consegnato il 30 set 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The company charged by way of first fixed charge all its intellectual property (although no further details are specified in the charge for intellectual property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(b)(vii) of the charge.. The company listed above charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V., London Branch
    Transazioni
    • 30 set 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 22 dic 2011
    Consegnato il 05 gen 2012
    In corso
    Importo garantito
    £3,671.88 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Its interest in the deposit account see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Newmarket General Partner Limited and Newmarket Nominee Limited
    Transazioni
    • 05 gen 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 21 lug 2010
    Consegnato il 26 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank Nv, London Branch (As Security Agent)
    Transazioni
    • 26 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 12 feb 2009
    Consegnato il 14 feb 2009
    In corso
    Importo garantito
    £3,671.88 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    With full title guarantee by way of fixed charge charges its interest in the deposit and all money from time to time withdrawn from the deposit in accordance with the rent deposit deed.
    Persone aventi diritto
    • Active Retail Rookery Fund (General Partner) Limited
    Transazioni
    • 14 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 10 gen 2006
    Consegnato il 12 gen 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £3,671.88 held in a deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Active Retail Rookery Fund (General Partner) Limited
    Transazioni
    • 12 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 21 gen 2005
    Consegnato il 26 gen 2005
    In corso
    Importo garantito
    £4,406.25 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The interest and all sums from time to time in a deposit account with the hsbc bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • Daniela Julia Michal Rose Maier
    Transazioni
    • 26 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 02 lug 2004
    Consegnato il 17 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £8,250.00.
    Persone aventi diritto
    • James Godfrey Blenkin and Bronwen Mary Blenkin
    Transazioni
    • 17 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 30 mar 2000
    Consegnato il 11 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company to any beneficiary under or pursuant to the terms of any of the finance documents, the loan facility or other financial accommodation and under the terms of the charge (all defined therein)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland("the Security Trustee")
    Transazioni
    • 11 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 mar 2000
    Consegnato il 10 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 21 gen 1999
    Consegnato il 01 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 20 lug 1995
    Consegnato il 26 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0