KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED

KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02745667
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED?

    • Istruzione prescolare (85100) / Istruzione
    • Attività di asili nido (88910) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    Northamptonshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KINDERCARE LEARNING CENTRES LIMITED28 ott 199228 ott 1992
    KINDERCARE LEARNING CENTERS LIMITED02 set 199202 set 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 26 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 gen 2016

    Stato del capitale al 26 gen 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 03 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 dic 2015

    Stato del capitale al 18 dic 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 18 nov 2015

    • Capitale: GBP 100
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account be cancelled 03/11/2015
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 12 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 set 2015

    Stato del capitale al 02 set 2015

    • Capitale: GBP 50,001
    SH01

    Cessazione della carica di Mary Ann Tocio come amministratore in data 01 giu 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    9 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 ago 2014

    Stato del capitale al 28 ago 2014

    • Capitale: GBP 50,001
    SH01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 10 apr 2014 al 31 dic 2013

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 10 apr 2013

    32 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 set 2013

    Stato del capitale al 09 set 2013

    • Capitale: GBP 50,001
    SH01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 apr 2013 al 10 apr 2013

    1 pagineAA01

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di Mr Stephen Dreier come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mary Ann Tocio come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Elizabeth Boland come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr David Lissy come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Stephen Kramer come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Claire Chadwick come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KRAMER, Stephen
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Segretario
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    177503500001
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    United StatesAmerican70853820001
    DREIER, Stephen
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    United StatesAmerican170443250001
    LISSY, Dave
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    United StatesAmerican218331690001
    ARNOLD, Shane
    34 Highclove Lane
    M28 1GZ Worsley
    Lancashire
    Segretario
    34 Highclove Lane
    M28 1GZ Worsley
    Lancashire
    British106525210001
    BRYAN, Rebecca Shows
    3615 Hillview Close
    36106 Montgomery
    Alabama
    Usa
    Segretario
    3615 Hillview Close
    36106 Montgomery
    Alabama
    Usa
    American40945390002
    CHADWICK, Claire Marie
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Segretario
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    168032460001
    CHALMERS MORRIS, Stephen Geoffrey
    55 Barcheston Road
    SK8 1LJ Cheadle
    Cheshire
    Segretario
    55 Barcheston Road
    SK8 1LJ Cheadle
    Cheshire
    British58641010002
    COONER, Angela Denise Long
    8140 Westlakes Place
    Montgomery Alabama 36117
    FOREIGN United States Of America
    Segretario
    8140 Westlakes Place
    Montgomery Alabama 36117
    FOREIGN United States Of America
    American50788430001
    DE TENLEY, Elizabeth Carolyn
    16 Blencowe Close
    OX6 9UL Bicester
    Oxfordshire
    Segretario
    16 Blencowe Close
    OX6 9UL Bicester
    Oxfordshire
    American54873780001
    HARNETT, Charlotte Emma Claire
    7 Calves Close
    Shenley Brook End
    MK5 7HF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    7 Calves Close
    Shenley Brook End
    MK5 7HF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British75093380001
    HUNTER, Amanda
    8 White Horse Yard
    NN12 6BX Towcester
    Northamptonshire
    Segretario
    8 White Horse Yard
    NN12 6BX Towcester
    Northamptonshire
    British84060330002
    KRIPALANI, Eva M
    3825 Sw Corbett
    97201 Portland
    Oregon
    Usa
    Segretario
    3825 Sw Corbett
    97201 Portland
    Oregon
    Usa
    Us Citizen55720080001
    MARSHALL, Rosamund Margaret
    Kidsunlimited
    Summerfields Village Centre
    SK9 2TA Dean Row Road, Wilmslow
    Cheshire
    Segretario
    Kidsunlimited
    Summerfields Village Centre
    SK9 2TA Dean Row Road, Wilmslow
    Cheshire
    British157022120001
    OTT, Keith Terry
    50 Gayton Road
    Hampstead
    NW3 1TU London
    Segretario
    50 Gayton Road
    Hampstead
    NW3 1TU London
    British35285110001
    PARNALL, Janet Lorraine
    4 Damson Close
    Walkwood
    B97 5WA Redditch
    Worcestershire
    Segretario
    4 Damson Close
    Walkwood
    B97 5WA Redditch
    Worcestershire
    British72392950001
    PEARSON, James Lee
    Rookery Cottages Chester Road
    Hartford
    CW8 1LL Northwich
    4
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Rookery Cottages Chester Road
    Hartford
    CW8 1LL Northwich
    4
    Cheshire
    United Kingdom
    British185162450001
    THOMPSON, Paul Simon
    Kidsunlimited
    Summerfields Village Centre
    SK9 2TA Dean Row Road, Wilmslow
    Cheshire
    Segretario
    Kidsunlimited
    Summerfields Village Centre
    SK9 2TA Dean Row Road, Wilmslow
    Cheshire
    British149567830001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BACH, Karen
    Kent Street
    RH13 8BE Cowfold
    Potts Cottage
    W Sussex
    Uk
    Amministratore
    Kent Street
    RH13 8BE Cowfold
    Potts Cottage
    W Sussex
    Uk
    United KingdomBritish160940730001
    BAILEY, William Esby
    3143 Lexington Road
    Montgomery Alabama 36106
    FOREIGN Usa
    Amministratore
    3143 Lexington Road
    Montgomery Alabama 36106
    FOREIGN Usa
    American36131440001
    BRYAN, Rebecca Shows
    3615 Hillview Close
    36106 Montgomery
    Alabama
    Usa
    Amministratore
    3615 Hillview Close
    36106 Montgomery
    Alabama
    Usa
    American40945390002
    CHALMERS MORRIS, Stephen Geoffrey
    55 Barcheston Road
    SK8 1LJ Cheadle
    Cheshire
    Amministratore
    55 Barcheston Road
    SK8 1LJ Cheadle
    Cheshire
    British58641010002
    CLARK, Jeremy
    Willington Road
    Willington
    CW6 0ND Tarporley
    3 Oak Bank
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Willington Road
    Willington
    CW6 0ND Tarporley
    3 Oak Bank
    Cheshire
    England
    EnglandBritish153453360001
    DE TENLEY, Elizabeth Carolyn
    16 Blencowe Close
    OX6 9UL Bicester
    Oxfordshire
    Amministratore
    16 Blencowe Close
    OX6 9UL Bicester
    Oxfordshire
    American54873780001
    GEARREALD JR, Tull Neal
    6025 Greystone Place
    36117 Montgomery
    Alabama
    United States Of America
    Amministratore
    6025 Greystone Place
    36117 Montgomery
    Alabama
    United States Of America
    American40328290001
    HARNETT, Charlotte Emma Claire
    7 Calves Close
    Shenley Brook End
    MK5 7HF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    7 Calves Close
    Shenley Brook End
    MK5 7HF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British75093380001
    HIOTT, David Leeds
    7060 Knoll Loop Drive
    36116 Montgomery
    Alabama
    United States Of America
    Amministratore
    7060 Knoll Loop Drive
    36116 Montgomery
    Alabama
    United States Of America
    American40328180001
    HOFFMANN, Mark Francis
    310 Boardwalk Place
    Park Ridge Illinois 60068
    FOREIGN United States Of America
    Amministratore
    310 Boardwalk Place
    Park Ridge Illinois 60068
    FOREIGN United States Of America
    American50788350001
    HOLLOWAY, Adam Stuart
    Flat 1 231-5 Liverpool Road
    Islington
    N1 1LX London
    Amministratore
    Flat 1 231-5 Liverpool Road
    Islington
    N1 1LX London
    United KingdomBritish80088960001
    HOUGHTON, Catherine Laura Jane
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish140056480001
    HUTCHINSON, Samuel Wray
    4235 Horton Road
    97068 West Linn
    Oregon
    Usa
    Amministratore
    4235 Horton Road
    97068 West Linn
    Oregon
    Usa
    Us Citizen55720030002
    JOHNSON, David Jordan
    12621 Sw Edgecliff Road
    Portland Oregon
    FOREIGN Usa
    Amministratore
    12621 Sw Edgecliff Road
    Portland Oregon
    FOREIGN Usa
    American54620270001
    KECK, Richard Paul
    69 Tranquil Vale
    Blackheath
    SE3 0BP London
    Amministratore
    69 Tranquil Vale
    Blackheath
    SE3 0BP London
    Us Citizen41822340002
    KEDWARDS, David Charles
    Flat 13 Eaton Mews
    North Thirteenth Street
    MK9 3NR Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Flat 13 Eaton Mews
    North Thirteenth Street
    MK9 3NR Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British67925060001

    KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Group debenture
    Creato il 04 apr 2008
    Consegnato il 12 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent (Security Agent)
    Transazioni
    • 12 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 15 nov 2007
    Consegnato il 21 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 21 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 apr 2004
    Consegnato il 13 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as kindercare learning centres limited to the charge on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Isis Equity Partners PLC
    Transazioni
    • 13 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 apr 2004
    Consegnato il 30 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property known as land on the south side of callands road warrington cheshire t/n CH381916. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 apr 2004
    Consegnato il 30 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property known as land on the south east side of quantock rise, t/n BD201472. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 apr 2004
    Consegnato il 30 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Stock pledge and security agreement
    Creato il 09 giu 1995
    Consegnato il 23 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The secured obligations (as defined therein) which are due or to become due from kindercare learning centers, inc. (The "borrower") to the chargee
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the stock held by the company being 1000 ordinary shares of £1 each in the capital of kindercare properties limited. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Toronto Dominion (Texas) Inc.as Agent for the Lenders and Facing Bank
    Transazioni
    • 23 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0